Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 27 avril 1974, Partie 1 samedi 27 (no 17)
[" i Jt bec A11E8 G3/ PTIE 1 EX.2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC PARTE 1 AVIS JURIDIQUES OFFICIAL GAZETTE PART 1 JURIDICAL NOTICES 27 AVRIL 1974 N° 17 3065 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1971, 106' année, n° 17 3067 PARTIE 1 AVIS AUX ANNONCEURS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Édi teur officiel du Québec, Québec, toute communication d'avis destinée à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazette officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et con tient des a vis généraux, proclamations, avis légaux divers et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard dans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Éditeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas.l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion : sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc., sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.8.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine; mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou r.nnonces, expire à midi, le mercredi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas, l'ultime délai expire àmidi, le mardi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou tout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce, afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.PART 1 NOTICE TO READERS 1.Address all communications to the Quebec Official Gazette, c/o The Québec Official Publisher, Québec.2.The Quebec Official Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains notices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Quebec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Wednesday noon; if Wednesday is a holiday, the deadline is Tuesday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec, CHARLES-HENRI DUBÉ.Québec Official Publisher 3068 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction : S5 des 100 mots.Exemplaire séparé: -SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, S20; du 1er avril au 31 décembre, S15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazette pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Editeur officiel du Québec, Charles-Henri Dubé.Cité Parlementaire, Québec, 25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: $3 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, 820, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, S10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings, Québec, October 25, 1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazette officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec G1A 1G7, P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Quebec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1A 1G7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3069 AVIS JURIDIQUES JURIDICAL NOTICES Vente pour taxes Sale for taxes Ville de St-Hubert Avis est par la présente donné, que le Conseil par une résolution en date du 18 mars 1974, a ordonné au soussigné, conformément à la Loi des cités et villes et de dispositions spéciales, de vendre les immeubles ci-dessous désignés pour satisfaire au paiement des arrérages de taxes dues à la Ville de Saint-Hubert, avec intérêts et frais et qu'en conséquence, lesdits immeubles seront vendus par encan public dans la salle de l'édifice municipal situé à 3350 Grande Allée, le VINGT-HUITIÈME jour «le MAI 1974, à DIX heures de l'avant-midi.Toutefois, seront exclus de la vente, les immeubles sur lesquels les taxes municipales, tant générales que spéciales de l'année 1973 et des années antérieures auront été payées avant le moment de la vente.City of St.Hubert Notice is hereby given that, by a resolution dated March 18, 1974, the Council has ordered the undersigned, in conformity with the Cities and Towns Ac-and with special provisions, to sell the immoveables hereinafter described in order to satisfy the payment of the tax arrears owed to the City of St.Hubert, together with interest and costs, and consequently, the said immoveables will be sold by public auction in the Main Hall of the Municipal Building located at 3350 Grande Allée, on the TWENTY-EIGHTH day of MAY, 1974, at TEN o'clock in the forenoon.Those immoveables on which the municipal taxes, both general and special, for the year 1973 and for earlier years, have been paid before the date of the sale will, however, be excluded from the sale.\tADDENDA \u2014 ADDENDA Immeubles sujets au droit de rertail / Immoveables\tsubject to the withdrawal \tNom\tDescription de l'immeuble Folio\t\t \tName\tDescription of immoveable 0392370.Spathodia Land Corp.Une partie du lot 98 contenant une superficie de 25,000 pieds carrés, bornée par les lots 98-83 (rue), 9S-5, 98-4, 98-3, partie du lot 98-2, par le Chemin Chambly et par le lot 98-1.A part of lot 98 covering an area of 25,000 square feet, bounded by lots 98-83 (street ).98-5, 98-4,98-3, part of lot 98-2, by the Chambly Road and by lot 98-1.0417050-2.Dame Antonine Gervais épouse Médéric Gervais.0574350-5.0578190-1.Oakwood Valley Holdings Limited.Un emplacement composé: a) D'une partie du lot 143 mesurant 188.97 pieds dans sa ligne nord-est, 216.15 pieds dans sa ligne sud-est, 187.4 pieds dans sa ligne sud-ouest, 216.76 pieds dans sa ligne nord-ouest, bornée au nord-est par le Boulevard Cousineau (143-197), au sud-est par le lot 143-467, au sud-ouest par la rue Pasteur (143-66) et au nord-ouest par la partie ci-après décrite du lot 145: 6) D'une partie du lot 145 mesurant 216.76 pieds dans sa ligne sud-est, 522.6 pieds dans sa ligne sud-ouest, 56.88 pieds dans une autre ligne sud-ouest, 225.22 pieds dans sa ligne nord-ouest, 100 pieds dans sa ligne nord, 395.17 pieds et 154.51 pieds dans sa ligne nord-est, bornée au sud-est par la partie ci-dessus décrite du lot 143, au sud-ouest par la rue Pasteur (145-59 et 145-60), au nord-ouest par une partie du lot 147-40, au nord par le Boulevard Gareau (145-150) et au nord-est par le boulevard Cousineau (145-150).0587496-1.Les Placements Thibault Limitée.Une partie du lot 155 contenant une superficie de 143,394 pieds carrés, bornée par les lots 155-1110, 1113, 1114, 1116, 1117 et par une partie des lots 155-1115 et 1118.0604950-fi.Jolisse Development Ltd.Une partie du lot 223 paroisse St-Antoine-de-Longueuil, contenant une superficie de 107,712.50 pieds carrés, bornée par 102-307 à/to 309 An emplacement comprising: (a) a part of lot 143 measuring 188.97 feet on its northeast line.216.15 on its southeast line, 187.4 feet on its southwest line, 216.76 feet on its northwest line, bounded on the northeast by Cousineau Boulevard (143-197), on the southeast by lot 143-467, on the southwest by Pasteur Street (143-66) and on the northwest by the part of lot 145 hereinafter described; (!>) a part of lot 145, measuring 216.76 feet on its southeast line, 522.6 feet on its southwest line, 56.88 feet on another southwest line, 225.22 feet on its northwest line, 100 feet on its north line, 395.17 feet and 154.51 feet on its northeast line, hounded on the southeast by the part of lot 143 hereinabove described, on the southwest by Pasteur Street (145-59 and 145-60), on the northwest by a part of lot 147-40, on the north by Gareau Boulevard (145-150) and on the northeast by Cousineau Boulevard (145-150).A part of lot 155 covering an area of 143,394 square feet, bounded by lots 155-1110, 1113, 1114, 1116, 1117 and by a part of lots 155-1115 and 1118.A part of lot 223.Parish of St.Antoine-de-Longueuil, covering an area of 107, 712.50 square feet, bounded by Payer - 3070 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable le boulevard Payer (223-284) et par partie du lot 224 originaire, ainsi que par les lots 223-97, 98, 99, 100, 101, 102, 103.104 et par une partie du lot 222-1 dudit cadastre.0604960-5.Boulevard (223-284) and by part of original lot 224 and also by lots 223-97, 98, 99.100, 101, 102, 103.104 and by a part of lot 222-1 of said cadastre.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Korman, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos, épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Une partie du lot 223 paroisse St-Antoine-de-Longueuil, contenant une superficie de 84,900 pieds carrés, bornée par les lots 223-128.129, 130, 131.132, 133.134.135.par une partie du lot 224 originaire, par te lot 223-284 boulevard Payer, et par une partie du lot 222-1 dudit cadastre.0940600-0.Hans Ehrensperger.Un emplacement composé d'une partie des lots 210 et 211 paroisse de St-Antoine de Longueuil, borné par les lots 210-1.211-1, 211-2, 212-1, 211-15, 211-14, 211-13.211-12, 211-11, 211-10, 211-9, 211-8, 211-7, 211-4, Grande Allée.211-6.211-16, Grande Allée, 209-132 à 168, 209-171, 209-278 à 307, 209-310, 209-770-5, 209-770-4, 209-185, partie du lot 209, 209-794, une partie du lot 209-723, les lots 209-921, 209-869, 209-875, 209-887.rue Montgomery.209-908, 209-761 et par une partie du lot 209-762.0095560-9.Les Développements Parc St^Laurent Inc.La partie nord-ouest des lots numéros 3 et 4, mesurant en tout 777.23 pieds dans sa ligne sud-est, 3,183.2 pieds dans sa ligne sud-ouest, 60.5 pieds dans sa ligne ouest, 735.2 pieds dans sa ligne nord-ouest et 3,448 pieds dans sa ligne nord-est, bornée au nord-ouest par la ligne limitative des terres de la Paroisse St-Antoine-de-Longueuil, du côté nord-est par partie du lot 2.du côté sud-ouest par partie du lot 5, et au sud-est par le résidu desdits lots 3 et 4.0095570-8.M.Rolland Gingras., Une partie du lot numéro 4 mesurant en front le long du A part of lot 223.Parish of St.Antoine-de-Longueml, covering an area of 84,900 square feet, bounded by lots 223-128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, by a part of original lot 224, by lot 223-284 Payer Boulevard, and by a part of lot 222-1 of said cadastre.An emplacement comprising part of lots 210 and 211, Parish of St.Antoine-de-Longueuil, bounded by lots 210-1.211-1, 211-2, 212-1, 211-15.211-14, 211-13, 211-12.211-11.211-10.211-9,211-8, 211-7, 211-4.Grande Allée, 211-6, 211-16, Grande Allée, 209-132 to 168, 209-171, 209-278 to 307.209-310.209-770-5, 309-770-4, 209-185.part of lot 209, 209-794.a part of lot 209-723, lots 209-921.209-869, 209-875.209-887, Mont-gomery Street, 209-908, 209-761 and by a part of lot 209-762.The northwest part of lots numbers 3 and 4, the whole measuring 777.23 feet on its southeast line, 3,183.2 feet on its southwest line, 60.5 feet on its west line, 735.2 feet on its northwest line and 3,448 feet on its northeast line, bounded on the northwest by the boundary line of the lands of the Parish of St.Antoine-de-Longueuil, on the northeast side, by a part of lot 2, on the southwest side, by part of lot 5 and on the southeast by the remainder of said lots 3 and 4.Chemin de la Savane 165.3 pieds, dans sa ligne sud-ouest 228 pieds, en arrière au nord-ouest 157.5 pieds et dans sa ligne nord-est 181.6 pieds, bornée au nord-est par partie du lot numéro 3, au sud-est par le Chemin de la Savane, au sud-ouest et au nord-ouest par d'autres parties dudit lot 4.0113400-6 0117600-7.Les Entreprises Agricoles St-Hubert Ltée À distraire cependant de ces lots les parties vendues aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 206588, 325296, 332642, 328000, 328002 et 346036.0119950-4.Dame Pierrette Albert, épouse de Jacques Un emplacement composé: a) de la partie sud-est du lot 8-486 mesurant 20 pieds de largeur sur une profondeur de 70 pieds, bornée en front au nord-est par la rue Viger, en arrière par le lot 9 ou ses subdivisions, du côté sud-est par le lot 8-487, et du côté nord-ouest par le résidu dudit lot 8-486; b) du lot 8-487; c) de la partie nord-ouest du lot 8-488, mesurant 20 pieds de largeur sur une profondeur de 70 pieds, bornée en front au nord-est par la rue Viger, en arrière par le lot 9 ou ses subdivisions, du côté nord-ouest par ledit lot 8-487 et de l'autre côté au sud-est par le résidu dudit lot 8-488.0120970-9.M.Yvon Girard.0136401-7.Les Entreprises Agricoles St-Hubert Ltée À distraire cependant de ce lot les parties vendues aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Ohamblv sous les numéros 67060, 80904, 81509, 99552, 217282 et 289244.A part of lot number 4, measuring in front along De la Savane Road, 165.3 feet, on its southwest line 228 feet, at rear, on the northwest 157.5 feet and on its northeast line 181.6, bounded on the northeast by a part of lot number 3, on the southeast by De la Savane Road, on the southwest and on the northwest by other parts of said lot 4.6 et/and 7 Less and to withdraw from these lots, the parts sold under the terms of deeds registered at the County of Chambly Registry Office under numbers 206588, 325296, 332642, 328000,328002 and 346036.Martin.An emplacement comprising: (a) the southeast part of lot 8-486, measuring 20 feet in width by a depth of 70 feet, bounded in front on the northeast by Viger Street, at rear by lot 9 or its subdivisions, on the southeast side by lot 8-487.and on the northwest side by the remainder of said lot 8-486; (fc) lot 8-487; (c) the northwest part of lot 8-488, measuring 20 feet in width by a depth of 70 feet, bounded in front, on the northeast, by Viger Street, at rear by lot 9 or its subdivisions, on the northwest side by said lot 8-487 and on the other side, on the southeast, by the remainder of said lot 8-488.8-674 a/to 677 10 Less and to withdraw from this lot the parts sold under the terms of deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 67060, 80904, 81509.99552, 217282 and 289244. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année.h° 17 3071 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0142730-1.Les Entreprises Agricoles St-Hubert Ltée.11 À distraire cependant de ce lot les parties vendues aux Less and withdraw from this lot the parts sold under the termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du terms of deeds registered at the County of Chambly Registry comté de Chambly sous les numéros 67231, 149151, 169160, Office under numbers 67231, 149151, 169160, 157043, 278557 157043, 278557 et 289330.and 289330.0150560-1.M.L.Michaud.et M.R.Maloney.0150750-8.M.Ogden T.Davis.0151570-9.M.Hubert Guertin, Dame Jeannine Guertin, épouse, Florian Benoit, Dame Léda Guertin, veuve Thomas Roberge, Paul Guertin, Dlle Bertha Guertin et Dame Germaine Guertin, épouse de M.Royal Caumartin.À distraire cependant de ce lot la partie expropriée par le ministère de la Voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sons le numéro 312753.23-618 a/to 622 23-655 et/and 656 23-805 Less and to withdraw from this lot, the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of a deed registered at the County of Chambly Registry Office under number 312753.M.Paul Therrien.M.Roger Fettu, et M.Yves Robail.M.Roger Fettu.M.Gérard Laplante.M.William F.Mantha.M.Pierre Léveillé.Dame Jeanne Choinière, épouse Césaire Viens.M.Hervé Giguère, Jr.Placements Dauverne Inc.0153080-7.0153670-5.0153680-4.0154660-5.0157730-3.0158360-8.0158400-2.0158420-0.0169200-3.Une partie du lot 41 mesurant 127 pieds en front et 128 pieds en arriève par une profondeur de 2248.2 pieds du côté est et 2168.3 pieds du côté ouest, bornée au nord par le boulevard Laurier, au sud par partie dudit lot 41, à l'est par partie dudit lot 41 appartenant :\\ Désiré Forro ou représentants, à l'ouest par une partie dudit lot 41 appartenant à Ludovic Fabian & uxor, ou représentants.0169600-4.Placements Dauverne Inc.Une partie du lot 41 mesurant 127 pieds en front et 128 pieds en arrière par une profondeur de 232S pieds du côté est et 2248.2 pieds du côte ouest, bornée au nord par le boulevard Laurier, au sud par partie du lot 41, à l'est par partie du lot 42, et à l'ouest par une autre partie dudit lot 41.0169900-8.M.Jimmy Tapp.Une partie du lot 41 mesurant 134.7 pieds de largeur dans sa ligne sud, à une distance de 263 pieds du côté nord du Chemin Chambly.127 pieds de largeur dans sa ligne nord, le long d,'une rue proposée, par une profondeur de 1717 pieds dans ses lignes est et ouest; la ligne ouest de cet emplacement est située à une distance de 50 pieds de la ligne est de la propriété de Roland Rocheleau (Ptie 41) ou représentants: cette partie est hornée en front au sud par une autre partie dudit lot 41 appartenant à M.Onésime Goulet ou représentants, en arrière au nord par une rue proposée, d'un côté à l'ouest par une autre rue proposée, et de l'autre côté à l'est par une autre partie dudit lot 41 appartenant à Bernard et René Rocheleau ou représentants.0171702-4.M.Guiseppe Cappadoro.Une partie du lot 41 mesurant 136 pieds de largeur en front et 134.7 pieds de largeur en arrière par une profondeur de 263 pieds, bornée en front au sud par le Chemin Chambly, au nord par une partie dudit lot 14 appartenant à Emery Ohukley ou représentants, à l'est par partie dudit lot 41, et à l'ouest par une autre partie dudit lot 41 (rue projetée).La ligne ouest de cet immeuble se trouve à 50 pieds du terrain appartenant à Roland Rocheleau, ou représentants.0175570-1.Placements Dauverne Inc.À distraire cependant de ce lot le lot 42-1 et les parties réservée et vendues aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 140539, 20648G et 225034.35-57 35-138 et/and 139 35-140 35-233 37-42 37-120 37-124 37-126 A part of lot 41, measuring 127 feet in front and 128 feet in rear by a depth of 2248.2 feet on the east side and 2168.3 feet on the west side, bounded on the north by Laurier Boulevard, on the south by a part of said lot 41, on the east by a part of said lot 41 belonging to Désiré Forio or representatives, on the west by a part of said lot 41 belonging to Ludovic Fabian & uxor, or representatives.A part of lot 41, measuring 127 feet in front and 128 feet in in rear by a depth of 2328 feet on the east side and 2248.2 feet feet on the west side, bounded on the north by Laurier Boulevard, on the south by a part of lot 41.on tne east by a p3rt of lot 42, and on the west by another part of lot 41.A part of lot 41, measuring 134.7 feet in width on its south line, at a distance of 263 feet from the north side of Chambly Road, 127 feet in width on its north line, along a proposed stieet, by a depth of 1717 feet on its east and west lines; the west line of this emplacement is located at a distance of 50 feet from the east line of the property of Roland Rocheleau (Pt.41) or representatives; this part is bounded in front, on the south, by another part of said lot 41 belonging to Mr.Onésime Goulet or representatives, in the rear, on the north, by a proposed street, on one side, on the west, by another proposed street, and on the other side, on the east, by another part of said lot 41 belonging to Bernard and René Rocheleau or representatives.A part of lot 41, measuring 136 feet in width in front and 134.7 feet in width in the rear by a depth of 263 feet, bounded in front, on the south, by the Chambly Road, on the north by a part of said lot 41 belonging to Emery Chukley or representatives, on the east by part of said lot 41, and on the west by another part of said lot 41 (proposed street).The west line of this immoveable is located at 50 feet from the piece of land belonging to Roland Rocheleau, or representatives.42 Less and to withdraw from this lot, lot 42-1 and tne parts reserved and sold under the terms of deeds registered at the County of Chambly Registrv- Office under numbers 110539, 2064S6 and 225034. 3072 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0178000-6.Placements Dauverne Inc.Une partie du lot 43, contenant 41.2 arpents et mesurant 4,025 pieds dans sa ligne nord-ouest, 390.5 pieds dans sa ligne sud-ouest.438 pieds dans sa ligne nord-est, et 3927 pieds dans sa ligne sud-est, bornée en front au sud-ouest par le Chemin Chambly, d'un côté au nord-ouest par le lot 42, en arrière au nord-est par partie du lot 22, et de l'autre côté au sud-est par le résidu dudit lot 43; la ligne sud-est de cet emplacement est située à 399 pieds (mesuré le long du chemin Chambly) de la ligne de division entre les lots 43 et 44 et est parallèle a cette dernière. distraire de cette partie une partie dudit lot 43 réservée par M.Bernard Gélineau aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 182034.0195660-6.M.Paul-Emile Martin.0195860-2.M.Franz Ithen.0196650-6.M.Franz Ithen.0197740-4.M.Appiar Kalouskian.La partie sud-ouest du lot 49-2 mesurant 90.1 pieds dans .sa ligne sud-est.65 pieds dans sa ligne nord-ouest sur une profondeur de 100 pieds dans ses lignes sud-ouest et nord-est, bornée au sud-ouest par le Chemin Chambly, au nord-ouest par le lot 49-3 (rue Proposée), au nord-est par le résidu dudit lot 49-2, et au sud-est par le lot 49-1.A part of lot 43, covering an area of 41.2 arpents and measuring 4,025 feet on its northwest line, 390.5 feet on its southwest line, 438 feet on its northeast line, and 3927 feet on its southeast line, bounded in front, on the southwest, by the Chambly Road, on one side, on the northwest, by lot 42, in rear, on the northeast, by a part of lot 22, and on the other side, on the southeast, by the remainder of said lot 43; the southeast line of this emplacement is located at 399 feet (measured along Chambly Road) from the dividing line between lots 43 and 44 and is parallel to the latter.Less and to withdraw from this part, a part of said lot 43 reserved by Mr.Bernard Gelineau under the terms of a deed registered at the County of Chambly Registered Office undei number 182034.47-1 48-16 et/and 49-229 48-83 The southwest part of lot 49-2, measuring 90.1 feet on its southeast line, 65 feet on its northwest line by a depth of 100 feet on its southwest and northeast lines, bounded on the southwest by Chambly Road, on the northwest by lot 49-3, (proposed street), on the northeast by the remainder of said lot 49-2 and on the southeast by lot 49-1.M.Georges Aliatas.et M.Emmanuel Papamanolioudakis.M.Leopold Palancz.0197780-0.0198430-1.La partie nord-est du lot 49-40 mesurant 100 pieds de largeur sur une profondeur de 90.6 pieds, bornée au nord-ouest par une partie du lot 49, au sud-ouest par le résidu dudit lot 49-40, au sud-est par une rue proposée (49-31) et au nord-est par le lot 49-41; et la partie sud-ouest du lot 49-41 mesurant 10 pieds de largeur sur une profondeur de 91.05 pieds, bornée au sud-est par une rue proposée (49-31) au nord-ouest par partie du lot 49.au sud-ouest par le lot 49-40, et au nord-est par le résidu dudit lot 49-41.19-5 The northeast part of lot 49-40 measuring 100 feet in width by a depth of 90.6 feet, bounded on the northwest by a part of lot 49, on the southwest by the remainder of said lot 49-40, on the southeast by a proposed street (49-31) and on the northeast by lot 49-41; the southwest part of lot 49-41 measuring 10 feet in width by a depth of 91.05 feet, bounded on the southeast by a proposed street (19-31 ), on the nortnwest by a part of lot 49, on the southwest by lot 49-40, and on the northeast by the remainder of said lot 49-41.0198500-1.M.Dimitrios Christopoulos et M.Peter Christopoulos.019.8900-3.M.Roger Fettu.0199310-4.M.Arpiar Kaloustian.0199330-2.M.Arpiar Kaloustian.0199390-6.M.Christos Papachristou, et M.John Papachristou.0199410-2.M.Christos Papachristou, et M.John Papachristou.0199750-1.M.Aimable Dannel.0199770-9.M.Aimable Dannel.0199790-7.Dame Wcra Arehangelsky, épouse Fritz Naujoks.0200180-8.Dame Jacqueline Vanhoutte, épouse Jean Detanne.0200360-6.Dame Yaroslawa Hlywka, épouse Michael Veleky.0200500-7.Dame Jacqueline Vanhoutte, épouse Jean Detanne.0200520-5____M.William Wolny.0200560-1.M.Marcel Mauron.0200580-9.M.Marcel Mauron.0200720-1.Dame Maria Sideri, épouse Michael Ganakas, et Dame Shirley Burd- man, épouse Earl Myers.La partie sud-ouest du lot 49-176 mesurant 164.2 pieds dans sa ligne nord-ouest.95.9 pieds dans sa ligne sud-ouest, 94 pieds dans sa ligne nord-est, et 191.85 pieds dans sa ligne sud-est, bornée au nord-ouest par une rue (49-167), au sud-est par les lots 49-33, 34 et.par une partie du lot originaire numéro 49, au sud-ouest par le Chemin Chambly, et au nord-est pat le résidu dudit lot 49-176.49-43 49-62 49-88 49-89 49-92 49-93 49-118 49-119 49-120 49-141 49-149 et/and 150 49-157 49-158 49-160 49-161 The southwest part of lot 49-176 measuring 164.2 feet on its northwest line, 95.9 feet on its southwest line, 94 feet on its northeast line, and 191.85 feet on its southeast line, bounded on in onor j v3t by a street 0266190-8.Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.«0 77 0266200-5.Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.0266210-4.Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.rq70 0266220-3.Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.S~«n 0266230-2.Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.6»-80 0266240-1.Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.ÇXol 0266250-0.0266340-9.0266360-7.0266370-6.0266380-5.0266390-4.0266400-1.0266420-9.0266430-8.0266440-7.0266450-6.0266460-5.0266470-4.0266590-9.0266600-6.0266610-5.0266710-3.0266730-1.0266820-0.0267230-1.0267240-0.0267280-6.0267290-5.0267300-2.0267310-1.0267320-0.0267330-9.0267340-8.0267350-7.0267360-6.0267370-5.0267380-1.0267390-3.0267400-0.0267410-9.0267420-8.0267430-7.0267440-6.0267450-5.0267460-1.0267710-2.0267720-1.0267730-0.0267740-9.0267750-8.0267760-7.0267770-6.0267780-5.0267790-4.0267810-0.0267880-3.0267950-4.0268020-5.0268030-4.Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.6n~n?Ludwig Zabludowski, Moses Haiperin et Herbert Lang.69-91 Pietro Scardera.69-93 Pietro Scardera.69-94 Pietro Scardera.69-95 Pietro Scardera.69-96 Pietro Scardera.69-97 Nicolo, Alfredo et Elena Giannetti.69-99 Nicolo, Alfredo et Elena Giannetti.69-100 Nicolo, Alfredo et Elena Giannetti.69-101 Nicolo, Alfredo et Elena Giannetti.69-102 Nicolo, Alfredo et Elena Giannetti.69-103 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.09-104 Giulio Ferrante.69-116 Giulio Ferrante.69-117 Giulio Ferrante.69-118 Leslie Braun.69-128 Leslie Braun.69-129 Ernest Yana.69-138 Ernest Yana.69-161 Ernest Yana.69-162 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-166 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-167 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-168 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-169 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-170 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-171 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-172 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-173 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-174 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-175 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-176 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-177 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-178 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-179 Ludwig Zabludowski.Moses Halperin et Herbert Lang.69-180 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-181 Angelo Dimeglio.69-182 Angelo Dimeglio.69-183 Angelo Dimeglio.69-1S4 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-197 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-198 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.96-199 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Long.69-200 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-201 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-202 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-203 Ludwig Zabludowski.Moses Halperin et Herbert Lang.69-204 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-205 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-207 Ludwig Zabludowski, Moses Halperin et Herbert Lang.69-214 Alkate Development Inc.69-221 Alfredo Giannetti.69-228 Alfredo Giannetti.69-229 GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC, 27 avril 1974, 100- année, n° 17 3099 Folio Nom A'amr Description de l'immeuble Description of immoveable 0268380-3.Ilja Welikoff.0268390-2.Ilja Welikoff.0268400-9.Ilja Welikoff.0268410-8.Ilja Welikoff.0268500-6.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268510-5.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268520-4.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268530-3.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.026S540-2.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268550-1.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268560-0.Dame Doha Pollock, veuve Harry Faierman.0268570-9.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268580-8.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268590-7.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268600-4.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268610-3.Dame Doba Pollock, veuve Harry Faierman.0268640-0.Dame Eugene Windier.0269010-5.M.Roger Fettu.0269020-4.M.Roger Fettu.0269030-3.M.Alois Zeiscl.0269040-2.M.Alois Zeisel.0269360-4.M.Roger Fettu.0269440-4.M.Roméo Lareau.0269530-2.Dame Ernestina Simovic épouse Emanuel Letko.0269540-1.Dame Ernestina Simovic épouse Emanuel Letko.0270380-9.Eugène Brown, et Paul Rendier.0270510-1.M.Leslie Braun.0270520-O.M- Leslie Braun.0270690-1.Dame Eugene Windier.0270730-5.Dame Marina Lejman, épouse Henri E.Kruszynsky.0270870-9.August Schmid.0271000-2.Anton Vogel.0271010-1.Anton Vogel.0271020-0.Anton Vogel.0271030-9.Rodolphe Marcotte.0271080-4.Antonios Choriatis.0271100-0.Eugenie Windier.0271110-9.Eugenie Windier.0271680-1.Dame Estriana Pink, épouse Winston Adlam, et Winston Adlam 0271690-0.Dame Estriana Pink, épouse Winston Adlam, et Winston Adlam.0272010-0.Bernard Laplante.0272020-9.Bernard Laplante.0272030-8.Bernard Laplante.0272100-9.Charles Dahinden.0272110-8.Charles Dahinden.0272500-1.Alkate Development Inc.0272660-2.Alkate Development Inc.0272670-1.Eugenie Windier.0272760-0.Odilon Perrault.0272770-9.Odilon Perrault.0272810-3.Ernest Yana.0273170-1.Alkate Development Inc.0273180-0.Yves Robail.0273580-1.Paul Emile Mailloux.0273630-4.Toivo Juuti.0273800-3.Roger Pronovost.0273810-2.Roger Pronovost.0273870-6.Eugène Delignou.0274050-4.Alfred Hans Bayer.0274060-3.Alfred Hans Bayer.0274070-2.Prudential Construction Co.Inc.0274160-1.Ernest Yana.0274170-0.Zwi Ganani.0274290-6.Simon Wicki.0274300-3.Simon Wicki.0274310-2.Dame Borisa Roth veuve Israel Fried.0274320-1.Dame Borisa Roth veuve Israel Fried.0274440-7.Dlle Guna Olte.0274450-0.Dlle Guna Olte.0274530-5.Benoit Laliberté.0274540-4.Benoit Laliberté.0274560-2.Alkate Development Inc.0275190-7.Roger Fettu.69-264 69-265 69-266 69-267 69-276 69-277 69-278 69-279 69-2MI 69-281 69-282 69-283 69-284 69-285 69-286 69-287 69-290 69-327 69-328 69-329 69-330 69-346 69-349 69-358 69-359 69-442 69-455 69456 70-5 70-9 70-23 70-36 70-37 70-38 70-39 70-14 70-46 70-47 70-98 70-99 70-131 70-132 70-133 70-140 70-141 70-188 70-195 70-196 70-205 70-206 70-210 70-231 70-232 70-257 70-262 70-279 70-280 70-286 70-304 70-305 70-306 70-315 70-316 70-328 70-329 70-330 70-331 70-343 70-344 70-352 70-353 70-355 70-418 31 (JO QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, Xo.17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0275290-5.0275300-2.0275410-9.0275420-8.0275430-7.0275440-6.0275450-5.0275620-3.0276110-4 0276120-3.0276350-6 0276360-5.0276760-6.0276770-5.0277060-0.0277070-9.0277 ISO li 0277230-9.0277240-8.0277440-4.0277450-3 0277530-2 0277540-1.0277550-0.0277560-9 0277590-6.0278050-0.027.SOHO !l 0278500-4.0278680-4.027S6!KI .1 (I27ssc,n 2 0278870-1.0279000-4 70-428 70-129 70-440 Lucien Gagné.Lucien Gagné.Iliya Welikoff._ .Iliya Welikoff.70-441 Iliya Welikoff.™-442 Iliya Welikoff.70-443 70-461 72-10 72-11 72-34 72-35 72-77 72-78 72-107 72-108 72-120 72-125 72-126 72-146 72-147 72-157 72-158 7a-159 72-160 72-163 72-211 72-212 72-258 72-276 72-277 72-294 72-295 72-308 Iliya Welikoff George Donat.Charles Eugène Laforest.Charles Eugène Laforest.Henri Louis Grenier.Henri Louis Grenier.Albert Le Bihan.Albert Le Bihan.Southway Development Inc.Dame Eugène Windier.Southway Development Inc.Julius Rische.Julius Rische.Edouard C.Coté Jr.Edouard C.Côté Jr.Yvette Taillard.Yvette Taillard.Bernard Shober.Bernard Shober.Louis Vaccaro.Donald John Albert.Donald John Albert.Walter Jawornicki.Southway Development Inc.Southway Development Inc.Eugène Delignou.Eugène Delignou.Dame Dionyssia Vythoulka épouse Alfredo Nunes Santos et Silva Antonio.0279010-3.Antonio Silva, et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos.0279020-2.Antonio Silva et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos.0279270-3.John Herzog.0279320-6.Alfred Hans Bayer.0279330-5.Alfred Hans Baver.0279340-4.Alfred Hans Bayer.0279350-3.Alfred Hans Bayer.0279360-2.Dame Lydia Lewandowski veuve Karl Alfred Merklein.0279440-2.Johann Roj ka.0279450-1.Johann Rojka.0279880-9.Robert Sigrist.0279890-8.Robert Sigrist.0279900-5.Robert Sigrist.0279910-4.Robert Sigrist.0279970-8.Antonio Silva, et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos.0279980-7.Antonio Silva, et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos.0279990-6.Antonio Silva et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos.0280160-3.Dame Ruth Stentzel, veuve Hans Bencoke.0287770-2.Peter Green berg.0287820-5.PeterGreenberg.0287830-4.PeterGreenberg .0293310-9.Jack Sheiner.Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 319806.72-309 72-310 72-337 72-342 72-343 72-344 72-345 72-346 72-355 72-356 72-401 72-402 72-403 72-404 72-410 72-411 72-412 72-129 75-19 75-24 75-25 76-11 To withdraw the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 319806.0293320-8.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.76-12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 197A.100- année, n° 17 3101 Nom Description de l'immeuble Folio Name Description of immoveable A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293330-7.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-13 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293340-6.Jack Sheiner.Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-14 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chamblv sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293350-5.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-15 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293360\u20141.Jack Sheiner.Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-16 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293370-3.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-17 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293380-2.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-18 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293390-1.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-19 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293400-8.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-20 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319800.number 319806. 3102 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1971, Vol.106, No.17 Nom Description de l'immeuble 'r°''° Xante Description of immoveable 0293410-7.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-21 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Kegistry Otnce under 319806.number 319806.0293420-6.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-22 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under .(l'.isor,.number 319806.0293430-5.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-23 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Quélwc under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293440-4.Jack Sheiner.Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-24 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 31'.is0ti.number 319806.0293450-3.Jack Sheiner.Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-25 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0293460-2.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-26 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the Count v of Chamblv Registry Office under 319806.number 319806.0293470-1.Jack Sheiner.Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-27 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed ll^.'X'i \" c»registrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319*00.number 319806.0293480-0.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-28 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie exproprié* par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated bv the Department of de la province de Québec aux termes d un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed 5S52S2Î «\"«g'strement u comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319800.number 319806.0293490-9.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-29 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed ¦.Vooïï enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under .110X06.number 319806. (JAZKTTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1971, 106' année, n\" 17 3103 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0293500-5.Jack Sheiner, Albert Sheiner et Samuel Sheiner faisant affaires ensemble 76-30 sous les nom et raison sociale de / carrying on business together under the firm-name of Home Mortgage & Acceptance Co.Reg'd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Department of de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au Roads of the Province of Québec under the terms of a deed bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro registered in the County of Chambly Registry Office under 319806.number 319806.0300420-7.Christos Tatsis.77-10 0300430-6.Christos Tatsis.77-11 0300470-2.Kostas Cothalis.77-15 0300480-1.Dame Niki Batsakas, épouse Kostantinos Georganes, et Kostantinos 77-16 Georganes.0300530-3.Kostas Cothalis.77-21 0300580-8.George K.Ress.77-26 0300620-2.Rudolf Stoeckl.77-30 0300630-1.Rudolf Stoeckl.77-31 0300640-0.Dame Sadik Xheka .77-32 0300650-9.Dame Sadik Xheka.77-33 0300660-8.Dame Sadik Xheka.77-34 0300730-9.Elias Gikas.77-41 0300740-8.Elias Gikas.77-42 0300750-7.Dame Avelyn Gabriel, et John N.Maris, son époux.77-43 0300760-6.Dame Avelyn Gabriel, et John N.Maris, son époux.77-44 0300860-1.Spartakos Inc.77-54 0300870-3.Spartakos Inc.77-55 0301040-2.Mile Angeliki Magafas.77-72 0301050-1.Spartakos Inc.77-73 0301160-8.Dame Maria Papa, et Sotirios Bardis, son époux.77-84 0301170-7.Dame Maria Papa, et Sotirios Bardis, son époux.77-85 0301430-5.J.William Katralis, et Paraskevas J.Katralis.77-111 0301440-4.J.William Katralis, et Paraskevas J.Katralis.77-112 0301450-3.J.William Katralis.et Paraskevas J.Katralis.77-113 0301460-2.J.William Katralis, et Paraskevas J.Katralis.77-114 0301540-1.Tasos Pollatos.77-135 0301720-9.Demetrios Paterekas.77-144 0301730-8.William Drosos, In Trust.77-145 0301740-7.William Drosos, In Trust.77-146 0301750-6.William Drosos.77-147 0301760-5.William Drosos.77-148 0301960-1.Spartakos Inc.77-164 0301970-0.Spartakos Inc.77-165 0302020-3.Dame Kalliope Hatzinikolaou épouse Constantin Costaras.77-170 0302190-4.Peter Belesis.77-187 0302200-1.Peter Belesis.77-188 0302210-0.Peter Belesis.77-189 0302440-3.Andreas Galanis.77-212 0302450-2.Andreas Galanis.77-213 0302540-0.Demetrios Paterakas.77-223 0302900-6.Sadix Xheka, et Beha Xheka.77-259 0302910-5.Sadix Xheka, et Beha Xheka.77-260 0303040-0.Sadix Xheka, et Beha Xheka.77-273 0303050-9.Sadix Xheka, et Beha Xheka.77-274 0321980-5.Dlle Joan Wright.80-61 0322040-7.Dlle Doris L.Asantewa.80-67 0322380-7.Dlle Myrl Best.80-101 0322440-9.Winston A.Allen.80-108 0322600-8.Fenelon Audain.80-124 0323110-7.Dame Roberta C.Dalessio et William T.P.Gittens, son époux.80-180 0326410-8.Pierre J.Elie, et Dame Jessy Massac, son épouse.80-236 0326420-7.Max Boucicaut, et Dame Magclla Solomon, son épouse.80-237 0326430-6.Gérard J.Elie, et Dame Mercedes Lebon, son épouse.80-238 0326450-4.Frank Chenet.80-240 0326500-6.Max Boucicaut, et Dame Magella Solomon, son épouse.80-245 0326790-3.Dlle Phyllis M.Aris, et Dlle Linnette E.Richardson.80-278 0326990-9.Dame Soliva Chkaiban, épouse Joseph Assali, et Dlle Bahia Chkaiban.80-298 0327040-2.Hermann Gauthier.80-303 0327050-1.Albert Jérôme, et Dame Yvette Colin, son épouse.80-304 0327090-7.Maxime Roumain, et Dame Rose Ascencio, son épouse.80-309 0327100-4.Maxime Roumain, et Dame Rose Ascencio, son épouse.80-310 0327130-1.Serge S.Celestin.80-314 0346340-3.Ernest Yana et Leonar Childs.90-108 0346490-6.Laszlo Csere.90-113 3104 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.10G, No.17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0346690-1.Laszlo Csere.0348580-2.Dlle Cyntha Eisa Iton.0348670-1.Derrick McNeil.0348710-5.Dlle Orpah Louise Headlam.0348890-5.Ashton English.0349060-4.Derrick Rowe.0349070-3.Simeon Cornelius Stewart.0349090-1.Eric E.Timothy.0349100-8.Pine Land Corp.0349110-7.Pine Land Corp.0349250-1.Dlle Joy Jamieson.0349350-9.Eric E.Timothy.0349370-7.Seymour Royal Williamson.0349430-9.Dlle Blossom Gloria Henry.0349440-8.Alfred Clayton.0349450-7.Alfred Clayton.0349500-9.George Gilbert Scott.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 331275 et 363181.90-121 .91-19 .91-28 .91-32 .91-61 .91-78 .91-79 .91-81 .91-82 .91-83 .91-97 .91-107 .91-109 .91-115 .91-116 .91-117 .91-122 To withdraw the part expropriated bv the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 331275 and 363181.0349540-5.Antonio Moscatel.0349640-3.Eric E.Timothy.0349700-5.Harry Beecher.0349750-0.Joseph Harold McComie.0349760-9.Joseph Harold McComie.0349770-8.Dlle Bernice Messiah.0349780-7.Dlle Bernice Messiah.0349910-0.Lynden Walton.0349920-9.Lynden Walton.0349930-8.Lynden Walton.0349940-7.Lunden Walton.0350160-8.Uriel Georges Whyte.0350180-6.Dannard Samuels.0350190-5.Dannard Samuels.0350200-2.LLewellvn Sandy.0350210-1.Roy Linton Hart.0350220-0.Eric E.Timothy.0350230-9.Dlle Icilma E.Samnson.0350250-7.Kaud Investment Corp.0350310-9.Ashton English.0350360-4.Kenneth Crossfield.0350420-6.Robert James.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 331275 et 349672.91-126 .91-136 .91-142 .91-147 .91-148 .91-149 .91-150 .91-163 .91-164 .91-165 .91-166 .91-188 .91-190 .91-191 .91-192 .91-193 .91-194 .91-195 .91-197 .91-203 .91-208 .91-214 To withdraw the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 331275 and 349672.0350430-5.Robert James.91-215 0350450-3.Dlle Shirley Alexander.91-217 0350520-3.Lloyd Mangaroo.91-224 0350530-2.Lloyd Mangaroo.91-225 0350550-0.Roy Linton Hart.91-227 0350570-8.Cornelius Blake.91-229 0350580-7.Cornelius Blake.91-230 0350650-8.Dennis E.Dublin.91-237 0350660-7.Dennis E.Dublin.91-238 0350670-6.Dennis E.Dublin.91-239 0350700-1.Nathan Edwards.91-242 0350710-0.Nathan Edwards.91-243 0350800-9.Dlle Eileen Hanson.91-252 0350810-8.Dlle Eileen Hanson.91-253 0356100-8.A.Fred Logan.92-175 0356110-7.A.Fred Logan.92-176 0356440-8.A.Fred Logan.92-209 0356450-7.Kenrick Quamina.92-210 0360610-0.L N S Development Corp.93-24 à 26 0360620-9.Dlle Avril C.Davy.93-208, 209 0360710-8.YvesRobail.93-287,288 0360990-6.Spathodia Land Corporation.93-344 0361560-6.Spathodia Land Corporation.93-460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n' 17 3105 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0361660-4.0361810-5.0361950-9.0361960-8.0361970-7.Ernest Yana.Spathodia Land Corp.Santos Investment Corp.Santos Investment Corp.Aurelio Brizida Ribeiro De Eiras, et Dame Maria José Pires Serra, son épouse.Santos Investment Corp.Santos Investment Corp .Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et, Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate.Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.Gerardo D'Abate, Giovanni Colaneri et Costanzo Padula.George Pawlik.George Pawlik.George Pawlik.Dlle Judith Ann East.Dlle Judith Ann East.Antonio Silva, et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos.Santos Investment Corp.George Pawlik.George Pawlik.Walter Jawornicki.93-479 93-505.506 93-534.535 93-536 à 538 93-539, 540 0361980-6.0361990-5.0362070-5.0362080-4.0362090-3.0362100-0.0362110-9.0362120-8.0362130-7.0362140-6.0362150-5.0362160-5.0362220-6.0362230-5.0362240-4.0362250-3.0362260-2.0362270-1.0362280-0.0362290-9.0362300-6.0362310-5.0362320-4.0362330-3.0362350-1.0362370-9.0362380-8.0362500-1.0362510-0.0362740-3.0362750-2.0362830-2.0362840-1.0362950-8.A distraire le quart du lot vendu à P3rk Realty Corporation aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 203383.93-541 93-542, 93-558, 93-560.93-562, 93-564, 93-566, 93-568, 93-570.93-572, 93-574, 93-576, 93-589, 93-591, 93-593.93-595, 93-597, 93-599, 93-601.93-603, 93-605, 93-607.93-609, 93-611 93-614.93-618, 93-620, 93-641 93-644 93-685 543 559 561 563 565 567 569 571 573 575 577 590 592 594 596 598 600 602 604 606 608 610 à 613 615 619 621 à 643 93-686 93-699, 700 93-701, 702 93-717 Less and to withdraw that quarter of the lot sold to Park Realty Corporation under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 203383.0363000-1.0363040-7.O363190-O.0363220-5.0363310-4.0363320-3.0363330-2.0363360-9.0363370-8.0363550-5.0363590-1.0363600-8.0363610-7.0363620-6.0363630-5.0363640-4.0363650-3.0363660-2.0363670-1.0363680-0.0363820-2.0364040-6.0364450-7.Jean Désiré Nagy.Ernest Yana.Spathodia Land Corporation.Spathodia Land Corporation.Georges Anthony.Dame Valerie Long, épouse Peter Kluever.Dame Valerie Long, épouse Peter Kluever.Dame Catherine Gage, veuve Thomas Riley.Dame Catherine Gage veuve Thomas Riley.Dlle Avril C.Davy.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Eizens Kalnins.Santos Investment Corp.Santos Investment Corp., Walter Jawornicki.93-725, 726 93-735.736 93-758, 759 93-763 93-779 à 781 93-783 à 785 93-786 à 788 93-792, 793 93-794 93-830 à 832 93-840, 841 93-842, 843 93-844, 845 93-846, 847 93-848, 849 93-850, 851 93-852.853 93-854, 855 93-856, 857 93-858, 859 93-886 93-929 93-1004 A distraire les 3/8 sud-ouest vendus à Park Realty Corpora- Less and to withdraw the southwest 3/8 sold to Park Realty tion aux termes d'un acte enregistre au bureau d'enregistré- Corporation under the terms of a deed registered in the Coun-ment du comté de Chambly sous le numéro 203383.ty of Chambly Registry Office under number 203383. 310(i QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1!)74, Vol.106, No.17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0364S70-6.Roger Fettu.0364900-1.Santos Investment Corp.0364930-8.The Longueuil Gardens Company Limited 0364940-7.The Longueuil Gardens Company Limited 0364950-6.The Longueuil Gardens Company Limited 0364960-5.The Longueuil Gardens Company Limited 0365150-2.Santos Investment Corp.0370640-5.Walter Jawornicki.A distraire du lot 94-135 les 3/8 vendus à Park Realty Corporation aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 203383.93-1074 .93-1080 .93-1087.1088 .93-1089, 1090 .93-1091, 1092 .93-1093.1094 .93-1134 .94-135, 136 To withdraw from lot 94-135 the 3/8 sold to Park Realty Corporation under the terms of a deed of sale registered in the County of Chambly Registry Office under number 203383.0371100-9.0372410-1.0372420-0.0372780-7.0372790-6.0373130-4.0373140-3.0373150-2.0373360-7.0373370-6.0373380-5.0373420-9.0373430-8.0373780-6.0373820-0.0374530-4.0375170-8.0375180-7.0375190-6.0375200-3.0375290-4.0375300-1.0375350-6.0375360-5.0375370-4.0375400-9.Ernest Yana.Dame Joyce Craigg.Dame Joyce Craigg.Karl Lawson et Dame Dorothy Chin Karl Lawson et Dame Dorothy Chin Harold G.Peart.Spathodia Land Corporation.Spathodia Land Corporation.Southway Development Inc.Southway Development Inc.Southway Development Inc.Roger Fettu.Roger Fettu.Edward Arthur Moss.Edward Arthur Moss.Alkate Development Inc.Dlle Gladys Advira McLeish.Dlle Gladys Advira McLeish.Spathodia Land Corporation.Spathodia Land Corporation.Dlle Heather Greaves.Dlle Heather Greaves.Spathodia Land Corporation.Santos Investment Corp.L N S Development Corp.Santos Investment Corp.0375490-0.Dlle Dorothy Drummond.0375540-2.Santos Investment Corp.0375550-1.Arthur Edward Moss.0375630-1.Pine Land Corp.0391570-9.Spathodia Land Corp.0391640-0.Dlle Myrl Best.0391650-9.Dlle Myrl Best.0391720-0.Spathodia Land Corp.0391730-9.Spathodia Land Corp.0391740-8.Spathodia Land Corp.0391750-7.Spathodia Land Corp.0391760-6.Spathodia Land Corp.0391770-5.Spathodia Land Corp.0391870-3.Spathodia Land Corp.0391880-2.Spathodia Land Corp.0391900-8.Dame Ave Elme, épouse Selyn Inniss .0391980-0.Dlle Beryl Thompson.0392000-6.Spathodia Land Corp.0392010-5.Spathodia Land Corp.0392020-4.Spathodia Land Corp.0392030-3.Spathodia Land Corp.0392070-9.Spathodia Land Corp.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 331275.94-209 à 211 94-479, 480 94-481,482 94-555, 556 94-557 a 559 94-610, 611; 93-121, 122 94-612.613; 93-123, 124 94-614; 93-125 94-660, 661 94-662, 663 94-664, 665 94-671, 672 94-673, 674 94-745, 746 94-755, 756 94-903, 904 94-1038, 1039; 93-169, 170 94-1040, 1041; 93-171, 172 94-1042; 93-173 94-1043.1044; 93-174, 175 94-1062; 93-193 94-1063, 1064; 93-194.195 94-1072 à 1075; 93-203 à 206 94-1076; 93-207 94-1077 94-1081 ; 93-213 .94-1096; 93-228 .94-1108;93-240 .94-1109,1110:93-241,242 .94-1125.1126 .98-2 .98-9 .98-10 .98-17 .98-18 .98-19 .98-20 .98-21 .98-22 .98-32 .98-33 .98-35 .98-43 .98-45 .98-46 .98-47 .98-48 .98-52 To withdraw the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 331275.0392090-7.Spathodia Land Corp.98-54 0392100-4.Spathodia Land Corp.98-55 0392120-2.Spathodia Land Corp.98-57 0392130-1.Spathodia Land Corp.¦ \u2022 \u2022\u2022 gx_5s 0392160-8.Dlle Pearl Dummot.98-61 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' aimée, »° 17 3107 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0392190-5.Dudley Morris Enterprises Limited 0392200-2.Spathodia Land Corp.0392210-1.Spathodia Land Corp.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 331275.98-64 .98-65 .98-66 To withdraw the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 331275.0392220-0.Dlle Jean A.Callender.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 331275.98-67 To withdraw the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 331275.0392230-9.Dlle Beryl Dixon, et Dlle Miley M.Hobbs.98-68 A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie To withdraw the part expropriated by the Roads Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of the Province of Québec under the terms of a deed reg-bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro istered in the County of Chambly Registry Office under num-331275.ber 331275.0392240-8.0392280-4.0392300-0.0392320-8.0392350-5.0398960-5.0399020-7.0399040-5.0399060-3.0399270-8.0399630-3.,, 0399640-2.0399650-1.0399660-0.0399670-9.0399680-8.0399900-0.0399910-9.0400060-0.0400130-1.0400140-0.0400150-9.0400280-4.0400380-2.0400530-2.0400610-2.0400620-1.0400850-4.0401030-2.0401110-2.0401120-1.0401430-4.0401440-3.0401750-5.0401760-4.0401770-3.0401780-2.0401790-1.0401800-8.0401810-7.Spathodia Land Corp.98-69 Spathodia Land Corp.98-73 Spathodia Land Corp.98-75 Spathodia Land Corp.98-77 Spathodia Land Corp.98-80 Mario Sollevanti.99-9 à 11 Pat Marra.99-20 Pat Marra.99-22 Emmanuel Bernard Sambrano.99-25, 26 Alkate Development Inc.99-67, 68 Dame Albertine Marion, veuve Georges Lanouette; Jean-Baptiste et Louis Lanouette, cs-qualités d'exécuteurs-testamentaire de la Succession de Georges Lanouette.99-140, 141 Dame Albertine Marion, veuve Georges Lanouette; Jean-Baptiste et Louis Lanouette.es-qualités d'exécuteurs-testamentaire de la Succession de Georges Lanouette.99-142, 143 Dame Albertine Marion, veuve Georges Lanouette; Jean-Baptiste et Louis Lanouette.es-qualités d'exécuteurs-testamentaire de la Succession de Georges Lanouette.99-144, 145 Dame Albertine Marion, veuve Georges Lanouette; Jean-Baptiste et Louis Lanouette, es-qualités d'exécuteurs-testamentaire de la Succession de Georges Lanouette.99-146, 147 Dame Albertine Marion, veuve Georges Lanouette; Jean-Baptiste et Louis Lanouette, es-qualités d'exécuteurs-testamentaire de la Succession de Georges Lanouette.99-148, 149 Dame Albertine Marion, veuve Georges Lanouette; Jean-Baptiste et Louis Lanouette.es-qualités d'exécuteurs-testamentaire de la Succession de Georges Lanouette.99-150, 151 Eric E.Timothy.99-197 à 199 Pat Marra.99-200 à 202 Paradise Gardens Development Inc.99-231 Gabrielle Colasurdo.99-244, 245 Gabrielle Colasurdo.99-246,247 Gabrielle Colasurdo.99-248, 249 Spathodia Land Corp.99-273 à 275 Frank Taylor et Dame Esther Rolston.son épouse.99-295.296 Alkate Development Inc.99-331.332 Milton S.Christopher.99-347.348 Milton S.Christopher.99-349, 350 Spathodia Land Corp.99-395 à 397 Emmanuel Bernard Sambrano.99-435, 436 Hilda Sullivan.99-449 à 451 Hilda Sullivan.99-152, 453 Tripodi Giove.99-520, 521 Tripodi Giove.99-522, 523 Anton Dojacek.99-584, 585 Anton Dojacek.99-586, 587 Anton Dojacek.99-588, 589 Anton Dojacek.99-590, 591 Anton Dojacek.99-592.593 Anton Dojacek.99-594, 595 Anton Dojacek.99-596, 597 a i os QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol- '(\">¦ No- 17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0401820-6.0401830-5.0401840-1.0401960-0.0402150-7.0402160-6.0402180-4.0402190-3.0402200-0.0402210-9.0402220-8.0402280-2.0402290-1.0402300-8.0402310-7.0402320-6.0402330-5.0402340-4.0402410-5.0402470-9.0402510-2.0402750-4.0402990-6.0403230-6.0403690-1.0403700-8.0403710-7.0403720-6.0404190-1.0404210-7.0404440-0.0404670-2.0404810-4.0404820-3.0404830-2.0404840-1.0404910-2.0405020-9.0405030-8.0405050-6.0405060-5.0405170-2.0405190-0.0405220-5.0405230-4.0405250-2.0405280-9.0405290-8.0405370-8.0405380-7.0405390-6.0405400-3.0405410-2.0405450-8.0405490-4.0405500-0.0405510-9.0405520-8.0405590-1.0405600-8.0405610-7.0405670-1.0405700-0.0405770-9.0405780-8.0405790-7.(1405800-4., .\u201e ., .99-598, 599 Anton Dojacek.,\u201e, lwn Anton Dojacek.09-602 à 604 Anton Dojacek.09-625 Spathodia Land Corp.09-660 661 Anton Dojacek.00_662] 663 Anton Dojacek.99-664, 665 Anton Dojacek.99-666,667 Anton Dojacek ¦ \u2022 99-668, 669 Anton Dojacek.»9-«70.«71 Anton Dojacek.99-672 673 Anton Dojacek.99-684'685:100-1251,1252 Anton Dojacek.90-686.687:100-1253.1254 Anton Dojacek.00-688.689:100-1255.1256 Anton Dojacek.99-690,691 ; 100-1257,1258 Anton Dojacek.on r,02.f,93; 100-1259.1260 Anton Dojacek.00-694.695; 100-1261.1262 Anton Dojacek.09-696 à 698; 100-1263 à Anton Dojacek.1265 100\u20141277 1278 SSSJSftl*fe:::::::::::^ 99-717,718:100-1284,1285 The Rov-al Trust Company, es-qualité d'exécuteurs-testamentaire et de Fiduciaires de la succession de David Davis / /n if capacity ai executor and trustée» for the estate of Darid Darit.g\"5B ! T-Q.,nA_iian Emmanuel Bernard Sambrano.ifrBZ î Ji?.' 10°-1340 Emmanuel Bernard Sambrano » ^\" Mauro Francesconi.g»-*» * 884 Mauro Francesconi.m oén osi Gabrielle Colasurdo.M Mauro Francesconi.rS'oef Spathodia Land Corp .9^088 à 1084 Mauro Francesconi.J» Ino-insa Spathodia Land Corp.99- 08,.1088 Emmanuel Bernard Sambrano.23J5 Spathodia Land Corp.99- >83 Christos Paraskevopoulos.997o?I4' 1215; 10°-1367' M(i8 Christos Paraskevopoulos.\"i^ô\"' 1217i l00\"1369' Christos Paraskevopouloe.\"iàfj8' 10O~1371, Christos Paraskevopouloe.SS\"!229\\,?ÎL Spathodia Land Corp.90- 234 à 1236 Ernest Yana.g\" 258 Ernest Yana.99-1259.1260 Ernest Yana .99-1263.1264 Theodoras Svinkos.et Apostolos Stetlos.09-1265.1266 Ernest Yana.»\" »«.28* EmestYan.99- 287.1288 Ernest Yana.SMSl Ernest Yana .99-1292 Christos Paraskevopoulos.99-1294 M 296 Austin RU Osbcrt Ward.\"-13,03 .Eric E.Timothv.99-1304 à 1306 Svdney Epstein, et haie Shore.99-1321.1322 Svdnev Epstein, et Issie Shore.99-1323, 1324 Sydney Epstein, et Issie Shore.99-1325, 1326 Sydney Epstein, et Issie 8hore.99-1327, 1328 Sydney Epstein, et Issie Shore.99-1329.1330 Emmanuel Bernard Sambrano.99-1337.1338 Svdney Epstein, et I»ie Shore.99-1346.1347 Svdney Epstein, et Issie Shore.99-1348.1349 Sydney Epstein, et Issie Shore.99-1350.1351 Svdney Epstein, et Issie Shore.99- 1352.1353 Austin FiU Osbert Ward.99-1365 Christos Paraskevo|)ouloe.99-1366 Christos Paraskevopoulos.99-1367 Austin Fin Osbert Ward.99-1383.1384 Spathodia Land Corp.99-1389.1390 James Cosmos.99-1404.1405 James Cosmos.99-1406,1407 James Cosmos.99-1408,1409 James Cosmos.99-1410,1411 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1974.106' année, n\" 17 3109 Nom Description de l'immeuble Folio Name Description of immoveable 0405810-3.\t\t99-1412 à 1414 0405920-O.\t\t99-1439.1440 0406580-1.\t\t100-14 à 16 0406590-0.\t\t100-17, 18 0406600-7.\t\t100-19, 20 0406610-6.\t\t100-21 0406680-9.\t\t100-37 à 39 0406690-8.\tDame Paraskevi Stamos, et Costas Hatzonoulos, son époux.\t100-41 à 43 0406700-6.\t\t100-44 à 46 0406840-9.\t\t100-70, 71 0407010-8.\t\t100-105 à 107 0407030-6.\t\t100-111 à 113 0407180-9.\t\t100-147 à 149 0407410-0.\t\t100-199, 200 0407600-6.\t\t100-244.245 0407610-5.\t\t100-246 à 248 0407650-1.\t\t100-255 0407720-2.\t\t100-269, 270 0407730-1\t\t100-271, 272 0407740-0.\t\t100-273, 274 0407750-9.\t\t100-275, 276 0407760-8.\t\t100-277, 278 0407770-7.\t\t100-279, 280 0407830-9.\t\t100-292, 293 0407840-8.\t\t100-294 à 296 0407930-7.\t\t100-316, 317 0407940-6.\t\t100-318 à 320 0407950-5.\t\t100-321 0407960-4.\tErnest Yana.\t100-322 0408820-9\tDame Yvonne Ouellette épouse Philippe Forget, Dame Jeanne Ouellette épouse Jean Meloche, Dame Aline Ouellette épouse Emile McElligott, Dame Cécile Ouellette épouse Lucien Bélanger, Leopold Ouellette, Raymond Ouellette, Dame Fernande Ouellette épouse Jean Desjardins, Roger Ouellette, Jean Ouellette, Guy Ouellette et René Ouellette\t100-450, 451 0409090-8.\tRené Martin.\t100-498, 499 0409170-8.\t\t100-512, 513 0409190-6.\t\t100-514 à 516 0409210-2.\t\t100-519, 520 0409270-6.\t\t100-532, 533 0409430-6.\t\t100-560, 561 0409590-7.\tDame Emilia Drakopoulos épouse Sotirios Vlachos.\t100-588, 589 0409660-8.\tJohn Steer.\t100-602, 603 0409730-9.\t\t100-617, 618 0409740-8.\t\t100-619, 620 0410030-1.\t\t100-681, 682 0410130-9.\t\t100-703, 704 0410140-8.\t\t100-705 à 707 0410160-6.\tDame Inès Battaglia, et Livio Mason, son époux.\t100-712 à 714 0410190-3.\t\t100-715 â 717 0410220-8_____\tPietro Lucchesi.\t100-722, 723 0410230-7.\t\t100-724, 725 0410240-6.\t\t100-726, 727 0410300-8.\t\t100-735, 736 0410310-7.\t\t100-737.738 0410320-6.\t\t100-739, 740 0410330-5.\t\t100-741, 742 0410340-4.\t\t100-743 à 745 0410400-6.\t\t100-754, 755 0410440-2.\t\t100-764, 765 0410450-1.\t\t100-766, 767 0411090-4.\t\t100-882, 883 0411240-5.\t\t100-914 0411250-4.\tDame Souzana Paraskevopoulos épouse George Savas.\t100-915, 916 0411360-1.\t\t100-939, 940 0411380-9.\t\t100-943, 944 0411420-3.\tDame Frances Kent, veuve Joseph Janvari, June Janvari, Serene Janvari\t100-951.952 \tet Kathy Mary Janvari.\t 0411430-2.\tDame Frances Kent, veuve Joseph Janvari, June Janvari, Serene Janvari\t100-953 à 955 \tet Kathy Mary Janvari.\t 0411520-0.\t\t100-971, 972 0411610-9.\t\t100-987, 988 0411760-2.\t\t100-1004, 1005 0411770-1.\tJohn Kenneth Austin, et Dame Audrey Coxon, son épouse.\t100-1006 à 1008 ¦3110_QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 197J,.Vol.106.No.1', Nom Description de l'immeuble Folio Name Description of immoveable 0412100-0.0412660-3.0412950-8.0413050-6.0413060-5.0413070-4.0413080-3.0413090-2.0413100-9.0413110-S.0413130-6.0413140-5.0413190-0.0413200-7.0413210-6.0413220-5.0413250-2.0413260-1.0413270-0.0413280-9.C413290-8.0413360-9.0413370-8.0413380-7.0413390-6.0413400-3.0413410-2.0413420-1.0413430-0.Henri Mercier.100-1064 à 1066 Eric E.Timothy.100-1174 a 1176 Spathodia Land Corp.101-9 Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-35 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-36 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-37 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-38 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-39 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-40 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-41 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101\u201443 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-44 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-49 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-50 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-51 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-52 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Benjamin Da Estrela.101-55 Benjamin Da Estrela.101-56 Benjamin Da Estrela.101-57 Benjan in Da Estrela.101-58 Benjamin Da Estrela.101-59 Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-66 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-67 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie a être incorporée 101-68 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-69 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie ù être incorporée 101-70 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-71 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-72 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-73 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 19?4, 10C>* année, n° 17 3111 Nom Description de l'immeuble Folio Name Description of immoveable 0413440-9.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-74 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413450-8.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-75 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413460-7.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-76 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413470-6.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-77 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413480-5.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-78 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413490-4.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-79 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413500-0.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-80 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413510-9.- .Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-81 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413520-8.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-82 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.04I3530-7.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-83 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413540-6.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-84 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413550-5.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-85 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413560-4.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-86 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413570-3.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-87 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413580-2.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-88 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413590-1.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-89 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413620-6.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-92 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413630-5.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-93 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413640-4.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-94 sous le nom de .' In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413660-2.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-96 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413750-1.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-105 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413760-0.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-106 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413770-9.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-107 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.0413780-8.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-108 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd. -3112 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, Xo.11 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0413790-7.0413870-7 0413880-6 0413960-6 0413970-5.04139S0-4.0413070-3.0414270-9.0414280-8.0414290-7.101-109 101-101-101- 117 118 126 Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Joao Andre.Joao Andre.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Dame Charlotte Paquette épouse Jean Bouchard.Dame Charlotte Paquette épouse Jean Bouchard.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie h être incorporée sous le nom de ' In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of a bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro deed registered in the County of Chambly Registry Office 331275.under number 331275.101-127 101-128 101-137 101-157 101-158 101-159 0414300-1 101-160 Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of a bureau d'enregistrement du comté de Chamblv sous le numéro deed registered in the County of Chambly Registry Office 331275.under number 331275.0414310-3.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-161 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of a bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro deed registered in the County of Chambly Registry Office 331275.under number 331275.0414320-2.Mariano Correia Do Rego.0414330-1.Mariano Correia Do Rego.0414370-7.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Viana et Antonio Viana.Jose Viana et Antonio Viana.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie il être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of a SurSÎ\" d enregistrement du comté de Chambly sous le numéro deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 331275.0414380-6.0414390-5.0414540-5.0114550-1.0414560 3.331275.101-162 101-163 101-167 101-168 101-169 101-184 101-185 101-186 0414570-2.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-187 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of Roads of the Province of Québec underThe termeToi a bureau d'enreg.strement du comté de Chambly sous le numéro deed registered in the County of ChimblyRegtstly Office ¦i-S'275.under number 331275. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, «\" 17 3113 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0414680-1, Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-188 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-211 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-212 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-213 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-214 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-215 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée 101-216 sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of intermundo Investments Ltd.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of a bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro deed registered in the County of Chambly Registry Office 331275.under number 331275.0414810-2.0414820-1.0414830-0.0414840-9.0414850-8.0414860-7.0414950-6.Jose Humbria Correia.In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Jose Humbria Correia In Trust pour une compagnie à être incorporée sous le nom de / In Trust for a company to be incorporated under the name of Intermundo Investments Ltd.Dlle Viola Nolan.Laurent Kelly.Laurent Kelly.Joseph Larocque.Peter Asimakopoulos, et Dame Despina Plevritou, son épouse.Victor Michaud.Alexandre Rochette, et Dame Pierrette Allaire, son épouse.Alexandre Rochette, et Dame Pierrette Allaire, son épouse.Alexandre Rochette ,et Dame Pierrette Allaire, son épouse.Alexandre Rochette, et Dame Pierrette Allaire, son épouse.Alexandre Rochette, et Dame Pierrette Allaire, son épouse.George Sardelis.George Sardelis.George Sardelis.George Sardelis.Stefanos Vandikas.Roland Henin.André Gagnon.André Gagnon.André Gagnon.Dlle Denise Bureau.Dlle Denise Bureau.Dame Rachel Golberg, épouse Maurice Schwartz.Ernest Yana.A distraire la partie vendue à Roger Leacock aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 156525.0414960-5.0414970-1.0414980-3.0414990-2.0416120-4.0416270-7.0416280-6.0416430-7.0416520-5.0416640-1.0416670-8.0416680-7.0416690-6 0416700-3.0416720-1.0416770-6.0416780-5.0416790-4.0416800-1.0416870-4.0417660-8.0417730-9.0417740-8.0417750-7.0418110-3.0418120-2.0418230-9.0418530-2.101-225 101-226 101-227 101-228 101-229 102-114 à 116 102-146, 147 102-148, 149 102-180, 181 102-198, 199 102-220, 221 102-226, 227 102-228, 229 102-230, 231 102-232 102-236, 237 102-246, 247 102-248, 249 102-250, 251 102-252, 253 102-265, 266 102-432 à 434 102-445, 446 102-447, 448 102-449, 450 102-512, 513 102-514 à 516 102-540 a 542 102-585 Less and to withdraw the part sold to Roger Leacock under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 156525.0418950-2.0419540-0.0419560-8.0419830-5.Arthur S.Burnett.Dame Laura Powell.Dame Laura Powell.Henry Alfred Collmorgen.102-658, 659 102-763, 764 102-766, 767 102-819, 820 31H QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.April 27.1974.Vol.100.So.17 Folio Nom Name 0419840-4.0419850-3.0419910-5.0420100-4.0420180-2.0420200-8.0420210-7.0420640-5.0420650-4 Henry Alfred Collmorgen Henry Alfred Collmorgen Edouard Thifault.Pine Land Corp.Nikolaos Tsigakis.Paul Lessard.Paul Lessard.Paul Lessard.Paul Lessard Description de l'immeuble Description of immoveable 102-821.822 102-823, 824 102-835, 836 102-888 102-891 à 893 102-895 à 897 102-898, 899 102-982.983 102-984 à 986 042OS9O 0421080-3 .l'aul kessara.ino-i0°9 h 1031 -6.Dame Eva Debroux, veuve Léon Ernaelsteen-.¦ ¦¦\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 ¦ - .Dame Kathleen Frances Cochrane Forster, veuve Kenneth H.Spnggs.102-1065, 106b u421u8u-3.mme l\\ftimcen rraiites voi-unuic ruio^», vsu.s .v,- .~r-\u201e 10o-1091 1092 0421210-6.Gerasimos Andrea Svoronos.ino too?' 10p.8 0«'240-3.JohnFardellas.!! ! ! !! ! ! 102-1099: 1100 1550-5.Nicholas J.Kyranious.înô_iifi7 1560-1.Nicholas J.Kyranious.inoîiRo ¦ Nikolaos Mikalef.JÎSi.ro Nikolaos Mikalef.J9HÎS8 0421250-2 0421260-1 0421270-0 0421550-5 042 0421570-3 0421580-2.0421590-1.0421660-2.0421670-1.0421750-1.0421890-5.0421900-2.0421910-1.0421960-6.0421970-5.0422030-7.0422040-6.0422140-4.0422300-4.0422420-0.0422440-8.0422660-1.0422850-8.0423050-5 0423960-4.0423970-3.0424620-3.0424650-0.0424940-5.0425030-4.0425070-0.0425220-1.John Fardellas.inô-1101 1102 Artemis Moundakis.Îî»lll03 1104 .102-1166 102-1170 à 1172 102-1183, 1184 102-1185.1186 Wles Valiôn Legendre .102-1198.1199 Spathodia Land Çorp.MMg; « Yves Robail Michael Vlachakis Nikolaos Mikalef Spathodia Land Corp.Spathodia Land Corp.}S*~î2?.' 1230 Theophilus D.Owusu Fernand Laforgia.Gerald T.McKernan.Gerald T.McKernan.Anthodesmi Vellopouloy.Georges Cadrin.Peter Greenberg.Artemis Moundakis.Jean Ferron.Guy Poulin.Dimitrios Kokonis.Dimitrios Kokonis.Dimitrios Kokonis.John & Maria Plarinos.Philippas Milonas.Dame Léa Beriault.Nathan Fish.Roland Perron.Joseph Bouey, Arthur Gignac.Dame LianeGignac énouse MauriceGrot-ton, Dame Ceneville Gignac.épouse J.Gérard Plante.Dame Marie Anna Dastous épouse Napoléon Page.Dame Lorette Dastous veuve Gérard Gauthier.Dame Cécile Dastous épouse Roger Lamoureux.Paul Dastous.Dame Pauline Dastous épouse Maurice Racette.Dame Gisèle Dastous épouse Normand Raymond.Dame Simone Dastous épouse Roméo David.M.Roméo Dastous.Dame Gilberte Dastous épouse de Roland Charbonnenu, Dame Marie-Blanche Dastous épouse Laurier Gladu, Dame Rita Dastous, épouse Rolland Racette, Paul-Emile Dastous, Lionel Dastous et Dame Thérèse Dastous épouse de Jean Hamel.A distraire du lot 102-2182 la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 331275.102-1239 102-1240.1241 102-1251.1252 102-1253.1254.1255 102-1275 à 1277 102-1304.1306 102-1328.1329 102-1332, 1333 102-1377.1378 102-1418.1419 102-1682.1683 102-1684.1685 102-1686.1687 102-2022 à 2024 102-2031 & 2033 102-2103, 2104 102-2123 à 2125 102-2142 a 2144 102-2181, 2182 Less and to withdraw from lot 102-2182 the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 331275.0425560-0.0425570-9.0425930-5.0426040-2.0426050-1.0426060-0.0426070-9.0426080-8.0426260-0.0426520-3.0426530-2.0426540 i Georges Poulin.Georges Poulin.Artemis Moundakis.Georges Poulin.Georges Poulin.Georges Poulin.Georges Poulin.Georges Poulin.Rolf Rosenlehner.Fred Arthur Menxer.Fred Arthur Menzer .¦ ¦ Fred Arthur Menzer Cosmopolitan Investment Corp- 102-2255, 2256 102-2257 à 2259 102-2334.2335 102-2358.2359 102-2360.2361 102-2362, 2363 102-2364.2365 102-2366.2367 102-2401 à 2403 102-2456.2457 102-2458.2459 102-2460, 102-2461 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 100' année, n° 17 3115 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0426550-0.Cosmopolitan Investment Corp.102-2462, 2463 0426560-9.Carl Akin et Dame Cassandra Fowler, son épouse.102-2464, 2465 0426570-8.Carl Akin et Dame Cassandra Fowler, son épouse.102-2466, 2467 0426580-7.James Hamizidis.102-2468,2469 0426590-6.James Hamizidis.102-2470 Dimitrios Nikolinos.102-2471 0426600-3.Dimitrios Nikolinos.102-2472 Nick Demas.102-2473 0426610-2.Nick Demas.102-2474 à 2476 0426790-2.Spathodia Land Corp.102-2519 à 2521 0427060-9.Dimitrius Kokkonis.102-2578, 2579 0427070-8.Dimitrius Kokkonis.102-2580, 2581 0427110-2.John Manousos.102-2588,2589 0427120-1.Spartakos Inc.102-2590,2591 0427130-0.Spartakos Inc.102-2592, 2593 0427400-7.Dame Elpina Mavridou, et Karnik Kekedjian, son époux.102-2646, 2647 0427510-3.Dimitrius Kokkonis.102-2670 a 2672 0427550-9.Krikor Migirditsian.102-2680,2681 0427570-7.Krikor Migirditsian.102-2684,2685 0427810-7.Anna Papavasilou.102-2735,2736 0427900-6.Dame Roussa Kakoyiannakis veuve Georges Frangedakis, Dame Helene 102-2754 Kakoyiannakis veuve Manousos Grigorakis, Nicholas, Ilias, Antonias, Guy, Angelo Kakoyiannakis, Emmanuel, Ioannis et Anthony Panayo-takis, 0427910-5.Dame Roussa Kakoyiannakis veuve Georges Frangedakis, Dame Helene 102-2755, 2756 Kakoyiannakis veuve Manousos Grigorakis, Nicholas, Ilias, Antonias, Guy, Angelo Kakoyiannakis, Emmanuel, Ioannis et Anthony Panayo-takis 0428070-7.Serge Fouchet.102-2842 à 2844 0428240-6.Hans Bachmann.102-2881 à 2883 0428260-4.Hermann Krehmer.102-2887 à 2889 0428390-9.Anton Vogel.102-2918 0428400-6.Anton Vogel.102-2919, 2920 0428480-8.Moses Dallafiora.102-2935 0428490-7.Moses Dallafiora.102-2936,2937 0428750-4.Jacques V.Legendre.102-2991,2992 0428760-3.Jacques V.Legendre.102-2993 0428830-1.Peter et Evangelos Kanatselis.102-3006 0428880-9.Peter & Evangelos Kanatselis.102-3015 à 3017 0428930-2.Peter Kupcis.102-3027 à 3029 0429280-1.Dimitros Asimakopoulos.102-3104,3105 0429330-4.John Petropoulos.102-3112 à 3114 0429430-2.George Cairis.102-3132, 3133 0429440-1.Georgia Athanasopoulou.102-3134,3135 0429450-0.Nikolaos Athanasoooulos.102-3136,3137 0429590-3.Christina & Efie Panagiotopoulou.102-3166, 3167 0429630-7.Gabriel Brinias, et George Galiatsatos.102-3175,3176 0429780-0.JohnTarris.102-3208,3209 0429810-5.Maniatis Euagelos.102-3214,3215 0429820-4.Dame Roussa Kakoyiannakis veuve Georges Frangedakis.Dame Helene 102-3216 à 3218 Kakoyiannakis veuve Manousos Grigorakis, Nicholas, Ilias, Antonias.Guy, Angelo Kakoyannakis, Emmanuel, Ioannis et Anthony Panayo- takis.0429900-1.Kostas Daras.102-3234 à 3237 0429910-3.Kostas Daras.102-3239 à 3242 0430420-0.Dame Fanny Kandris, épouse Elie Papadopoulos.102-3396, 3397 0430430-9.Dame Fanny Kandris, épouse Elie Papadopoulos.102-3398.3399 0430450-7.Aristomenis Psalidas, et Dame Angelika Stefatou, son épouse.102-3402, 3403 0430480-4.Nikolaos Mikalef.102-3408, 3409 0430510-8.Thoynell A.Kennedy.102-3414 à 3416 0430610-6.Georgia Hronopoulou.102-3436,3437 0430920-9.Spartakos Inc.102-3510,3511 0431070-2.Aida Construction Inc.102-3541,3542 0431080-1.Aida Construction Inc.102-3543,3544 0431090-0.Aida Construction Inc.102-3545 à 3547 0431290-6.Robert Paquin.102-3597,3598 0431810-1.Armand Doyon.102-3710,3711 0431840-8.James Putnaerglis.102-3714 à 3716 0432030-5.Urban Homes Inc.102-3764-1,3765-1,3766-1 et 3767-1 0432050-3.Dame Eva Debroux, veuve Léon Ernaelsteen.102-3768 à 3770 0432410-9.Konstantinos Adamopoulos.102-3818 0432470-3.Charalambos Stefanopoulos et Dame Diamanto Efthymiou, son épouse.102-3824 3116 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, April 27, 197i, Vol.100, No.17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 04.12670-8.0435150-8.Joseph R.Matte.Dame Marguerite Cormier veuve Walter Kanters 102-3849 103-77 A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part cxpropr ated by de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au ment of Roads of the Province of Québecunaer the terms of the bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numé- deeds registered in the County of Chambly Registry Office ros 273854 et 316735.under numbers 273854 and dlb/Jo.0435630-9.0436480-8.0436580-5.0436610-0.0436660-5.0436700-9.0436710-8.0437340-3.0437350-2.0437360-1.0437370-0.0437390-8.0437420-3.104-569 104-570 104-571 104-572 104-574 104-577 James Tindley.int^c* City & District Development Inc.ina i17 11a City & District Development Inc.inl loi' lia City & District Development Inc.J\"1 Madeleine Gagnon.XHS*1M RenéBarkley.\"J*\" « , .RenéBarkley.\\0*~\\fQ à 146 Panagiotis Kfthimiou.Panagiotis Efthimiou.\u2022.CharalambosStefanopoulos et Dame Diamanto Efthymiou, son épouse.Dame Vasiliki Brinias.et Dimitrios Kourembes, son époux.Dame Vasiliki Brinias, et Dimitrios Kourembes.son époux.-\u2022 Dame Lousin Mardikian veuve Parsegh Kekedjian.et Succession Parsegh Kekedjian.Dame Smaragdi Tsangarsouli et I.eonidas Evangelou, son époux.Leonidas Evangelou.Leonidas Evangelou.Spartakos Inc.Spartakos Inc.Spartakos Inc.Miltiades Tembelia.Miltiades Tembelis.Mike Ntovas, et James Ntovaa.Mike Ntovas, James Ntovas et Bill Tassaras.Mike Ntovas, James Ntovas et Bill Tassaras.Steve Demosthenis.Steve Demosthenis.Steve Demosthenis.Miltiades Tembelis.0437640-6.0487080-6.0437690-1.0438410-3.0438420-2.0438430-1.0438850-0.0488880-0.0439100-9.0439110-8.0439120-7.0439600-8.0439610-7.0439620-6.0439730-3.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 331276 et 383324.0439740-2.Miltiades Tembelis.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 331275 et 383324.104-602 104-603 104-607 104-674 104-675 104-676 104-722 104-723 104-738 104-739 104-740 .104-779 .104-780 .104-781 .104-792 Less and to withdraw the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Quebec under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 331275 and 383324.104-793 Less and to withdraw the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 331275 and 383324.0439750-1.Vasilios Aravanis.et Dame Irini Poulou.son épouse.104-794 A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of the bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numé- deeds registered in the County of Chambly Registry Office ros 331275 et 353180.under numbers 331275 and 353180.0139.XMI 6 0439890-5.0439970-5.0439980-4.0440020-6.0440030-5.0440040-1.0440050-3.0440090-9.044010(1 li.0440110-5.0440140-2.0440150-1.0440170-9.0440250-9.0440260-8.0440270-7.0440280-6.044040O-0.Dame Angela Kontobassi, Peter Servetis.son époux et Peter Thcofilis.Dame Angela Kontobassi.Peter Servetis.son époux, et Peter Theofilis.Spartakos Inc.Spartakos Inc.Spartakos Inc.Spartakos Inc.Spartakos Inc.Spartakos Inc.William Drosos.William Drosos.Zois Bricolas, In Trust.Spartakos Inc.[.Spartakos Inc.Vassilios Plaitis, In Trust.!!!!!!!!!!!! !\" ! Spartakos Inc.Spartakos Inc.Spartakos Inc.Spartakos Inc.I ! Dame Despina.Ntovas.épouse John Margonidou.'.'.104-813 104-814 104-822 104-823 104-827 104-828 104-829 104-830 104-834 104-835 104-836 104-839 104-840 104-842 104-850 104-851 104-852 104-853 104-857 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9.7 avril 197A, 106' année.n° 17 3117 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0440420-8.George Bricolas.0440430-7.George Bricolas.0440780-5.Dame Georgia Raftis, et James Kassimis, son époux.0440790-4.Dame Georgia Raftis, et James Kassimis, son époux.0440800-1.Dame Georgia Raftis.et James Kassimis, son époux.0441080-9.Dlle Sophie Kostios.0441850-5.Dame Helen Prazarakou, et Vasilios Tzanakos, son époux 0441980-0.Spathodia Land Corp.0442180-6.Athanasios Zontanos.0442190-5.Athanasios Zontanos.0442200-2.Athanasios Zontanos.0442210-1.Athanasios Zontanos.0442220-0.Athanasios Zontanos.0442250-7.Henri Bouchard.0442390-1.Theophilus D.Owusu.Une partie du lot 105-57 mesurant 25 pieds de largeur sur une profondeur de 120 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest, bornée en front au sud-est par le lot 105-62 (rue), en arrière au nord-ouest par partie du lot 105-35, d'un côté au nord-est par le lot 105-58, et de l'autre côté au sud-ouest par le résidu dudit lot 105-57.104-859 104-860 104-895 104-896 104-897 104-91G 105-5 105-18 105-35 105-36 105-37 105-38 105-39 105-42 A part of lot 105-57 measuring 25 feet in width by a depth of 120 feet in its northeast and southeast lines, bounded in front on the southeast by lot 105-62 (street), in the rear on the rear on the northwest by a part of lot 105-35, on one side on the northeast by lot 105-58, and on the other side on the southwest by the remainder of said lot 105-57.0443160-7.Leon Janssens Van Der Sande, es-qualité d'exécuteur-testamentaire de/ 105-135 in his capacity as testamentary executor to l'abbé Norbert Bras.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of bureau d'enregistrement du comté de Chamblv sous les numé- the deeds registered in the County of Chambly Registry under ros 331275 et 388971.numbers 331275 and 388971.0443170-6.Leon Janssens Van Der Sande.cs-qualité d'exécuteur-testamentaire de / 105-136 in his capacity as testamentary executor to l'abbé Norbert Bras.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of a bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro deed registered in the County of Chambly Registry Office 331275.under number 331275.0443960-0.Friedrick Ernst Kroemer.105-212 0444000-1.Ronald Williams.105-216 0444020-2.Alan Henry Wightman.105-218 0444030-1.Alan Henry Wightman.105-219 0444070-7.Ronald Williams.105-223 0444100-2.Friedrich E.Kroemer.105-226 0444110-1.Labrador Acceptance Corporation.105-228 0444120-0.Labrador Acceptance Corporation.105-229 0444430-3.Roland Rickenback.105-261 0444440-2.Roland Rickenback.105-262 0444450-1.Roland Rickenback.105-263 0444460-0.Roland Rickenback.105-264 0444470-9.Roland Rickenback.105-265 0444480-8.Gilles Label le.105-266 0444490-7.Gilles Labelle.105-267 0444500-3.Gilles Labelle.105-268 0444800-7.Albert Le Bihan.105-300 0444810-6.Albert Le Bihan.105-301 0444830-4.Albert Le Bihan.105-303 0444840-3.Albert Le Bihan.105-304 0444850-2.Albert Le Bihan.105-305 0444860-1.Al bert Le Bihan.105-306 0444870-0.Albert Le Bihan.105-307 0444890-8.Albert Le Bihan.105-309 0444900-5.Albert Le Bihan.105-310 0444910-1.Albert Le Bihan.105-311 0444920-3.Albert Le Bihan.105-312 0444950-0.Albert Le Bihan.105-315 0444960-9.Hans Bilger.105-316 0444970-8.Hans Bilger.105-317 0445070-6.Charles Husson.105-327 0445080-5.Charles Husson.105-328 0445110-0.Walter Jawornicki.105-331 0445130-8.Mme Micheline Poitras.105-333 0445150-6.JohnSchamel.105-335 0445160-5.JohnSchamel.105-336 3118 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 197i, Vol.106, Xo.17 Nom Description de l'immeuble Name Description of immoveable 0445170-4.0445310-6.04453S0-9.0445450-0.0445460-9.0445500-2.0445510-1.0445520-0.0460480-7.0460490-6.0460500-2.0460590-3.0400630-7.0461490-5.0473840-9.0464080-1.0464090-0.0464120-5.0464240-1.0464490-2.0464820-0.0464860-6.0464950-5.0465160-0.0465170-9.0465200-4.0465270-7.0465310-1.0465480-2.0465490-1.0465610-4.0465620-3.0465670-8.0465680-7.0465860-5.0465910-8.0466090-8.0466130-2.0466260-7.0466280-5.0466320-9.0466400-9.0466450-4.0466470-2.0466510-5.0466680-6.0466700-2.0466710-1.0467220-0.0467360-4.0467590-6.0467620-1.0467660-7.0467670-6.0467680-5.0467690-4.0467700-1.0468220-9.0468230-8.0468510-3.0468520-2.0468530-1.0468850-3.0468860-2.0468870-1.0468960-0.0468980-8.0469210-9.0469220-8.0469230-7.0469330-5.0469520-1.0469530-0.John Schamel.Egon Peter Dahlke.et Dame Inge Winkel, son épouse.Dlle Jeannine Bippus 105-337 105-350 105-357 Dlle Jeannine ISippus.So.Dame Norma Forbes, épouse Peter Klvever.JxEKw Dame Norma Forbes, épouse Peter Klvever- Anton Ingold.Dlle Muriel Roach.Dlle Muriel Roach.Theophilus D.Owuau.Eugene Gaudreau.Eugène Gaudreau.Spathodia Land Corp.Theophilus D.Owuau.Theophilus D.Owusu .Antonio A.Moutinho.- - ¦ Dame Eugène Roberts, épouse Isaac Pannycooke Dame Kugène Koherts.épouse Isaac I'annycooke Domenico Testa.Matteo Penta.Skerrett Douris.Dlle Cynthia Roach.Skerrett Douris.Skerrett Douris.Eric Ad- Llewellyn.Eric Adolphus Llewellyn.Cynthia Phillips.James Chin .Dlle Gloria Wong.Giovanni Serignese.Giovanni Serignese.Dlle Gloria Wong.M.Horace Moore.Canute Davis.Dame Jean Lynch, épouse Jean Baston.Earlwyn Ambrose.Joseph Farrugia.Charles Green.Dlle Elizabeth Morgan.Ashford à Winston Lewis.Dlle Rita Edwards.Eric A.Llewellyn.DU- Winifred Cockbum.Myrtle 4 Monica Holder.Myrtle it Monica Holder.AlanO I ckhrt.Antonio Pietro Monaco.Derrick Oswald Lewis.Derrick Oswald Lewis.Pine Land Corp.Steven Hershel Connell.Jose Ribeiro.Dlle Kerl Bacchus.Theodores Alevisos.Theodoros Alevisos.Theodores Alevisos.Theodoros Alevisos.Theodoros Alevisos.Evangelos Sideris.Evangelos Sideris .Daniel Skeete.Daniel Skeete.Daniel Skeete.Alfredo Nunes Santos.Alfredo Nunes Santos.Alfredo Nunes Santos.Gosford E.Brown.Gosford E.Brown.Antonio Da Silva.Antonio Da Silva.Antonio Da Silva.Marcus Boatswain.Manuel Jose Tavares.Manuel Jose Tavares .105-365 105-369 105-371 105-372 111-17 111-18, 19 111-20 à 22 111-37C, 37D 111-38 111-228 113-43, 44 113-95, 96 113-97, 98 113-104 à 106 113-130, 131 113-171, 172 113-245, 246 113-253, 254 113-272 113-316, 317 113-318 à 320 113-327.328 113-340 à 342 113-352, 353 113-390.391 113-392, 393 113-420.421 113-122 à 424 113-438 à 440 113-441 à 443 113-486 à 488 113-519 à 521 113-587, 588 113-596, 597 113-622 à 624 113-625 à 627 113-634 à 636 113-658 à 660 113-670 à 672 113-673.674 113-693 h 695 113-731 à 734 113-739, 740 113-741, 742 113-858 à 860 113-885 à 888 113-937, 938 113-943 à 945 113-952 a 954 113-965.956 113-957.958 113-959.960 113-961, 962 113-1079, 1080 113-1081, 1082 113-1138, 1139 113-1140, 1141 113-1142.1143 113-1206, 1207 113-1208, 1209 113-1210, 1211 113-1229 à 1231 113-1232, 1233 113-1286, 1287 113-1288.1289 113-1290, 1291 113-1311 a 1314 113-1363.1364 113-1365, 1366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 87 avril MA, 100- année, n° 17 3119 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0469540-9.0469600-1.0469780-1.0469820-5.0469850-2.0469860-1.0469870-0.0470200-7.0470210-6.0470220-5.0470230-4.0470490-4.0470590-1.0470600-8.0470610-7.0470670-1.0470680-0.0470710-5.0471100-8.0471120-6.0471130-5.0471230-3.0471240-2.0471670-0.0471680-9.0471690-8.0472330-0,.0472350-8.0472520-6.0472530-5.0472650-1.0473160-0 0473580-9.0473950-4.0474050-2.0474190-6.0474200-3.0474250-8.0474460-3.0474700-2.0475130-1.0475410-7.0475450-3.0475540-1.0475650-8.0475890-0.0475950-2.0476060-9.0476070-8.0476350-4.0476360-3.0476370-2.0476380-1.0476470-0.0476710-9.0476940-2.0476980-8.0477080-6.0477230-7.0477240-6.0477250-5.0477560-7.0477810-6.0477840-3.0478510-1.0478520-0.0478530-9.0478570-5.0478580-4.0490740-8.Manuel Jose Tavares.Dame Thelma Williams, épouse John Huggins.Antonio Perdigao.Dame Clara Richard Quevillon, veuve G.Alfred Quevillon.Jean & Fernand Néron.William Walsh.George Cumberbath.John Raviolos.Marc André Croteau.Edwin E.Denton.Edwin E.Denton.Dame Mary Margaret Littlejohn épouse Ernest Douris- George Spithourakis.George Spithourakis.George Spithourakis.John Barry.Raymond Millar.William Goldberg .Dame Kataryna Sondej, et Stanislaw Grzeszczyk, son époux.Dame Kataryna Sondej.et Stanislaw Grzeszczyk son époux.Dame Kataryna Sondej.et Stanislaw Grzeszczyk, son époux.John Markopoulos.John Markopoulos.Evangelos Kavoukis.Evangelos Kavoukis.Evangelos Kavoukis.Efthyhios Kirbizakis.Wasily Twerdowsky.Paul Hrynewych.Paul Hrynewych.George Giannoulakis.Paweï Gerasimow.Frank Allen.Dame Niki Massoura-Dritsas.Otto Bauer.Elie Papadopoulos.Elie Papadopoulos.Kostas Papageorgacopoulos.Trevor Spence.Dame Barbara Jeromska, et Anthony Malyszko, son époux.Elie Papadopoulos.Mike Novak.Douris Skerrett.Pine Land Corp.Friedhelm Bunte.Ernst Damian.Walter Jawornicki.Chandra Bahn Singh Senger.Chandra Bahn Singh Senger.Dame Janina Wronska, et Tomasz Drabek, son époux.Dame Janina Wronska, et Tomasz Drabek, son époux.Dame Janina Wronska, et Tomasz Drabek, son époux.Dame Janina Wronska, et Tomasz Drabek, son époux.Jadwiea Gajewski.J.Philipe De Figueredo.John Nagy.Albert Gaudreau.Dame Lizzie ('hoquette, veuve Joseph Simoneau.Herbert Tanaka.John Velischek.Antonio Silva, et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos Roméo Lareau.Dame Elizabeth Howlett.veuve Matthew J.Birdwhistle, et Dame Margaret Morey épouse Frank Kearns Le Procureur Général de la Province de Québec.Josef Rakoczy, et le Shérif de Montréal.Josef Rakoczy, et le Shérif de Montréal.Josef Rakoczy, et le Shérif de Montréal.Josef Rakoczy, et le Shérif de Montréal.Josef Rakoczy.et le Shérif de Montréal.Nicola Kulyk.113-1367,1368 113-1388 a 1391 113-1431, 1432, 1432A, 1432B 113-1440, 1441 113-1444 113-1445 à 1447 113-1448, 1449 113-1535 à 1537 113-1538.1539 113-1540, 1541 113-1542, 1543 113-1599, 1600 113-1621, 1622 113-1623, 1624 113-1625 à 1627 113-1641 113-1642 113-1644.1645 114-23.24 114-25, 26 114-27, 28 114-45 à 47 114-48, 49 114-142 à 144 114-145, 146 114-147 à 149 114-283 à 285 114-288, 289 114-329, 330 114-331, 332 114-356 à 358 114-460, 461 114-553 à 555 114-630 à 632 114-653, 654 114-684, 685 114-686, 687 114-696.697 114-743 à 745 114-803 à 805 114-897 à 899 114-965 à 967 114-975 à 977 114-996 114-1020 à 1022 114-1085 à 1087 114-1099, 1100 114-1136, 1137 114-1138.1139 114-1199, 1200 114-1201, 1202 114-1203, 1204 114-1205, 1206 114-1226 & 1228 114-1278 à 1280 114-1329, 1330 114-1338 114-1359 114-1390, 1391 114-1392.1393 114-1394 114-1464 114-1517 114-1521 à 1523 115-4 et 15 115-5.6 115-7.8 115-13.14 115-16, 17 118-102, 103 312(1 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 27.1971.\u2022Yo- 17 Folio Nom Name 0490750-7.0490870-3.0490880-2.0491020-4.0491030-3.0491040-2.0491050-1.0491190-5.0491250-7.Nicola Kulyk.Philippe Genest.Philippe Genest.Intermundo Investments Ltd.Intermundo Investments Ltd.Intermundo Investments Ltd.Intermundo Investments Ltd.Dlle Anna Kalouta.Dame Mary Margaret Littlejohn épouse Robert Douris 0491320-8.Antonio Silva.ct Dame Dionyssia Vythoulka.épouse Alfredo Nunes 0491330-7.AnStonio'silva, ct Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes 0491340-6.Antonio'silva, et Dame Dionyssia Vythoulka.épouse Alfredo Nunes 0491410-7.Dlle Gloria Prescod, et Dame Ernie Butcher épouse Elias Prescod.0491620-1.Dame Madore Willis, épouse Arnold White, et Arnold White .\u2022 0491630-0.Henri Demers.faisant affaires seul sous le nom et raison sociale at ¦ 2-B-5 Enrg.» 0491640-9.Park Plaza Garden Corp.0491650-8.Park Plaza Gardens Corp.-.\u2022\u2022\u2022 \u2022\u2022¦ y.- 0491680-5.Dame Rhoda Steinman, épouse Michael Cohen, Dame Gloria bimon épouse Morton Steinman et Dame Lilian Harris épouse Edward Steinman ._.0491090-4.Dame Rhoda Steinman épouse Michael Cohen, Dame Gloria Simon épouse Morton Steinman et Dame Lilian Harris épouse Edward Steinman 0491700-1.Dame Rhoda Steinman épouse Michael Cohen, Dame Gloria Simon épouse Morton Steinman et Dame Lilian Harris épouse Edward Steinman 0491820-7.Alexandre Polkovnikow.0491830-6.Alexandre Polkovnikow.0492040-1.Dame Antonie Hols alias Dame Antonia Holz veuve Iwan Lagutin .0492050-0.Dame Antonie Hols alias Dame Antonia Holz veuve Iwan Lagutin .0492060-9.Dame Antonie Hols alias Dame Antonia Holz veuve Iwan Lagutin- 0492140-9.Darnell Francis Mayers.0492150-8.Darnel 1 Francis Mayers.049221'id 5 Dame Gaétaiie Durand, épouse Maurice f'arpenlier .0492270-4.Dame Gaétane Durand, épouse Maurice Carpentier.0493230-7.Juan Diaz.0493240-6 Isidore Navarro.0493570-6.Santos Investment Corp.0493830-4.Santos Investment Corp.0404120-9 Joseph Sproson, et Dame Ethel Green, son épouse.0494330-4 Henri Demers, faisant affaires seul sous les nom et raison sociale de t 2-B-5 Enrg.» 0494440-1.Edward Edwardson.0494450-0.Edward Edwardson.0494570-5.Henri Demers, faisant affaires seul sous les noms et raison sociale de « 2-B-5 Enrg.» 0494010-9.Santos Investment Corp.0194710-7.Francis Earl Magee.0494810-5.Eugenie Windier.0495020-0.Santos Investment Corp.0405060-0.Viateur Levasaeur.0495680-1.Santos Investment Corp.0495700-7.Santos Investment Corp.0496150-4.Dame Theoda Marcil.veuve Hector Lavoie.0400260-1.Tadeusz Chmielewski.0496270-0.Tadeusz Chmielewski.°JS£5n2game Helen Sudol.épouse Tadeusz Chmielewski.0-8.Dame Helen Sudoj.épouse Tadeusz Chmielewski.0496330-2 0496360-9 0490820 2 0496870-7 0497020-8 0497030-7 n iorî™~?,Dame Hele\" Sudo1' éP°\"se Tadeusz Chmielewski ! Victor KolefT.Stephan Piwowarczyk.Santos Investment Corp.Santos Investment Corp.et Benjamin Treiser .Walter Jawornicki.Ignacy Jawornicki.sSSSSri.Santos Investment Corp.£?Js£2~?Santos Investment Corp.M97390-6.Walter Jawornicki.0497420-0.Hartley Williams.Description de l'immeuble Description of immoveable 118-104, 105 118-132, 133 118-134, 135 118-171.172 118-173.174 118-175.176 118-177.178 118-199 118-205 118-211 118-212 118-213 118-220 à 222 118-248 118-249 118-250 118-251 118-254 118-255 118-256 118-274 118-275 118-297 118-298 118-299 118-309 118-310 118-321 118-322 118-424 118-425 119-67.68 119-130 119-196, 197 119-239 119-261.262 119-263 à 265 119-291 à 293 119-299 a 302 119-317 à 319 119-340, 341 119-389 119-396 à 398 119-528 119-532 119-632 à 634 119-656.657 119-658 ,659 119-660.661 119-662.663 119-664.665 119-670 à 674 119-679, 680 119-779 119-789 119-820.821 119-822 fl 824 119-880 119-891 119-899, 900 119-905 à 907 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1971.106' année, n° 17 3121 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0497610-6.Dame Eugene Windier.119-948, 949 0497640-3.Dame Mabel A.Williams Barnes épouse Ernest Barnes.119-956 à 958 0497740-1.Spathodia Land Corp.119-977, 978 0497810-2.Santos Investment Corp.119-999 0497880-5.Nick Orfanos et Georges Orfanos.119-1024, 1025 0498100-7.William J.Harris.119-1070,1071 0498240-1.Ivan Chmelevski.119-1117,1118 0498310-2.Fred Wm Chs Rowe.119-1133.1134 0498350-8.Alexander Osier.119-1142 à 1145 0498460-5.Antonio Silva, et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes 119-1169 à 1171 Santos.0498500-8.Dlle Gilberte Lajoie.119-1176 à 1178 0499130-3.Dlle Athanasia Sarantaki.119-1321,1322 0499140-2.Dlle Athanasia Sarantaki.119-1323,1324 0499150-1.Dlle Athanasia Sarantaki.119-1325,1326 0500070-8.Stephen Falkland.120-8 0500080-7.Stephen Falkland.120-9 0500090-6.Stephen Falkland.120-10 0500110-2.Stephen Falkland.120-12 0500120-1.Stephen Falkland.120-13 0500130-0.Stephen Falkland.120-14 0500140-9.Stephen Falkland.120-15 0500400-7.Eva Gold.120-47 0500410-6.Eva Gold.120-48 0500420-5.Eva Gold.120-49 0500440-3.Bessie Levitt.120-51 0500460-1.Dame Molly Flanz, veuve Saul Harry Goldberg, personnellement et In 120-53 Trust pour Joel Goldberg.0500470-0.Dame Molly Flanz, veuve Saul Harry Goldberg, personnellement et In 120-54 Trust pour Joel Goldberg.0500540-0.Bessie Levitt.120-61 0500550-9.Bessie Levitt.120-62 0500560-8.Jean Leduc.120-63 0500710-9.Eva Gold.120-78 0500720-8.Eva Gold.120-79 0500750-5.Alexander Tchebykine.120-82 0500940-2.Alexander Tchebykine.120-101 0501050-9.Alexander Tchebykine.120-112 0501210-9.Eugenie Windier.120-128 0501260-4.Basilios Peteros.Dimitrios Peteros et Spiros Peteros.120-133 0501270-3.Basilios Peteros, Dimitrios Peteros et Spiros Peteros.120-134 0501280-2.Basilios Peteros, Dimitrios Peteros et Spiros Peteros.120-135 0501290-1.Basilios Peteros.Dimitrios Peteros et Spiros Peteros.120-136 0501300-8.Emile Steiner.120-137 0501550-8.Jerzv Krzeczunowicz.120-174 0501870-0.Moulton Holdings (Québec) Ltd.120-226 0501890-8.Alexander Tchebykine.120-227 0501910-1.Alexander Tchebykine.120-228 0501990-6.Jerzy Krzeczunowicz.120-233.234 0502000-3.Jerzy Krzeczunowicz.120-235 0502010-2.Jerzy Krzeczunowicz.120-236,237 0502020-1.Jerzy Krzeczunowicz.120-238,239 O502O30-O.Jerzy Krzeczunowicz.120-240 à 242 0502100-1.Andrew Czinke.120-254 0502110-0.Andrew Czinke.120-255 0502180-3.Alexander Tchebykine.120-262 0502190-2.Austin L.Letran.120-263 0502230-6.Dlle Bella Levitt.120-267 0502240-5.Dlle Bella Levitt.120-268 0502250-4.Dlle Bella Levitt.120-269 0502390-8.Andrew J.Walton.120-280 0502410-4.Andrew J.Walton.120-281 0502480-7.Jerzv Krzeczunowicz.120-285 0502540-8.Jerzy Krzeczunowicz.120-296,297 0502550-7.Jerzy Krzeczunowicz.120-298,299 0502560-6.Jerzy Krzeczunowicz.120-300,301 0502570-5.Jerzy Krzeczunowicz.120-302,303 0502580-4.Jerzy Krzeczunowicz.120-304,305 0502670-3.Alexander Tchebykine.120-314 0502680-2.Alexander Tchebykine.120-315 0502810-5.Homer Augustine.120-328 0502890-7.Alexander Tchebykine.120-333 0503290-9.Dlle Lynette Eversley.120-373 Folio QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 27.197A, Vol.IPG.So.17___ Description of immoveable 0503310-5.DI le Cïslyn Spence.0503320-4.Dlle Cislyn Spence.0503330-3.Dlle Cislyn Spence.0508690-0.Dame Margaret Clark, épouse George Whelan 0503980-5.Bohdan Lawruk.0503090-4.Andrew Czinke.0504120-7.Dennis E.Dublin.0504140-5.Dennis E.Dublin.0604180-1.Aurelio Gomez.0504240-3.Jerzy Krzeczunowicz.0504250-2.Jerzy Krzeczunowicz.0504260-1.Jerzy Krzeczunowicz.0504400-3.Efstathios Panagiotopoulos.0504410-2.Walter Jaworniki.Une partie du lot 120-453 mesurant 50 pieds de largeur sur une profondeur de 100 pieds, bornée en front par un boulevard proposé, en arrière par le lot 119 ou ses subdivisions, d'un côté par le lot 120-452, et de l'autre côté par le résidu dudit lot 120-453.120-375 120-376 120-377 120-407 120-429 120-430 120-437 120-438 120-140 120-443 120-444 120-445 120-152 A part of lot 120-453 measuring 50 feet in width by 100 feet in depth, bounded in front by a proposed boulevard, in the rear by lot 119 or its subdivisions, on one side by lot 120-452, and on the other by the remainder of said lot 120-453.0504420-1.Albert McGee.La moitié sud-ouest du lot 120-453 mesurant 50 pieds de largeur par une profondeur de 120 pieds, bornée en front par une rue proposée, en arrière par le lot 119 ou ses subdivisions, d'un côté par le lot 120-454.et de l'autre côté par le résidu dudit lot 120-453.The southwest half of lot 120-453 measuring 50 feet in width by 120 feet in depth, bounded in front by a proposed street, in the rear by lot 119 or its subdivisions, on one side by lot 120-454, and on the other by the remainder of said lot 120-453.0504700-6.Gilles Henry Musynowicz alias Nash.0504710-5.Richard Dobson.0538770-9.Dlle Matina Karadiakos.0538780-8.Dlle Matina Karadiakos.0538790-7 Dionisios Tsouhlakis.0638800-8.Nicholas Douvros, et Nick Landouris.0538880-0.Miltiades Kosti, et Dame Chrysoula Arabatsidis, son épouse.0538920-0.Dame Helen Kantaros, épouse George Karalis.0538970-5.Chris Papas.0539130-5.Sharon Lins.0539170-1.Dimitrios Floros et Dame Fratzeska Konstantakis, son épouse.0539180-0.Dimitrios Floros et Dame Fratzeska Konstantakis, son épouse.0539190-9.Anyonios Vandoulakis.0539200-6.Anyonios Vandoulakis.0539240-2.Sharon Lins.0539250-1.Evangelina Nikrogianakis.0539260-0.Tommy Destounis.0539270-9.Emmanuel Fragedis, et Dame Argyro Kampourakis.0539300-4.Evangelos Papapostolou et Dame Koula Vergeraki son épouse.0539310-3.Evangelos Papapostolou et Dame Koula Vergeraki son épouse.0539440-8.Constantin Charalainbous.0539030-4.Christos Karavanopoulos.0539640-3.Christ03 Karayanopoulos.0539700-5.Dimitrios Kissis.0539880-5.Konstantinos Katouni, et Dame Helen Riga, son épouse.0539890-4.Konstantinos Katouni, et Dame Helen Riga, son épouse.0539910-0.JohnTzakas.0539950-6.George Pavlakos et George Koutros.0510240-9.Demetrios G.Seretis.0540330-8.George Koukounas, Dlle Georgia Koukounas et Dlle Christina Koukounas.0540340-7.George Koukounas, Dlle Georgia Koukounas, et Dlle Christina Koukounas.0540350-6.George Koukounas, Dlle Georgia Koukounas et Dlle Christina Koukounas, 0540760-6.Dimitrios Eftathioy.0540890-1.Rena Haralampous.0541060-0.George Pavlakos, et George Koutros.0541070-9.George Pavlakos, et George Koutros.0541180-6.Nikolaos Tsatsaronis.A distraire la partie expropriée par la Ville de St-Hubert aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du 120-16S 120-468A 131-6 131-7 131-8 131-18 131-20 131-24 131-30, 31 131-50 131-54 131-55.56 131-57, 58 131-59 131-63 131-64 131-65 131-66 131-71, 72 131-73 131-88 131-110 131-111.112 131-119 131-140, 141 131-142, 143 131-145 131-149 131-184.185 131-196 131-197 131-198 comté de Chambly sous le numéro 392170.131-249 .131-265 .131-282 .131-283, 284 .131-296 To withdraw the part expropriated by the City of St.Hubert under the terms of a registered in the Registry Office of the County of Chambly under number 392170.0541190-5 City & District Development Inc.131-298 Nom Description de l'immeuble Same GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n' 17 3123 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable A distraire la partie expropriée par la Ville de St-Hubert aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 392170.To withdraw the part expropriated by the City of St.Hubert under the terms of a registered in the Registry Office of the County of Chambly under number 392170.0541200-2.NickTanouris.131-299 0541210-1.NickTanouris.131-300 0541220-0.Nick Tanouris.131-301 0541240-8.Bill Tsioubris.131-303 0541280-4.Constantinos Loverdos, et Matina Nikolakakou.131-307 0541290-3.Constantinos Loverdos, et Matina Nikolakakou.131-308,309 0541300-0.Constantinos Loverdos, et Matina Nikolakakou.131-310,311 0541310-9.Constantinos Loverdos, et Matina Nikolakakou.131-312 0541370-3.Heleni Tanouris.131-318 0541500-5.Constantin Charalambous.131-333 0543190-3.Kostas & Angelo Pateras.132-103 0543200-0.Kostas & Angelo Pateras.132-104 0543280-2.Dlle Fannie V.Vardoulis.132-112 0543790-0.George Kumpuris et Dame Bessie Colovos.son épouse.132-167 0543800-7.George Kumpuris et Dame Bessie Colovos, son épouse.132-168 0544690-1.Bill Karamitsos, Angelos Ghikas et Vasilios Karamitsos.Une partie du lot 133-89 mesurant 25 pieds de largeur sur A part of lot 133-89 measuring 25 feet in width by 125 feet une profondeur de 125 pieds, bornée en front par le Chemin in depth, bounded in front by Chambly Road, in the rear and Chambly, en arrière et d'un côté par le résidu dudit lot 133-89, on one side by the remainder of said lot 133-89, and on the et de l'autre côté par partie du lot 133-88.other side by part of lot 133-88.Emmanuel Coofakis, et Amalia Coofakis.Emmanuel Coofakis, et Amalia Coofakis.Frank Browman.William Grozier.Thomas Georgiou.0545760-1.0545770-0.0546480-5.0548650-1.0548780-6.Une partie du lot 134-9 mesurant 50 pieds de largeur sur une profondeur de 100 pieds, bornée en front par la rue Adelaide, en arrière par le lot 133 ou ses subdivisions, d'un côté par le lot 134-8 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 134-9.0549800-1.Doris Demers.A distraire la partie vendue à Joseph André Levy aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 257389.133-210, 211 133-212, 213 133-298, 299 133-536 A part of lot 134-9 measuring 50 feet in width by 100 feet in depth, bounded in front by Adelaide Street, in the rear by lot 133 or its subdivisions, on one side by lot 134-8 and on the other by side the remainder of said lot 134-9.134-69 To withdraw the part sold to Joseph Levy under the terms of a deed of sale registered in the Registry Office of the County of Chambly under number 257389.0550560-7.Nicolaos Spyropoulos.A distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 325750 et 337981.134-130, 131 To withdraw from these lots the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 325750 and 337981.0550570-6.Nicolaos Spyropoulos.A distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 325750 et 337981.134-132, 133 To withdraw from these lots the part expropriated by the Roads Department of the Province of Quebec under the terms of the deeds registered County of Chambly Registry Office under numbers 325750 and 337981.0551080-5.George Balafoutis.0551250-4.Leonard Libitz.0553240-3.Norman Devoe.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 325750 et 346603.134-183 .134-199, 200 .134-1-101 To withdraw the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec under the terms of the registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 325750 and 346603.0553380-7.Flamingo Construction Inc.134-1-119 0553390-6.Flamingo Construction Inc.134-1-120 0553400-3.Flamingo Construction Inc.134-1-121 0553410-2.Flamingo Construction Inc.134-1-122 0553420-1.Flamingo Construction Inc.134-1-123 0553430-0.Flamingo Construction Inc.134-1-124 0553450-8.Athanasia Sarantaki.134-1-126 0553470-6.Konstantinos Tzamouranis.134-1-128 0553740-2.Patrick Casey.134-1-160,161 0554040-6.Perry Economides.134-1-194 0554580-1.City & District Development Inc.134-1-258 3124 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.100, No.17 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0554620-5.Les commissaires d'école de la municipalité de St-Hubert, comté de Chambly / The School Commissioners for the Municipality of St.Hubert, in the County of Chambly.Les commissaires d'école de la municipalité de St-Hubert.comté de Chambly/The School Commissioners for the Municipality of St.Hubert, in the County of Chambly.0554640-3.Les commissaires d'école de la municipalité de St-Hubert, comté de Chambly / The School Commissioners for the Municipality of St.Hubert, in the County of Chambly.Les commissaires d'école de la municipalité de St-Hubert, comté de Chambly/The School Commissioners for the Municipality of St.Hubert,\"in the County of Chambly.Dimitrios Roumeliotis.Dimitrios Roumeliotis.George Lambrinos.George Lambrinos.Dame Vasiliki Dukaki.épouse Costantinos Papanikolaou.Dame Stavroula Papanikolaou épouse Loukas Diavatis.Roger Fettu.Roger Fettu.Jacovos Dumakis.Jaeovos Dumakis.James Francis Roberts.Henry Wenz.Henry Wenz.Panajiotis Sarikas.Henry Wenz.Douglas Millichamp, Ernest Millichamp et Georges Lafontaine.A distraire la partie nord-est vendue à Wilfrid Duncum aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 180539.0554630-4.0554650-2.05547U0 5 0554710-4 0554770-8 O5547S0-7 0555070-2 0555080-1 0555320-1 0555330-0 05558SO-4.0555890-3 0556450-5.0556490-1.0556500-7.0556690-6.0556710-2.0559080-7.134-1-262 134-1-263 134-1-264 134-1-265 134-1-276 134-1-277 134-1-283 134-1-284 134-1-316 134-1-317 134-1-344 134-1-345 134-1-409 134-1-410 134-1-462 134-1-466 134-1-467 134-1-488 134-1-490 135-154 To withdraw the northeast part sold to Wilfrid Duncum under the terms of a deed of sale registered in the County of Chambly Registry Office under number 180539.0563990-1.0564000-8.0564050-3.0565970-1.0571870-5.0574180-6.0579390-6.0579640-4.0579780-8.0579810-3.0579820-2.0580090-9.0580100-6.0583990-7.0584000-4.0584010-3.0584020-2.0584030-1.0584040-0.0584050-9.0584060-8.0584070-7.0584080-6.0548090-5.0584100-2.0584110-1.0584120-0.0584130-9.0548140-8.0584150-7.0584160-6.0584170-5.0584180-4.0584190-3.0584200-0.0584210-9.0584220-8.0584230-7.0584240-6.George Papoutsis.George Papoutsis.Frank Handler.Myer Block.In Trust.Paul Larose.Jardins St-Hubert Inc.Pine Land Corp.Waclaw Lubczunski.Dymitr Sniezyk.Jean Tomaszewicz.Jean Tomaszewicz.Dame Felicia Gajewska épouse Jozef Swiatek, et Dame Stefania Ga-jewska épouse Tadeusz Bialachowski.Dame Felicia Gajewska épouse Jozef Swiatek, et Dame Stefania Gajewska épouse Tadeusz Bialachowski.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.]][.[[.[ .\\.[.[[ Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.¦¦-.¦.[.[.[.[ Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.136-570 136-571 136-581 136-1027.1028 143-223 143-535 147-127 147-152 147-166 147-169 147-170 147-204 147-205 152-1 à 4 152-6, 7 152-8.9 152-10, 11 152-12, 13 152-14, 15 152-16, 17 152-18, 19 152-20.21 152-22, 23 152-24, 25 152-26, 27 152-28, 29 152-30, 31 152-32, 33 152-34, 35 152'-36, 37 152-38, 39 152-40, 41 152-43, 44 152-45.46 152-47, 48 152-49, 50 152-51.52 152-53, 54 152-55, 56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 197!,, 106' année.n° 17 3125 Folio Nom Same Description de l'immeuble Description of immoveable 0584250-5.Mercury Realties Inc.0584260-4.Mercury Realties Inc.0584270-3.Dame Julia Annie Sweetman veuve William Sydney Shelton Matthews.0584280-2.Dame Julia Annie Sweetman veuve William Sydney Shelton Matthews.0584290-1.Dame Julia Annie Sweetman veuve William Sydney Shelton Matthews.0584300-8.Mercury Realties Inc.0584310-7.Mercury Realties Inc.0584320-6.Mercury Realties Inc.0584330-5.Mercury Realties Inc.0584340-4.Mercury Realties Inc.0584360-2.Mercury Realties Inc.0584370-1.Mereurv Realties Inc.\u2022.0584380-0.Dame Beverly El va Wallace é[>ouse Philip Herbert Barnes Obendorf .0584400-6.Mercury Realties Inc.0584410-5.Mercury Realties Inc.0584430-3.Mercury Realties Inc.0584450-1.Mercury Realties Inc.0584460-0.Mercury Realties Inc.0584470-9.Mercury Realties Inc.0584480-8.Mercury Realties Inc.0584490-7.Mercury Realties Inc.0584520-1.Mercury Realties Inc.0584530-0.Mercury Realties Inc.A distraire des lots 152-110 et 111 la partie expropriée parle ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 316527 et 365817.152-57.58 152-59.60 152-61, 62 152-63.64 152-65.66 152-67,68 152-69.70 152-71, 72 152-73.74 152-75, 76 152-80.81 152-82, 83 152-84 152-86 .152-87.88 .152-91,92 .152-95, 96 .152-97, 98 .152-99, 100 .152-101.102 .152-103.104 .152-107.108 .152-109 4 111 To withdraw from lots 152-110 and 111 the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec according to the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 316527 and 365817.0584550-8.0584560-7.0584570-6.0584580-5.0584590-4.0584600-1.0584610-0.0584620-9.0584630-8.0584640-7.0584650-6.0584660-5.0584670-4.0584680-3.0584690-2.0584700-9.0584710-8.0584720-7.0584730-6.0.584740-5.0584750-1.0584760-3.0584770-2.0584780-1.0584790-0.0584800-7.0584810-6.0584820-5.0584830-4.0584840-3.0584850-2.0584860-1.0584870-0.0584880-9.0584890-8.0584900-5.0584910-4.0584920-3.0584930-2.05S4940-1.0584950-0.0584960-9.0584970-R.0584990-6.0585000-3.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.William Ewing.William Ewing.William Ewing.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.152 152 152 152-152 152 152-152 152 152-152-152-152-152-152-152-152-152-152-152-152-152 152-152-152-152 152 152-152-152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 124 ft 126 127.128 130.131 132.133 134.135 136.137 138, 139 140,141 142, 143 144.145 146, 147 148, 149 150.151 152.153 154.155 156.15\" 158.159 160, 161 162, 163 164,165 166, 167 \u2022168.169 ¦170.171 172, 173 174,175 176.177 ITS.179 ISO.1M \u2022182, 183 \u2022184, 185 186, 187 188,189 190.191 192.193 -194.195 196, 197 -198, 199 -200, 201 ¦203, 204 205, 206 -207, 20S 209, 210 211.212 -215, 216 217, 218 3126 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Folio Nom Same Description de l'immeuble Description of immoveable 0585010-2.\tMercury\tRealties\tInc.0585020-1.\tMercury\tRealties\tInc.0585030-0.\tMercury\tRealties\tInc.0585040-9.\tMercury\tRealties\tInc.0585050-8.\tMercury\tRealties\tInc.0585070-6.\tMercury\tRealties\tInc.0585080-5.\tMercury\tRealties\tInc.0585100-1.\tMercury\tRealties\tInc.0535110-0.\tMercurj\tRealties\tInc.0585120-9.\tMercury\tRealties\tInc.0585130-8.\tMercury\tRealties\tInc.0585140-7.\tMercury\tRealties\tInc.0585150-6.\tMercury\tRealties\tInc.0585160-5.\tMercury\tRealties\tInc.0585170-4.\tMercury\tRealties\tInc.0585180-3.\tMercury\tRealties\tInc.0585190-2.\tMercury\tRealties\tInc.0585200-9.\tMercury\tRealties\tInc.0585210-8.\tMercury\tRealties\tInc.0585220-7.\tMercury\tRealties\tInc.0585230-6.\tMercurv\tRealties\tInc.0585240-5.\tMercury\tRealties\tInc.0585250-4.\tMercury\tRealties\tInc.0585280-1.\tMercury\tRealties\tInc.0585290-0.\tMercury\tRealties\tInc.0585300-7.\tMercur.\\\tRealties\tInc.0585310-6.\tMercurj\tRealties\tInc.0585320-5.\tMercury\tRealties\tInc.0585330-4.\tMercur>\tRealties\tInc.0585340-3.\tMercury\tRealties\tInc.0585350-2.\tMercury\tRealties\tInc.0585360-1.\tMercur.\\\tRealties\tInc.0585370-0.\tMercury\tRealties\tInc.0585380-9.\tMercury\tRealties\tInc.0585390-8.\tMercury\tRealties\tInc.0585420-3.\tMercury\tRealties\tInc.A distraire dudit lot 152-305 la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 316527 et 365817: également à distraire dudit lot 152-306 la partie expropriée par ledit ministère aux termes des actes enregistrés audit bureau d'enregistrement sous les numéros 263691, 316527, 348181 et 365817.0585430-2.Mercurv Realties Inc.0585440-1.Mercurv Realties Inc.0585450-0.Mercurv Realties Inc.0585460-9.Mercury Realties Inc.0585470-8.Mercurv Realties Inc.0585480-7.Mercurv Realties Inc.0585490-6.Mercury Realties Inc.0585500-2.Mercury Realties Inc.0585510-1.Mercury Realties Inc.0585520-0.Mercury Realties Inc.0585530-9.Mercury Realties Inc.0585540-8.Mercury Realties Inc.A distraire de ces lots les parties vendues et expropriées aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 322390, 316527, 365817, 263691, 348181.152-219, 220 152-221, 222 152-223, 224 152-225, 226 152-227, 228 152-232, 233 152-234.235 152-239, 240 152-241, 242 152-243, 244 152-245, 246 152-247, 248 152-249, 250 152-251, 252 152-253, 254 152-255, 256 152-257, 258 152-259.260 152-261, 262 152-263, 264 152-265, 266 152-267, 268 152-269, 270 152-276, 277 152-278, 279 152-280, 281 .152-282.283 .152-284,285 .152-286,287 .152-288,289 .152-290, 291 .152-292, 293 .152-294, 295 .152-296, 297 .152-298,299 .152-305.306 To withdraw from said lot 152-305 the part expropriated by the Roads Department of the Province of Québec according to the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 316527 and 365817: also to withdraw from said lot 152-306 the part expropriated by the said Department according to deeds registered at said Registry Office under numbers 263691, 316527.348181 and 365817.152-311,312 .152-313, 314 .152-315, 316 .152-317, 318 152-319, 320 152-321, 322 152-323, 324 152-325.326 152-327, 328 152-329, 330 152-331,332 .152-333 a 340 To withdraw from these lots the parts sold and expropriated under the terms of the deeds of sales registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 322390, 316527, 365817, 263691, 348181.0585560-6____ 0585570-5.0585580-4____ 0585590-3.0585600-0____ 0585610-9.0585620-8.0585630-7____ 0585640-6.0585650-5.0585660-4.Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Mercury Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.Realties Inc.153-3,4 153-5.6 153-7, 8 153-9, 10 153-11, 12 153-13, 14 153-15.16 153-17, 18 153-19, 20 153-21.22 153-23, 24 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 37 avril 1971, 106' année, n° 17 3127 Folio Nom Xame Description de l'immeuble Description of immoveable 0585670-3.Mercurv Realties Inc.153-25.26 0585680-2.Mercury Realties Inc.153-27, 28 0585690-1.Mercurv Realties Inc.153-29,30 0585700-8.Mercury Realties Inc.153-31.32 0585710-7.Mercurv Realties Inc.153-33,34 0585720-6.Mercurv Realties Inc.153-35.36 0585730-5.Mercury Realties Inc.153-37.38 0585740-4.Mercury Realties Inc.153-39.40 0585750-3.Mercury Realties Inc.153-41.42 0585760-2.Mercury Realties Inc.153-43, 44 0586770-1.Mercurv Realties Inc.153-45, 46 0585780-0.Mercury Realties Inc.153-17,48 0585790-9.Mercurv Realties Inc.153-49,50 0585800-6.Mercury Realties Inc.153T5'- 52 0585810-5.Mercury Realties Inc.153-53,54 0585820-4.Mercurv Realties Inc.153-55.56 0585830-3.Mercury Realties Inc.153-57, 58 0585840-2.Mercurv Realties Inc.153-59.60 0585850-1.Mercurv Realties Inc.153-61,62 0585860-0.Mercury Realties Inc.153-63, 64 0585870-9.Mercury Realties Inc.153-65,66 0585880-8.Mercury Realties Inc.153-67,68 0585890-7.Mercury Realties Inc.153-69, 70 0585900-1.Mercury Realties Inc.153-71,72 0585910-3.Mercury Realties Inc.153-73, 74 0585920-2.Mercury Realties Inc.153-75, 76 0585930-1.Mercury Realties Inc.153-77,78 0585940-0.Mercury Realties Inc.153-80.81 0585950-9.Mercury Realties Inc.153-82.83 0585960-8.Mercury Realties Inc.153-84, 85 0585970-7.Mercury Realties Inc.153-86, 87 0585980-6.Mercury Realties Inc.153-88.89 0585990-5.Mercury Realties Inc.153-90.91 0586000-2.Mercury Realties Inc.153-92,93 0586010-1.Mercurv Realties Inc.153-94,95 0586020-0.Mercury Realties Inc.153-96.97 0586030-9.Mercury Realties Inc.153-98, 99 0586040-8.Mercury Reallies Inc.153-100,101 0586050-7.Mercury Realties Inc.153-102.103 0586060-6.Mercury Realties Inc.153-104.105 0586070-5.Mercurv Realties Inc.153-106,107 0586080-4.Mercury Realties Inc.153-108,109 0586090-3.Mercury Realties Inc.153-110,111 0586100-0.Mercurv Realties Inc.153-112.à 114 0586110-9.Mercury Realties Inc.153-115.116 0.586120-8.Mercury Realties Inc.153-117.118 0586130-7.Mercurv Realties Inc.153-119,120 0586140-6.Mercury Realties Inc.153-121.122 0586150-5.Mercury Realties Inc.153-123, 124 0580160-4.Mercury Realties Inc.153-125.126 0586170-3.Mercury Realties Inc.153-127,128 0586180-2.Mercury Realties Inc.153-129.130 0580190-1.Mercury Realties Inc.153-131,132 0586200-8.Mercury Realties Inc.153-133,134 0586210-7.Mercury Realties Inc.153-135,136 0586220-6.Mercury Realties Inc.153-137, 138 0586230-5.Mercury Realties Inc.153-139,140 05S624O 4.Mercury Realties IM.168 Ml.Ml' 0586250-3.Mercury Realties Inc.153-143,144 0586260-2.Mercurv Realties Inc.153-145.146 0586270-1.Mercury Realties Inc.153-147 à 149 0586280-0.Mercury Realties Inc.153-151.152 0586290-2.Mercurv Realties Inc.153-153.154 0586300-6.Mercury Realties Inc.153-155.156 0586310-5.Mercury Realties Inc.153-157,158 0586320-1.Mercury Realties Inc.153-159,160 0586330-3.Mercury Realties Inc.153-161,162 0686340-2.Mercury Realties Inc.153-163, 164 0586350-1.Mercury Realties Inc.153-165,166 0586360-0.Mercury Realties Inc.153-167.168 0586370-9.Mercury Realties Inc.153-169.170 0586380-8.Mercury Realties Inc.153-171,172 0580390-7.Mercury Realties Inc.153-173.174 3128 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 27, 1974, Vol- 100.No.17 Folio 0586400-4.0586410-3.0586420-2.0586430-1.0586440-0.0586450-9.0586460-8.0586470-7.0586480-6.0586490-5.0586500-1.0580510-0.0586520-9.0586530-8.0586540-7.0586550-6.05S0560-5 0586570-1.0586580-3.0586590-2.0586600-9.0586610-8.0586620-7.0586630-6.0586640-5.0587300-5.0602250-3.0602260-2.0602270-1.0602280-0.0602290-9.0602300-6.0602310-5.0602320-4.0602330-3.0602340-2.0602350-1.0602360-0.0602370-9.0602380-8.0602390-7.0602400-4.0602410-3.0602470-7.0602480-6.0602490-5.0602500-1.0602510-0.0602520-9.0602530-8.0602540-7.0602550-6.0602560-5.0602570-4.0602580-3.0602590-2.0602600-9.0602610-8.00(12020 7 0602030-6.0603070-4.Nom A'amr Description de l'immeuble Description of immoveable \u201e ., .153-175.176 Mercury Realties Inc.153-177, 178 Mercury Realties Inc.153-179, 180 Mercury Realties Inc.153-181, 182 Mercury Realties Inc.153-183, 184 Mercury Realties Inc.153-185.186 Mercurv Realties Inc.153-187.188 Mercury Realties Inc.153-189.190 Mercury Realties Inc.153-192, 193 Mercury Realties Inc.153-194,' 195 Mercury Realties Inc.153-196 197 Mercurv Realties Inc.¦ \u2022 ¦ 153-198', 199 Mercury Realties Inc.153-200.201 Mercury Rea ties Inc.153-202.203 Mercury Rea les Inc.153-204.205 Mercurv Rea Hies Inc.153-206.207 Mercury Realties Inc.\u201e.,Q Mercury Realties Inc.Jm Sin ill Mercury Realties Inc.J*~ - ,' ;i Mercury Realties Inc.}*> -[-¦ -\\î Mercurv Realties Inc.JSlliiL 91?Mercury Realties Inc.iïTô s 7, û Mercury Realties Inc.5™ \"»'», Mercury Realties Inc.\"Sb Mercury Realties Inc.Mercury Realties Inc.!H\"?SL Gordel Investments Ltd.155-lObt, Paroisse St-Antoine de Longueuil \u2014 Parish of St.Antoine de Lonaueuil (i( 103080-3, Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development.Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse De\\*elopment Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.,.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Jolisse Development Ltd.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor-man.Jacoh C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsav Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor-man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsny Investments Limited, Lodge Investment Corp.223-88 22:-: SO 223 90 223-91 223-92 223-93 223-94 223-95 223-96 223-97 223-98 223-99 223-100 223-101 223-102 223-103 223-104.224-115 223-110 223-111 223 112 223-113 223-114 223-115 223-116 223-117 223 118 223-119 223-120 223-121 223-122 223-123 223 124 223-125 223-126 223-169 223-170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106- année, n° 17 3129 Nom Description de l'immeuble Folio Xamc Description of immoveable 0003000-2.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-171 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603100-9.Daine Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-172 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen.Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603110-S.Daine Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-173 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0003120-7.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-174 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603130-6.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-175 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited.Lodge Investment Corp.0603140-5.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-176 man.Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603150-1.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-177,224-151 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603160-3.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-178; 224-150 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603170-2.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-170; 224-149 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603180-1.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-180; 224-148 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603190-0 .Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-181; 224-147 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603200-7.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-182; 224-146 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen.Dorsay Investments Limited.Lodge Investment Corp.0603210-6.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-183; 224-145 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603220-5.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-184; 224-144 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603230-4.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-185; 224-143 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603240-3.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-186; 224-142 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603250-2.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-187; 221-141 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603260-1.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-188; 224-140 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp. 3130 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Folio 0603270-0.0603280-9.0603290-8.0603310-4.0603340-1.0603350-0.0003360-9.0603370-8.0603380-7.0603390-0 0603420-1.0603430-0.Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0603300-5.0603320-3.0003330-2.0603400-3.0603410-2.0603440-9.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-18!); 224-139 man.Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Dame*Ceci'eSSroT.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-191 ; 224-137 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Dam^Cecfle^froT.'épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-192; 224-136 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen.Dorsay Investments Limited, Lodge Daine Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-193; 224-135 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-194; 224-134 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Daine Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-195; 224-133 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cccile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-196; 224-132 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-197 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-198 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-199 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-200 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-201 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-202 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-203 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-204 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-205 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-206 man.Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-207 man Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1971, 106' année, n° 17 3131 Nom Description de l'immeuble Folio Xante Description of immoveable 0603450-8.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-208 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603460-7.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-209 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603470-6.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-210 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603480-5.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-211 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603490-4.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-212 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603500-0.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-213 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603510-9.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-214 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603520-8.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-215 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603530-7.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-216 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0003540-6.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-217 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603550-5.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-218 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603560-4.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-219 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603570-3.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-220 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603580-2.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-221 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603590-1.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-222 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603600-8.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-223 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603610-7.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-224 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603620-6.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-225 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp. 3132 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 37, 1974, Vol.106, No.17 Nom Description de l'immeuble Xame Description of immoveable 0603630-5.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-226 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603640-4.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-227 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603650-3.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-228 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603660-2.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.Davxd Kor- 223-229 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0003670-1.Dame Cccilc Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-231 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603680-0.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-232 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603690-9.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-233 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603700-6.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-234 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603710-5.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-235 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603720-4.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I, Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-236 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603730-3.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-237 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603740-2.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-238 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments L'mited, Lodge Investment Corp.0603750-1.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-239 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603760-0.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-240 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603770-9.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-241 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603780-8.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-242 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0003790-7.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-243 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investment?Limited, Lodge Investment Corp.0603800-4.Daine Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-244 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n\" 17 3133 Nom Description de l'immeuble Folio Name Description of immoveable 0603810-3.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-245 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603820-2.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-246 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603830-1.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-247 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603840-0.Dame Cécile Efros, épouse Frwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-248 man.Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603850-9.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-249 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodga Investment Corp.0603860-8.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-250 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603870-7.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-251 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603880-6.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-252 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603890-5.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-253 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0003900-2.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-254 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603910-1.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-255 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603920-0.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-256 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603930-9.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-257 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603940-8.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-258 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603950-7.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-259 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603900-6.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-260 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603970-5.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-261 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0603980-4.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-262 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp. 3134 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Nom Description de l'immeuble Folio _ , , Xante Description of immoveable 0603990-3.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-263 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited.Lodge Investment Corp.0604000-0.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-264 man, Jacob C.Greenbaum.Dame Katahn Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.0604010-9.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein.David Kor- 223-265 man.Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-266 man.Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-267 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros.épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-268 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen.David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-269 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I, Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-270 man.Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, éi>ouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-271 man.Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen.Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein, David Kor- 223-272 man.Jacob C.Greenbaum.Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp, Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein.Erwin I.Klein.David Kor- 223-273 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Dame Cécile Efros, épouse Erwin I.Klein, Erwin I.Klein, David Kor- 223-274 man, Jacob C.Greenbaum, Dame Katalin Gardos épouse David Barenstaen, David Barenstaen, Dorsay Investments Limited, Lodge Investment Corp.Jolisse Development Ltd.223-308; 224-114 Richard Legault.I\"ne lisière de terrain mesurant 10 pieds de largeur sur une profondeur de 191 pieds, composée d'une partie du lot 157-13 paroisse St-Hubert, et d'une partie du lot 224-13 paroisse St-Antoine de Longueuil, bornée au sud-est par la Montée St-Huliert.en arrière au nord-ouest par partie du lot originaire 224 paroisse St-Antoine-de-Longueuil, d'un côté au nord-est par une partie desdits lots 157-13 et 224-13 appartenant à Jacques Savage, ou représentants, et de l'autre côté au sud-OUMt par une partie des mêmes lots 157-13 et 224-13 appartenant à Dame Charles Leguult ou représentants.A distraire de ladite partie du lot 157-13 la partie prise pour l'élargissement de lu Montée St-Hubert.O0O402O-S 0604030 7.0604040-0.0604050-5.0604060-4.0604070-3.0604080-2.0604090 1.nom mu s 0604130-5.0607050-2.A strip of land measuring 10 feet in width by a depth of 191 feet, comprising a part of lot 157-13, Parish of St.Hubert, and a part of lot 224-13, Parish of St.Antoine-de-Longueuil, bounded on the southeast by Montée St.Hubert, in the rear on the northwest by a part of original lot 224, Parish of St.Antoine-de-Longueuil, on one side on the northeast by a part of said lots 157-13 and 224-13 belonging to Jacques Savage, or representatives, and on the other side on the southwest by a part of said lots 157-13 and 224-13 belonging to Mrs.Charles Legault or representatives.Less and to withdraw from said part of lot 157-13 the part taken for the widening of Montée St.Hubert.0609160-7 0609170 l, (I0OOISO 5 00091911 I 0009200 I 0610060-3 0611340- Dame liobina Chalmers veuve James M.Chalmers.158-227 Dame Itobina Chalmers veuve James M.Chalmett .IS8 338 Dame Robina Chalmers veuve James M.Chalmers.158-229 Roger Fettu.158-230 Roger 1-ettu.158_231 Mercury Realties Inc.158-491 Mercury Realties Inc.158-597 !!'.' ! LmnZaVasilios Doukakis.et Dame Paulyne Fournier épouse MarcelLe vesque .' 158-606, 607 UOiau/V-S.André Désormeaux. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1971, 106' année, n° 17 3135 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 158-743 et une partie du lot 158-744 mesurant cettedite partie, 15 pieds de largeur sur une profondeur de 81 pieds, bornée en front par la rue Domville, en arrière par une partie du lot 158-698, d'un côté par le lot 158-743 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 158-744.158-743 and a part of lot 158-744, said part measuring 15 feet in width by a depth of 81 feet, bounded in front by Domville Street, in the rear by a part of lot 158-698, on one side by lot 158-743 and on the other side by the remainder of said lot 158-744.0613310-2.Dame Eleni Tsopanargia et Dimitrios Saklas, son époux.158-1026, 1027 0614230-1.Panagiotis Maltezos.158-1220,1221 0614470-3.André Rioux.158-1267,1268 0616120-2.Spathodia Land Corporation.159-257, 258 0618640-7.Dame Kiki Dimakis, et Peter Maniatakos, son époux.160-324 0620320-2.Elie Papadopoulos.160-512 0620480-4.George Mionoyos.160-528 0620530-6.Georges Klidones.160-534 0620570-2.Penelope Kontou.160-538 0621750-9.Dame Ethel Ula Haynes épouse Alfred Braithwaite.161-112; 162-195 0624390-1.Dame Angela Kontobassi, Peter Servetis, son époux, et Peter Theofilis.162-183 0629330-2.Nilos Bakas.163-11 0629640-4.John Caragianakos.163-44 0629840-0.Garyfalia A.Mangas.163-65 0629850-9.Garyfalia A.Mangas.163-66 0629880-6.John Caragianakos.163-69 0629950-7.Park Plaza Gardens Corp.163-76 A distraire la partie expropriée par la Ville de St-Hubert aux To withdraw the part expropriated by the City of St.Hubert termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du under the terms of the deeds registered in the County of Cham-comté de Chambly sous les numéros 275630 et 281790.bly Registry Office under numbers 275630 and 281790.0629960-6.Park Plaza Gardens Corp.A distraire la partie expropriée par la Ville de St-Hubert aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 275630 et 281790.0633290-2.Condor Construction Company Ltd.A distraire la partie expropriée par la Ville de St-Hubert aux termes des actes enregistrés au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous les numéros 264569 et 290593.163-77 To withdraw the part expropriated by the City of St.Hubert under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 275630 and 281790.164-29 To withdraw the part expropriated by the City of St.Hubert under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under numbers 264569 and 290593.0633427-0.Eli Brown Realties Inc.0640590-6.Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.0640980-9.Steve Szakos.Une partie du lot 166-37 mesurant 50 pieds de largeur sur une profondeur de 166 pieds bornée en front par le chemin public, en arrière par le lot appartenant à Armand Lamarre ou représentants, d'un côté à Bedford Gordon ou représentants, et de l'autre côté par le résidu dudit lot 166-37.164-50 166-9,10 A part of lot 166-37 measuring 50 feet in width by a depth of 166 feet, bounded in front by the public road, in the rear by the lot belonging to Armand Lamarre or representatives, on one side by Bedford Gordon or representatives, and on the other side by the remainder of said lot 166-37.0641100-3.0641110-2.0644520-9.0644530-8.0644540-7.0644970-6.0644980-5.0644990-4.0645000-1.0645010-0.0645020-9.0645030-8.0645040-7.0645050-6.0658290-2.0658300-9.0658310-8.0658640-8.0659060-8.0659270-3.0659620-9.0659630-8.0659640-7.0659800-7.0659810-6.0659820-5.Andrew Edward Gordon.166-41 Andrew Edward Gordon.166-42 Dame Marguerite Laliberté veuve Léonard John Hanson.166-405 Dame Rhoda Gore, épouse Joseph Steele.166-406 Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.166-407 Dame Rhoda Gore, épouse Joseph Steele.166-448 Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.166-449 Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.166-450 Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.166-451 Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.166-452 Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.166-453 Dame Rhoda Gore épouse Joseph Steele.166-454 Spathodia Land Corp.166-455 Spathodia Land Corp.166-456 Lucien J.Therrien.171-1.2 Lucien J.Therrien.171-3, 4 Lucien J.Therrien.171-5 Elie Papoutsis.171-64,65 Dame Vivian Lowe épouse Donald McCaig, et John Maxwell Lowe.171-140, 141 Archie Newby.171-182,183 Ohristoforos Pittas.171-249 Christoforos Pittas.171-250, 251 Christoforos Pittas.171-252, 253 Dlle Lily Parman.171-281.282 Dame Lily Parman.171-283, 284 Raffaele Ciolla.171-285, 286 3136 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April S7.1971, Vol.106, No.17 Folio Nom S'a me Description de l'immeuble Description of immoveable 0f>59830-4.Raffaele Ciolla.'ï!-28,!' SSI 0659840-3.Raffaele Ciolla.1 i!-289.290 0660070-J.Spathodia Land Corp.JZ}\"?J?' ?S 0660720-4.Aarne Kytola.J J, J -470.477 0660800-4.Garth Parker.HîhS'SÎ 0661290-7.Antonio Silva et Dame Dionyssia Vythoulka épouse Alfredo Nunes 171-587.58» Santos.James Viris et Dame Angela Kaliavas.son épouse .Alexandres Aggelidou, et Kvangelia Aggelidou.Alexandres Aggelidou.et Evangelia Aggelidou.0661660-1.Dame Katina Aggelidou épouse John Mirinathopoulos.171-B4U 0661680-9.Dame Katina Aggelidou épouse John Mirinathopoulos.}71-641 a 643 City and District Development Inc.Hrisostomos Kangelis.\u2022 \u2022 \u2022.lames Viris et Dame Angela Kaliavas, son épousS, et Peter MakOS.Antonio Silva, et Dame Dionyssia Vythoulka, épouse Alfredo Nunes Santos.Albert Brown.\u2022 \u2022.Dame Vivian Lowe épouse Donald McCaig.et John Maxwell Lowe.Dame Vivian Lowe épouse Donald McCaig, et John Maxwell Lowe Dame Vivian Lowe épouse Donald McCaig, et John Maxwell Lowe.Luis Marquis Rebelo.Luis Marquis Rebelo.Luis Marquis Rebelo.Dimitrios Roumeliotis.Dimitrios Roumeliotis.Stefan Mudryk.Dame Vivian Lowe épouse Donald McCaig, et John Maxwell Lowe.Dame Vivian Lowe épouse Donald McCaig.et John Maxwell Lowe Thomas O'Connell.Park Plaza Gardens Corp.Max Ticker et Dame Lily Jane Rodger, son épouse.Max Ticker et Dame Lily Jane Rodger, son épouse.Euthymios Spyropoulos.Euthymios Spyropoulos.Constantine Kapetanios.Joseph Farrugia.Michèle Giambagno, et Mario Giovanni.Valtes Inc.Theodore Chase.Theodore Chase.Dame veuve Evangelia Kouzara.Valtes Inc.Valtes Inc.Dame veuve Evangelia Kouzara.James Devine.Dame Paraskevi Founta et Nikolaos Haralabidis son époux.Marcel Vallicres.Dame Annie Thompson Shepherd épouse Bernard C.Jones.Biaggio Tambuzzo.et Onofrio Cutro.Biaggio Tambuzzo ct Onofrio Cutro.Nicolaos Katsafanas.Nicolaos Katsafanas.Nicolaos Katsafanas.Nicolaos Katsafanas.Evangelo Georgaros et Antonios Georgaros.Evangelo Georgaros.et Antonios Georgaros.Evangelo Georgaros, et Antonios Georgaros.Evangelo Georgaros, et Antonios Georgaros.Evangelo Georgaros.et Antonios Georgaros.Evangelo Georgaros, et Antonios Georgaros.Jean-Paul Deschenes.Une partie du lot 172-33 mesurant 25 pieds de largeur sur une profondeur de 101 pieds bornée en front, par la rue Kensington , en arrière par le lot 171-265, d'un côté par le lot 172-34 et de l'autre côté par le résidu dudit lot 172-33.0661600-7 0661630-4 0661650-2 0661950-6 0662000-9 0662030-6.0662040-5.0662290-6____ 0662540-4.0662550-3.0662560-2- 0662960-4 0662970-3.0662980-2.0G62990-1 0663000-8____ 0663460-4 0664140-1.0664160-9.0664190-6.0664210-2.0664290-4.0664300-1- 0664600-4 0664620-2.0664670-7- 0664870-3.0664900-8.0665430-5.0665510-4- 0665520-3.0665540-1.0665640-9.0665740-7.0665770-4.0665960-1.0666040-1____ 0666640-8.0667550-8.0667580-5- 0667590-4.0667620-9- 0667630-8.0667650-6____ 0667670-4.0667680-3____ 0667700-9.0667710-8.0667720-7.0667730-6.0667740-5.0667810-6.171-629.630 171-635.636 171-637 à 639 171-693, 694 171-701, 702 171-707.708 171-709, 710 171-763 a 765 171-815, 816 171-817.818 171-819, 820 171-898.899 171-900, 901 171-902, 903 171-904, 905 171-906, 907 171-961, 962 171-1092.1093 171-1094 à 1096 171-1100 à 1102 171-1103 171-1115, 1116 171-1117.1118 171-1162.1163 171-1164 a 1166 171-1174 171-1207, 1208 171-1213,1214 171-1305 à 1307 171-1321.1322 171-1323, 1324 171-1328,1329 171-1342 à 1344 171-1358, 1359 171-1363, 1364 171-1394.1395 171-1408.1409 171-1494 à 1496 172-6 172-9 172-10 172-13.14 172-15 172-17 172-19 172-20 172-22 172-23 172-24 172-25 172-26 A part of lot 172-33 measuring 25 feet in width by a depth of 101 feet bounded in front by Kensington Street, in the rear by lot 171-265.on one side by lot 172-34 and on the otherside by the remainder of said lot 172-33.0667820-5.0668280-1.0668540-8.0668630-7.0668660-4.Jeun-Paul Deschenes.Dame Pauline Gauthier épouse René Berthiaume .f'ity & District Development Inc.Georges Klidonas.Menios Liofagos.172-34 172-85 172-103 172-113 172-116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1971, 106' année, n° 17 3137 Nom Description de l'immeuble Folio Name Description of immoveable 0608690-1.\t\t172-120 0668700-8.\tDame Evangelie Vasdakis et Dimos Couzaras, son 6poux.\t172-121 0668710-7.\t\t172-122 0669020-0.\t\t172-151 0669030-9.\t\t172-152 0669100-0.\t\t172-160;173-76 0669101-8.\t\t172-161;173-75 0669340-2.\t\t172-185;173-45 0669660-3.\t\t172-206; 173-18 0670200-5.\t\t172-257 0670310-2.\t\t172-269 0670320-1.\t\t172-270 0670330-0.\t\t172-271 0670340-9.\t\t172-272 0670350-8.\t\t172-273 0671480-2.\t\t173-86 0671540-3.\t\t173-93 0671550-2.\t\t173-94 0671590-8.\t\t173-98 0671600-5.\t\t173-99 0671630-2.\t\t173-102 0671640-1\t\t173-103 0671650-0.\t\t173-104 0671820-9.\tDame Ruth Backman.épouse Hyman Shugar.\t173-123 0671830-8.\t\t173-124 0671860-5.\t\t173-127 0671870-».\t\t173-128 0672420-7.\t\t173-177 0672430-6.\tAntonio Silva et Dame Dionyssia Vythoulka épouse Alfredo Nunes Santos.\t173-178 0672800-0.\t\t173-214 0672820-8.\t\t173-216 0672830-7.\t\t173-217 0672860-4.\tTheophilius D.Owusu.\t173-220 0672870-3.\t\t173-221 0672880-2.\t\t173-222 0673260-6.\t\t173-254 0673270-5.\t\t173-255 0673300-O.\t\t173-259 0673570-8.\t\t173-288 0673580-7.\t\tI7:i 2X9 0673610-2.\tAlex Theofanis.\t173-292 0673620-1.\t\t173-293 0673630-0.\t\t173-294 0673640-9.\t\t173-296 0673650-8.\tRoger Fettu.\t173-297 0673660-7.\t\t173-298 0673670-6.\tRoger Fettu.\t173-299 0673680-5.\t\t173-300 0673690-4.\t\t173-301 0673860-3.\t\t173-318 0673891-8.\t\t173-323 0673910-6.\t\t173-324 0673970-0.____\t\t173-330 0673980-9.\t\t173-331 0673990-8.\t\t173-332 0674231-6.\t\t173-357 0674250-6.\t\t173-358 0674310-8.\t\t173-365 0674320-7.\t\t173-366 0674350-4.\t\t173-369 0674360-3.\tAlex Theofanis.\t173-370.371 0674530-1.\tGeorge Kritikos et Harry Kitzimian.faisant affaires ensemble sous les nom et raison sociale de « G & H Carpets »\t173-390 0074550-9.\t\t173-392 0674650-7.\t\t173-404 0674660-6.\t\t173-405 0674810-7.\t\t173-121 0674820-6.\t\t173-422 0674890-9.\tBenito Di Tommasso, et Daine Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon\t173-430 0674900-0.\tBenito Di Tommasso.et Dame Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon\t173-431 0674910-5____\tBenito Di Tommasso, et Dame Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon\t173-432 3138 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1971, Vol.106, No.17 Nom Description de l'immeuble folio Xante Description of immoveable 0675040-0.Benito Di Tommasso.et Dame Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0675050-9.Benito Di Tommasso, et Dame Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0675060-8.Benito Di Tommasso, et Dame Germaine St-Pierre veuve Louis Grenon 0675230-7.Spathodia Land Corp.0675370-1.Antonios Tsocanos.0675380-0.Constantine Kapetanios.0675440-2.Noel Pat Brady.Une partie du lot 173-478 mesurant 25 pieds de largeur sur une profondeur de 90 pieds, bornée au nord-ouest par une rue, en arrière au sud-est par partie du lot 173-390, d'un côté au sud-ouest par le résidu dudit lot 173-478, et de l'autre côté au nord-est par le lot 173-477.173-445 173-446 173H147 173-455 173-470 173-471 A part of lot 173-478 measuring 25 feet in width by a depth of 90 feet, bounded on the northwest by a street, in the rearon the southeast by a part of lot 173-396, on one side on the southwest by the remainder of said lot 173-478, and on the other side on the northeast by lot 173-477.0675680-3.Dimitrios et Dennis Pilarinos.0676070-0.Antonio Silva et Dame Dionyssia Vythoulka épouse Alfredo Nunes Santos Une partie du lot 173-539 mesurant 25 pieds de largeur sur une profondeur de 100 pieds, bornée au sud-est par une rue (173-489), d'un côté au nord-est par le lot 173-538, en arrière au nord-ouest par le lot 173-546 et de l'autre côté au sud-ouest par le résidu dudit lot 173-539.173-496 A part of lot 173-539 measuring 25 feet in width by a depth of 100 feet, bounded on the southeast by a street (173-489).on one side on the northeast by lot 173-538, in the rear on the northwest by lot 173-546 and on the other side, on the southwest, by the remainder of said lot 173-539.0676130-8.Spathodia Land Corp.A distraire la moitié sud-ouest vendue aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 71423.173 546 To withdraw the southwest half sold under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 71423.0676190-2 0676200-9.0676210-8.0676490-0.0676600-0.0677060-6.0677070-5.0677250-3.0677260-2.0677590-2.0677600-9.0677610-8.0678070-4.0678080-3.0678090-2.0678100-9.0678110-8.0678120-7.0678130-0.0678140-5.0678150-4.0678160-3.0678330-2.0678360-9.0678370-8.0678380-7.0078400-3.0678510-9.0678520-8.0678530-7.0678590-1.0678600-8.0678610-7.0678620-6.0678630-5.0678640-4.0678650-3.0078660-2.0678690-9.0679580-1.0679590-0.0679660-1.0679670-0.0679740-1.0679750-0.Rosaire Levasseur.Rosaire Levasseur.Rosaire Levasseur.Dimitrios et Dennis Pilarinos.Roger Fettu.Spyros Lazos.Spyros Lazos.Petros Zamagias.Petros Zamagiaa.Georgios-Haralam Constantinidis et Dame Stella Vassiliou, son épouse Georgios-Haralam Constantinidis et Dame Stella Vassiliou, son épouse Georgios-Haralam Constantinidis et Dame Stella Vassiliou, son épouse City & District Development Inc.City & District Development Inc.City & District Development Inc.City & District Development Inc.City & District Development Inc.City & District Development Inc.Theofilos Kaselis, et Dame Athena Millas, son épouse.Theofilos Kaselis.et Dame Athena Millas, son épouse.Theofilos Kaselis, et Dame Athena Millas, son épouse.Theofilos Kaselis, et Dame Athena Millas, son épouse.Dlle Opacic Mirjana.Paul Leunes.Paul Leunes.George Vallouris, et Dame Irene Kehagias, son épouse.Radenko Fanuka et Dame Mira Santic, son épouse.Nick Alengakis.Nick Alengakis.Nick Alengakis.Evstratios, Panagiotis et George Anastasakos.Evstratios, Panagiotis et George Anastasakos.Evstratios, Panagiotis et George Anastasakos.Evstratios, Panagiotis et George Anastasakos.Evstratios, Panagiotis et George Anastasakos.Evstratios, Panagiotis et George Anastasakos.Evstratios.Panagiotis et George Anastasakos.Evstratios, Panagiotis et George Anastasakos.James Karulas.George Sengos et Peter Dounis.George Sengos et Peter Dounis.John M.Kalozois.John M.Kalozois.George Sengos et Peter Dounis.George Sengos et Peter Dounis.173-552 173-553 173-554 173-58G 173-588 174-55 174-50 174-65 174-66 174-99 174-100 174-101 174-147 174-148 174-149 174-150 174-151 174-152 174-153 174-154 174-155 174-156 174-173 174-176 174-177 174-178 174-180 174-191 174-192 174-193 174-199 174-200 174-201 174-202 174-203 174-204 174-205 174-206 174-209 174-288 174-289 174-296 174-297 174-304 174-305 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril .1974, 106' année, n° 17 3139 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0679900-1.City & District Development Inc.174-320 0679910-0.City & District Development Inc.174-321 0679990-2.Dlle Maria Grimbilas.174-340 0680000-7.Dlle Maria Grimbilas.174-341 0680010-6.Dame Venetia Dikonomakos épouse Panagiotis Koroneos.174-342 0680020-5.Dame Venetia Dikonomakos épouse Panagiotis Koroneos.174-343 0680030-4.Dame Sophia Manetas, épouse Peter Venetsanakis.174-344 0680040-3.Dame Venetia Dikonomakos épouse Papagiotis Koroneos.174-345 0680060-1.Petros Zamagias.174-347 0680070-0.Petros Zamagias.174-348 06S0080-9.City & District Development Inc.174-349 0680180-7.Panos Photopoulos.174-359 0680370-4.Citv & District Development Inc.174-377 0680380-3.Citv & District Development Inc.174-378 0680390-2.City & District Development Inc.174-379 0680400-9.City & District Development Inc.174-380 0680410-8.City & District Development Inc.174-381 0680420-7.City & District Development Inc.174-382 0680430-6.Theofilos Kaselis et Dame Athena Millas son épouse.174-383 0680440-5.Theofilos Kaselis et Dame Athena Millas, son épouse.174-384 0680450-1.Theofilos Kaselis et Dame Athena Millas, son épouse.174-385 0680460-3.Theofilos Kaselis et Dame Athena Millas, son épouse.174-386 0680890-1.James Georgakis.174-415 0680900-8.James Georgakis.174-416 0681080-8.Nick Asimis et Dame Petroula Giakoumis, son épouse.174-434 0681U0-3.Linwood Pratt.174-437 0681370-3.Andreas Hajiyerou.174-459 0681380-2.Andreas Hajiyerou.174-460 0681390-1.Andreas Hajiyerou.174-461 0682190-4.Menas Michael.174-508 0682200-1.Menas Michael.174-509 0682210-0.Menas Michael.174-510 0682220-9.Menas Michael.174-511 0682350-4.Demetrios Vounasis et Dame Ramute Matulaitis, son épouse.174-524 0682710-9.Christ Lambros.174-532 0682720-8.Christ Lambros.174-533 0682730-7.Christ Lambros.174-534 0682840-4.Anastasia Hamijidis.174-581 0682841-2.Anastasia Hamijidis.174-582 0682845-3.George Stavropoulou-Stevens et Elias Stavropoulos-Stevens.174-586 0682846-1.George Stavropoulos-Stevens et Elias Stavropoulos-Stevens.174-587 0682848-7.Demetrios Vounasis et Dame Ramute Matulaitis.174-590 0683150-7.Astro Development & Research Corp.175-457 A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie Less and to withdraw the part expropriated by the Depart-de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au ment of Roads of the Province of Québec under the terms of a bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro deed registered in the County of Chambly Registry Office 273854.under number 273854.0683160-6.Astro Development & Research Corp.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 273854.175-458 Less and to withdraw the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 273854.0683170-5.Astro Development 0683180\u20141.Astro Development 0683190-3.Astro Development 0683200-0.Astro Development 0683210-9.Astro Development 0683220-8.Astro Development 0683230-7.Astro Development 0683240-6.Astro Development 0683250-5.Astro Development 0683260-4.Astro Development 0683270-3.Astro Development 0683280-2.Astro Development 0683290-1.Astro Development 0683300-8.Astro Development 0683310-7.Astro Development 0683320-6.Astro Development 0683330-5.Astro Development 0683340-4.Astro Development & Research Corp.175-461 & Research Corp.175-462 & Research Corp.175-463 & Research Corp.175-464 & Research Corp.175-465 & Research Corp.175-466 & Research Corp.175-167 & Research Corp.175-468 & Research Corp.175-469 & Research Corp.175-470 & Research Corp.175-471 & Research Corp.175-472 & Research Corp.175-473 & Research Corp.175-474 & Research Corp.175-475 & Research Corp.175-476 & Research Corp.175-477 & Research Corp.175-478 3140 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1971,, Vol.106, No.17 Folio Nom Xante Description de l'immeuble Description of immoveable 0683350-3.Astro Development & Research Corp .0683360-2.Astro Development & Research Corp.0683370-1.Astro Development & Research Corp .A distraire la partie vendue à la Ville de St-Hubert aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 260706.0683380-0.Astro Development & Research Corp.A distraire la partie vendue a la Ville de St-Hubert aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 260706.0683390-9.Astro Development & Research Corp.A distraire la partie vendue à la Ville de St-Hubert aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 260706.0695330-1.Guiseppe Ottoni.A distraire la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chamblv sous le numéro 306362.0695340-0.G uiseppe Ottoni.A distraire la partie expropriée par la ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 306362.175-179 .175-480 .175-481 Less and to withdraw the part sold to the City of St.Hubert under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 260706.175-482 Less and to withdraw the part sold to the City of St.Hubert under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 260706.175-483 Less and to withdraw the part sold to the City of St.Hubert under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 260706.177-131 Less and to withdraw the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 306362.177-132 Less and to withdraw the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 306362.0695350-9.Guiseppe Ottoni.A distraire de ces lots la partie expropriée par le ministère de la voirie de la province de Québec aux termes d'un acte enregistré au bureau d'enregistrement du comté de Chambly sous le numéro 306362.177-133 à 135 Less and to withdraw from these lots the part expropriated by the Department of Roads of the Province of Québec under the terms of a deed registered in the County of Chambly Registry Office under number 306362.0695360-8.Guiseppe Ottoni.0695370-7.Guiseppe Ottoni.0695380-6.Guiseppe Ottoni.0695390-5.Guiseppe Ottoni.0695400-2.Guiseppe Ottoni.0695410-1.Willv Ruegger.0695500-9.John Bachetti.0695510-8.John Bachetti.0695520-7.John Bachetti.0695530-6.Dame Maria Bachetti, épouse Guiseppe Ottoni 0695650-2.Dame Maria Bachetti, épouse Guiseppe Ottoni 069G150-2.Antonio Daniele et Aldo Conte.0696160-1.Antonio Daniele et Aldo Conte.0696170-0.Antonio Daniele et Aldo Conte.0696180-9.Antonio Daniele et Aldo Conte.0696190-8.Antonio Daniele et Aldo Conte.0697150-1.Benri Development Corp.A distraire de ces lots la partie expropriée et vendue au ministère de la voirie de la province de Québec aux termes des 177-136 177-137 177-138 177-139 177-140 177-141 177-150 177-151 177-152 177-154 177-166 177-216 177-217 177-218 177-219 177-220 177-322, 323 Less and to withdraw from these lots the part expropriated - and sold to the Department of Roads of the Province of Québec actes enregistres au bureau d enregistrement du comté de under the terms of the deeds registered in the County of Chambly Registry Office under number 306362 and 374991.Chambly sous le numéro 306362 et 374991.0697160-0.0697170-9.0697180-8.0697190-7.0697200-4____ 0697210-3____ 0697220-2.0097230-1 069724O-0.0697250-9.0697260-8.0697270-7.0697280-6.0697290-5.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard .Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard 177-324 177-325 177-326 177-327 177-328 177-346 177-347 177-348 177-349 177-350 177-351 177-352 177-353 177-354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3141 Folio Nom Name Description de l'immeuble Description of immoveable 0697300-2____ 0697310-1____ 0697320-0____ 0697330-9.0697340-8____ 0697350-7____ 0697360-6____ 0697370-5.06973S0-4.0697390-3____ 0697400-0____ 0697410-9.0697420-8____ 0697430-7.0697440-6- 0697450-5.0697460-4____ 0697470-3.06974S0-2- 0697490-1____ 0697500-7____ 0697510-6.0697520-5.0697530-4 0697540-3.0697720-1 0697890-2- 0697900-9____ 0697910-8.0698650-9.0698660-8.0698670-7.0698680-6.0698690-5.0730730-9.0759210-8.0763450-4 0764360-6 0774461-8.0774462-6.0774520-1.0774570-6.0774580-5.07752904).0775300-7.0775310-6.0775320-5.0775330-4.0775340-3- 0775350-2.0775360-1.0775370-0.0776100-0.0776650-4____ 0776660-3.0776670-2.0776680-1.0776690-0- 0776700-7- 07767704).0777030-8- 0777100-9.0778030-7.0778040-6,.0778050-5.0778060-4- 0778070-3.0778080-2- 0778090-1.0778100-8.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard .Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Mare Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Marc Brassard.Isidore Langenauer Alfa Construction Corp.Alfa Construction Corp.Alfa Construction Corp 177-355 177-357 177-358 177-359 177-360 177-361 177-362 177-363 177-364 177-365 177-366 177-367 177-368 177-370 177-371 177-372 177-373 177-374 177-375 177-376 177-377 177-378 177-379 177-380 177-381 177-400 177-416 177-417 177-418 177-493 177-494 177-495 177-496 181-14 187-353 076471041 Roger Fettu .187-1517.1518 0766470-9.'.'.'.'.Raymond Levasseur.'.'.'.'.JSHSS?» 0767120-9.Edwin Joseph Valois.iS'lS'soJ?Jacques Noury.I^\"4?Jacques Noury.Jacques Noury.Jacques Noury.Jacques Noury.Emmanuel Theofilou Klonaris.Adrien Brosscau et A.Darabaner.Southway Development Inc.JgJ-1330 k -38 Zacharias Gerondaris.}ll'}t2- \\i 5 .18¦field par Penn Central Transportation Company, en vertu de leurs services réguliers de « piggyback ». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' armée, n° 17 3201 No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de: à:\tDétails du permis Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of permit MS-543 23715-V-S-l\tSYRACUSE RIGGING CO.INC.\tJusqu'au 1er juillet 1974 Until July 1, 1974\tLa clause / décrite dans ce présent permis remplace la clause / qui existe dans le permis permanent numéro 4389-V.Les remorques utilisées dans le cadre du service décrit dans la clause/ ci-dessus décrite, devront être immatriculées conformément aux Lois de la province de Québec.Ce permis est accordé et devra être opéré conjointement avec un permis de l'Interstate Commerce Commission.(/) From Coteau Station, Coteau-du-Lac, Coteau Landing and St.Zotique to Montreal, and return.Restriction: The riaht of transhipment at the Coteau-du-Lac terminal shall be applicable only for goods carried in trailers belonging to American carriers holding permits from the Interstate Commerce Commission, and delivered in Valleyfield by Penn Central Transportation Company, under the terms of their regular piggyback services.Clause f quoted in this permit replaces clause f, which appears in the present permanent permit numbered 4S89-V.The trailers utilized under the terms of the service described in clause f hereinabove stated must be registered in conformity with the laws of the Province of Quebec.This permit is granted and must be operated concurrently with a permit from the Interstate Commerce Commission.De Montréal à la frontière Québec-Etats-Unis (tous les ports d'entrée) pour le transport, au moyen de véhicules spécialement agencés, de panneaux de béton préfabriqués en provenance des établissements de Prefac Concrete à Montréal et à destination de Syracuse (New-York), pour le compte de A.Neslick & Sons./ From MontrealtotheQuébec-U.S.A.border (ailportsof entry) for the carriage by specially designed equipment of precast concrete panels originating at Montreal at Prefac Concrete, destined to Syracuse, New York, for the account of A.Neslick & Sons.De Montréal à la frontière Québec-Ontario (port d'entrée: Rivière-Beaudette), en transit à travers la province de l'Ontario jusqu'à la frontière Ontario-Etats-Unis (tous les ports de sortie), point de destination: Syracuse, pour le transport, au moyen de véhicules spécialement agencés, de panneaux de béton préfabriqués en provenance des établissements de Prefac Concrete à Montréal et à destination de Syracuse (New-York) pour le compte de A.Neslick & Sons./ From Montreal to the Québec-Ontario border (port of entry; Rivière-Beaudette), in transit through the Province of Ontario to the Ontario-U.S.A.border (all ports of exit), destination: Syracuse, for the carriage by specially designed equipment of precast concrete panels originating at Montreal at Prefac Concrete, destined to Syracuse, New York, for the account of A Neslick & Sons.Ce permis est accordé et devra être opéré conjointement avec un permis de l'Interstate Commerce Commission./ This permit is granted and shall be operated concurrently with a permit from the Interstate Commerce Commission. 3202 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Validité: de:.à: Validity Period Détails du permis Particulars of permit MS-MI 1301-DY-S-l MS-US 703-V-S-2 LES AGENCES KYOTO LTEE C.LEBOEUF TRANSPORT INC.MS-5S3 18289-V-S-l MS-564 2656-V-S-4 M.AIME TREMBLAY Requérant-vendeur A ppticant-vendor TRANSPORT AIME TREMBLAY INC.Requérant-acheteur A pplicant-purchaser URGEL CHARETTE TRANSPORT LTEE Jusqu'au 15 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March IB.1975 or pending final decision.Jusqu'au 15 septembre 1974.Until September 15, 1974.Jusqu'au 15 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March 16, 1975 or pending final decision.Jusqu'au 15 mars 1975 ou jusqu'à décision finale Until March 16, 1976 or pending final decision.Location à court terme (moins d'une année) de véhicules de promenade aux clients seulement pendant que leurs véhicules sont en réparation au garage de la requérante./ Leasing of pleasure vehicles on a short-term basis (less than one year) exclusively to customers while their vehicles are being repaired in the applicant's garage.Accordée / Granted, g) De St-Louis-de-Gonzague à Montréal, et retour.Restriction: Le droit de transbordement au terminus de St-Louis-de-Gonzague est restreint au transport de marchandises dans des remorques appartenant à des transporteurs américains détenteurs de permis de l'Interstate Commerce Commission, et livrées à Valleyfield par Penn Central Transportation Company, en vertu de leurs services réguliers de « piggy back ».La clause g décrite dans ce présent permis remplace la clause g qui existe dans le permis permanent numéro 730-V.Ce permis est accordé et devra être opéré conjointement avec un permis de l'Interstate Commerce Commission.(g) From St.Louis-de-Gomague to Montreal, and return.Restriction: The right of transhipment at the terminal in St.TjOuis-de-Gor.eague shall be applicable only for goods carried in trailers belonging to American carriers holding permits from the Interstate Commerce Commission, such goods being delivered in Valleyfield by Penn Central Transportation Company, under the terms of their regular piggy back services.Clause g described in this permit replaces clause g, which appears in the permanent permit numbered 730-V.This permit is granted and shall be operated con-concurrently with a permit from the Interstate Commerce Commission.a) De Sherrington et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite municipalité.b) De Sherrington à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles des limites de ladite municipalité, et retour.c) De Sherrington à Montréal, et retour.Ce permis est accordé à la condition que le requérant-vendeur Aimé Tremblay, cesse immédiatement les opérations autorisées par ledit permis.(a) From Sherrington and all points located over a distance of not more than 5 miles from said municipality.(b) From Sherrington to all points located within a radius of SO miles from the limits of said municipality, and return.This permit is granted on condition that the applicant-purchaser, Aimé Tremblay, cease immediately the operations authorized by said permit.Prolongation du permis spécial ci-après: Tirer les remorques CP.Rail de Montréal à tous les points qu'elle dessert en vertu des clauses d et k du permis No 2656-V./ Extension of the following special permit: To haul the trailers belonging to CP.Rail from Montreal to all points that the latter serves pursuant to clauses d and k of permit No.2666-V.Accordée / Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 avril 1974, 106' année, n° 17 3203 No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails du permis Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of permit MS-555 2656-V-S-3\tURGEL CHARETTE TRANSPORT LTEE\tJusqu'au 15 septembre 1974 ou jusqu'à décision finale.Until September 15, 1974 or final decision.\tk) De Rivière-Beaudette, Cteoau-du-Lac, St-Dominique, St-Féréol, Coteau Station, Str-Zotique et Coteau à Montréal, et retour.Restriction: Le droit de transbordement au terminus de Coteau-du-Lac est restreint au transport de marchandises dans des remorques appartenant à des transporteurs américains détenteurs de permis de l'Interstate Commerce Commission et livrées à Valleyfield par Penn Central Transportation Company, en vertu de leurs services réguliers de « piggy back ».La clause k décrite dans ce présent permis remplace la clause k qui existe dans le permis permanent numéro 2656-V.Les remorques utilisées dans le cadre du service décrit dans la clause k ci-dessus décrite, devront être immatriculées conformément aux lois de la Province de Québec.Ce permis est accordé et devra être opéré conjointement avec un permis de l'Interstate Commerce Commission.(Je) From Rivière-Beaudette, Coteau-du-Lac, St.Dominique, St.Féréol, Coteau Station, St.Zoti-que, and Coteau Landing to Montreal, and return.Restriction: The right of transhipment at the Coteau-du-Lac terminal shall be applicable only for goods carried in trailers belonging to American carriers holding permits from the Interstate Commerce Commission, such goods being delivered in Valleyfield by Penn Central Transportation Company, unter the terms of their regular piggy back services.Clause k quoted in this permit replaces clause k that appears in the present permanent permit numbered 2656-V.The trailers utilized under the terms of the service described in clause k hereinabove stated must be registered in conformity with the laws of the Province of Québec.This permit is granted and must be operated concurrently with a permit from the Interstate Commerce Commission.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t MCR-827\t02-04-74\t23328-V\t1-19-49\t4413\t28-07-73\tM-4407\tRejetée / Rejected \t\tLEONARD RAVENELLE\t\t\t\t\t MCR-828\t02-04-74\t6715-V\t2-26-37\t1484\t10-03-73\tM-3529\tDésistement \t\tLA CIE LABELLE\t\tà/io\t\t\tWithdrawal M.CR-829\t\tTRANSPORT LTEE\t\t1487\t\t\t \t02-04-74\t23379-V\t\t4727\t11-08-73\tM-4526\tAccordée avec restric- \t\tRUTAN INC.\t\t\t\t\ttion telle qu'amendée Granted as amended with restriction MCR-830\t02-04-74\t21912-V\t3-23-2\t2183\t14-04-73\tM-4079\tAccordée / Granted MCR-834\t03-04-74\tTRANSPORT GERARD INC.92-V ASBESTOS EASTERN TRANSPORT INC.\t3-13-17\t2244 2245\t14-04-73\tM-3861\tDésistement Withdrawal 3204 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicants\tBulletin\tpage\tdate\tCase\tDécisions MCS-416\t04-04-74\t23312-V\t1-16-18\t4122\t04-07-73\tM-4489\tAccordée en partie \t\tLLOYD THE MOVER (Lloyd Robert Borne)\t\t\t\t\tPartly granted MCS-417\t04-04-74\t12353-V\t1-1-171\t2584\t29-04-73\tM-4164\t \t\tE.T.TANK LINES LTD.\t\t\t\t\t \t\t16130-V\t1-1-171\t2585\t28-04-73\tM-4165\t \t\tMODERN TANK LINES\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t\t Décision La Commission accorde les deux requêtes mais ces autorisations ne seront valides qu'en autant que le contrôle des deux détenteurs demeurera le même.Decision The Commission grants the two requests, but these authorizations shall be valid only as for as the control of the twoo holders remains unchanged.ML-239\t04-04-74\t847-DYV\t1-18-181\t2975\t12-05-73\tM-4316\tAccordée en partie \t\tLACTON LEASING INC.\t\t\t\t\tPartly granted \t\tLOCATION LACTON\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t\t DECISION DE LA COMMISSION « PROPRIO MOTU » / DECISION \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION MOR-819 TF 02-04-74 30003 MD-6-TF BT-1 BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Décision La Commission corrige sa décision MCR-639-TF de 11/1/74 relativement au cautionnement déposé par la requérante.MPV-224 | 1948-A-P-l UNCLE HARRY'S BUS SERVICE INC.Décisions La Commission : Annule la décision rendue en date du 6 novembre, numéro MPV-74.Requiert le paiement à la Commission des transports du Québec par la requérante « Uncle Harry's Bus Service Inc.de la somme de $25.00 qui lui avait été remise par inadvertance par le biais de la décision portant le numéro MPV-74.1664 02-03-74 M-1157 Decision The Commission corrects its decision MCR-639-TF dated 11/1/74 as regards the deposit paid by the applicant.1664 02-03-74 M-1155 Decisions The Commission: Cancels the decision rendered on November 5, number MPV-74.Requires the payment to the Québec Transport Commission by the applicant, \"Uncle Harry's Bus Service Inc.\"., of a sum of 825.00 which had been reimbursed to said applicant inadvertently, in conformity with the decision bearing number MPV-74.SEANCES EN CHAMBRE/SITTINGS IN CHAMBERS ML-264\t18-03-74\t1282-DY-D-l SOCIETE DE LOCATION DE RAWDON INC.\t\t102\t12-01-74\tM-873\tAccordée / Granted ML-256\t18-03-74\t1268-DY-D-l JACQUES ROCHELEAU\t\t5588\t29-09-73\tM-185\tAccordée / Granted ML-256\t\t& ROMEO BOUCHARD\t\t\t\t\t \t18-03-74\t1268-DY-D-2 JACQUES ROCHELEAU\t\t102\t12-01-74\tM-782\tAccordée / Granted MSM 7 TF\t\t& ROMEO BOUCHARD\t\t\t\t\t \t21-03-74\t257-N-D-l TF LES BATEAUX\t\t917\t18-02-74\tM-935\tAccordée / Granted MCR-820 TF\t\tALOUETTE INC.\t\t\t\t\t \t02-04-74\t30006-D-l-TF NIAGARA FRONTIER TARIFF BUREAU INC.SOUTHERN MOTOR CARRIERS RATE\t\t122\t12-01-74\tM-866\tAccordée / Granted MCR-821 TF\t\tCONFERENCE\t\t\t\t\t \t02-04-74\t30007-TF\t\t101\t12-01-74\tM-780\tAccordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3205 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t MCR-822\t02-04-74\t30007-D-l-TF\t\t118\t12-01-74\tM-853\tAccordée / Granted TF\t\t\t\t\t\t\t MCR-823\t02-04-74\t365-V-D-l-TF\t\t109\t12-01-74\tM-814\tAccordée / Granted TF\t\tFORGET TRANSPORT INC.\t\t\t\t\t MCR-824\t02-04-74\t30003-D-7-TF\t\t1129\t02-02-74\tM-985\t TF\t\tBUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.\t\t\t\t\t Décisions Accordée avec condition comme suit: L'acceptation définitive des modifications, est sujette à la production des contrats touchant les intérims suivants: Supplément intérim No 1848 BEAULIEU TRANSPORT LTEE.Augmentation: Supplément intérim No 1866 TRANSPORT A.CAYER INC.Augmentation - annulation.Supplément intérim No 1868 LAPOINTE ET FILS LTEE.Augmentation.Supplément intérim No 1987 GENESSE TRANSPORT INC.Augmentation.Supplément intérim No 1907 TREMBLAY EXPRESS LTEE.Augmentation.Supplément intérim No 1948 HUSBAND TRANSPORT (QUEBEC) LTD.Addition.Supplément intérim No 1897 BOURRET TRANSPORT LTEE.Augmentation - Addition - Annulation.Et les taux ci-haut décrits n'entreront en vigueur que sur confirmation écrite de l'administrateur de la Commission des transports de la réception des documents en cause.Les tarifs, sauf ceux touchés par la condition précédemment décrite n'entreront en vigueur que dans les délais légaux, quant à ceux touchés par la restriction antérieurement énoncée, ils entreront en vigueur un fois les conditions remplies et les délais légaux expirés.MCR-825 02-04-74 11717-V-D-l-TF TF YVON LAROCQUE TRANSPORT LTEE MCR-826 02-04-74 12316-V-D-l-TF TF DENIS TRANSPORT ENR'G.MCR-831 03-04-74 870-V-D-l-TF TF GEO.A.HALL CARTAGE CO.LTD.MCR-832 03-04-74 11217-V-TF TF ATOMIC TRUCK CARTAGE LTD.MCR-833 03-04-74 250-V-D-l-TF TF JOS TONDREAU & FILS INC.MCR-835 04-04-74 30003-D-9-TF TF BUREAU DES TARIFS DU QUEBEC INC.Décisions La Commission accorde la requête mais l'acceptation définitive de ces modifications est sujette à la production des contrats touchant les intérims suivants : Numéro 1898 MCCRUM TRANSPORT M CP.EXPRESS CO.Numéro 1856 CHALUT TRANSPORT INC.M pour la clause F.DESROCHERS & FILS, pour la clause H.F.Decisions Granted under the following condition : The final acceptance of the modifications is subject to the production of the contracts respecting the following interims: Interim supplement No.1848 BEAULIEU TRANSPORT LTEE.Increase.Interim supplement No.1866 TRANSPORT A.CAYER INC Increase - cancellation.Interim supplement No.1868, LAPOINTE ET FILS LTEE.Increase.Interim supplement No.1987, GENESSE TRANSPORT INC Increase.Interim supplement No.1907 TREMBLAY EXPRESS LTEE.Increase.Interim supplement No.1948 HUSBAND TRANSPORT (QUEBEC) LTD.Addition.Interim supplement No.1897 BOURRET TRANSPORT LTEE.Increase - addition - cancellation.And the rates hereinabove described shall come into force only upon written confirmation by the Administrator of the Transport Commission upon receipt of the documents required.The tariffs, except for those affected by the condition previously stated, shall come into force only within the prescribed time limits; as regards those affected by the restriction previously set forth, they shall come into force when the conditions are complied with and when the legal time limits have expired.6818 1290 110 108 122 1546 17-11-73 09-02-74 21-01-74 21-01-74 21-01-74 23-02-74 M-611 M-999 M-820 M-810 M-868 M-1065 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Decisions The Commission grants the request, but the final acceptation of these modifications is subject to the production of contracts affecting the following interims: Number 1898 MCCRUM TRANSPORT us CP.EXPRESS CO.Number 1856 CHALUT TRANSPORT INC.vs for clause F.DESROCHERS & FILS for clause H.F.HARNOIS 3206 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 197J,, Vol.106, No.17 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicants\tBulletin\tpage | date\tCase\tDécisions HARNOIS LTEE.pour la clause N.LOUIS DESROCHERS & FILS.Numéro 1989 LEMAIRE EXPRESS INC.vs DOMINION TEXTILE LTD.Numéro 1843 ASBESTOS-EASTERN TRANSPORT INC.vs TEXTILE.RUBBER & CHEMICAL CO.(CAN.) LTD.et les taux ci-hauts décrits n'entreront en vigueur que sur confirmation écrite de l'administration de la Commission de la réception des documents en cause.Les tarifs, sauf ceux touchés par la condition précédemment décrite n'entreront en vigueur que dans les délais légaux, quant à ceux touchés par la restriction antérieurement énoncée, ils entreront en vigueur une fois les conditions remplies et les délais légaux expirés.LTEE for clause N.LOUIS DESROCHERS & FILS.Number 1989 LEMAIRE EXPRESS INC.vs DOMINION TEXTILE LTD.Number 1843 ASBESTOS-EASTERN TRANSPORT INC vs TEXTILE RUBBER & CHEMICAL CO.(CAN.) LTD.and the rates hereinabove described shall come into force only on the written confirmation of the Administrator of the Commission upon receipt of the documents required.The tariffs, except for those affected by the condition previously stated shall come into force within the legal time limits; as regards those affected by the restriction previously set forth, they shall come into force when the conditions are complied with and when the legal time limits have expired.04-04-74 04-04-74 04-04-74 04-04-74 04-04-74 675-V-D-l-TF ROGERS TRANSPORT INC.22820-V-D-2 RHEAULT GAREAU Requérant-vendeur Applicant-vendor STERIVAN INC Requérante-acquéreur Applicant purchaser 23389-V-D-l ANDRE LABRECQUE 23518-V-D-l ROYAL RACICOT 23561-V-D-l JEAN-GUY PARE CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS TARIFF BUREAU ASS'N 40003-D-2-TF 40003-D-6-TF 02-04-74 02-04-74 02-04-74 40003-D-4-TF 02-04-74 02-04-74 02-04-74 04-04-74 04-04-74 04-04-74 04-04-74 04-04-74 40003-D-l-TF 40003-D-5-TF 19614-V-D-l-TF FLORIDA REFRIGERATED SERVICE INC.4549-V-D-l-TF LIPARI MOVING & CARTAGE LTD.23469-V-D-l JEAN HOULE Voiturier-remorqueur Haulaway operator 17645-V-D-l METRO LIQUID CARRIERS (1966) LTD.Voiturier-roulier / Carrier 139-A-D-2 BRI8SETTE & FRERES LTEE 1076-DYV-D-l A.T.I.LEASING (Maurice Spector) 1072-DYV-D-l KALITE REG'D.(Mme Katchleen M.Prud'homme) 6821\t17-11-73\tM-622\tAccordée / Granted 7412\t15-02-73\tM-742\tAccordée / Granted 130\t12-01-74\tM-918\tAccordée / Granted 130\t12-01-74\tM-915\tAccordée / Granted 327\t19-01-74\tM-897\tAccordée / Granted 123\t12-01-74\tM-872\tAccordée / Granted 128\t12-01-74\tM-910\tAccordée / Granted 128\t12-01-74\tM-909\tAccordée / Granted 123\t12-01-74\tM-873\tAccordée / Granted 128\t12-01-74\tM-908\tAccordée / Granted 110\t12-01-74\tM-816\tAccordée / Granted 122\t12-01-74\tM-869\tAccordée / Granted 121\t12-01-74\tM-856\tAccordée / Granted 121\t12-01-74\tM-857\tAccordée / Granted 7412\t15-12-73\tM-744\tAccordée / Granted 132\t12-01-74\tM-929\tAccordée / Granted 132\t12-01-74\tM-931\tAccordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106- année, n° 17 3207 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t ML-268\t04-04-74\t828-DYV-D-l\t\t132\t12-01-74\tM-930\tAccordée / Granted \t\tTOD VEHICLES\t\t\t\t\t \t\t(QUEBEC) INC.\t\t\t\t\t AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS\t\t\t\t\t\t\t MCR-851\t10-04-74\t23292-V-D-l\t\t6425\t03-11-73\tM-428\tDésistement \t\tJEAN-PAUL LAGARIERE\t\t\t\t\tWithdrawal MCR-852\t10-04-74\t23193-V\t1-31-13\t2396\t21-04-73\tM-4246\t \t\tTRANSPORT PHOENIX\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t\t \t\tDécision\t\t\t\tDecision\t La Commission accorde la requête mais le permis ne sera The Commission grants the request but the permit shall\t\t\t\t\t\t\t valide qu'à la condition que les compagnies TRANSPORT be valid on\t\t\t\t\tcondition that TRANSPORT PHOENIX INC.\t\t PHOENIX INC.et PRODUITS D'ACIER PHOENIX and PRODUITS D'ACIER PHOENIX LTEE be controlled\t\t\t\t\t\t\t LTEE soient\tcontrôlées par les mêmes actionnaires.\t\tby the same shareholders.\t\t\t\t MCR-853\t10-04-74\t23193-V\t1-14-85\t3882\t30-06-73\tM-4386\t \t\tTRANSPORT PHOENIX\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t\t \t\tDécision\t\t\t\tDecision\t La Commission accorde la requête mais le permis ne sera The Commission grants the request but the permit shall\t\t\t\t\t\t\t valide qu'à la condition\t\tque les compagnies TRANSPORT only be valid on condition that the companies TRANSPORT\t\t\t\t\t PHOENIX INC.et PRODUITS D'ACIER PHOENIX PHOENIX\t\t\t\t\tINC.and\tPRODUITS D'ACIER PHOENIX\t LTEE soient contrôlées par les mêmes actionnaires.\t\t\tLTEE be controlled by the same shareholders.\t\t\t\t MCS-430\t10-04-74\t15911-V\t3-8-39\t1780\t24-03-74\tM-3707\tDésistement \t\tQUEENSWAY TANK\t\t\t\t\tWithdrawal \t\tLINES LTD.\t\t\t\t\t MPV-226\t09-04-74\t3415-A-D-l\t\t6602\t29-09-73\tM-247\t TF\t\tCOMMISSION DE\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT DE LA\t\t\t\t\t \t\tCOMMUNAUTE\t\t\t\t\t \t\tREGIONALE DE\t\t\t\t\t \t\tL'OUTAOUAIS\t\t\t\t\t \t\tDécision\t\t\t\tDecision\t La Commission fixe le coût normalisé au montant de S99.00 The Commission fixes the standardized cost at ?99.00 per\t\t\t\t\t\t\t par année par écolier transporté quotidiennement, une fois à year per pupil transported daily, for the round trip.\t\t\t\t\t\t\t l'aller et une fois au retour.\t\t\t\t\t\t\t MCV-5\t10-04-74\t23341-V\t1-18-6\t4286\t21-07-73\tM-4504\tRejetée / Rejected \t\tGASTON HEBERT\t\t\t\t\t MCV-6\t10-04-74\t12425-V\t\t4718\t11-08-73\tM-1530\tRejetée / Rejected \t\tLEO TREMBLAY\t\t\t\t\t \t\tTRANSPORT INC.\t\t\t\t\t MCV-7\t10-04-74\t22372-V\t\t4729\t11-08-73\tM-4523\tRejetée / Rejected MCV-8\t\tBILLETTE & D'ARCY\t\t\t\t\t \t10-04-74\t22336-V\t1-18-3\t4285\t21-07-73\tM-4517\tRejetée / Rejected MCV-9\t\tWILBROD LECLERC\t\t\t\t\t \t10-04-74\t22337-V\t\t4138\t14-07-73\tM-4503\tRejetée / Rejected \t\tROGER LECLERC\t\t\t\t\t QCR-619\t08-04-74\tQ-18739-V-D-1\t\t4800\t18-08-73\tQ-13\tAccordée / Granted \t\tJEAN-MARIE\t\t\t\t\t \t\tLACHARITE\t\t\t\t\t QCR-520\t08-04-74\t20017-V-D-2\t\t6971\t24-11-73\tQ-391\t \t\tLA CIE GASPESIA\t\t\t\t\t \t\tRIMOUSKI LTEE\t\t\t\t\t \t\tRequérante / Applicant\t\t\t\t\t \t\t21508-V\t\t\t\t\t \t\tLAUREAT CANUEL\t\t\t\t\t \t\tIntimée / Defendant\t\t\t\t\t \t\tDécision\t\t\t\tDecision\t La Commission déclare ne pas devoir procéder sur la pré- The Commission declares that it will not consider the sente demande et clôt ce dossier à toutes fins que de droit.present request and that for all legal purposes this file is closed 3208 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 \t\t\t\tG.O.Q.\t\tCause\t No\tDate\tRequérants\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t QCR-521\t08-04-74\t810-V\t\t2200\t14-04-73\tqh1093\tRejetée / Rejected \t\tARTHUR LA VOIE\t\t\t\t\tRejetée / Rejected QCR-523\t10-04-74\t22173-V-D-l\t\t5769\t06-10-73\tQ-192\t \t\tCHO-BO INC.\t\t\t\t\t \t\t13175-V-D-2\t\t\t\t\t \t\tGRONDIN TRANSPORT\t\t\t\t\t \t\tINC.13176-V-D-2\t\t6411\t03-11-73\tQ-313\tAccordée / Granted \t\tGrondin transport\t\t\t\t\t \t\tinc.\t\t\t\t\t \t\t22173-V-D-l\t\t\t\t\t \t\tCHO-BO INC.\t\t\t\t\t qcs-286\t08-04-74\t23281-V\t\t4122\t14-07-73\tQ-380\tRejetée \t\tSA YARD & VACHON\t\t\t\t\tRejected for default \t\tINC.\t\t\t\t\t QCS-287\t08-04-74\t21508-V\t\t4715\t18-08-73\tQ-390\t \t\tLAUREAT CANUEL\t\t\t\t\t Décision La Commission: 1.Prend acte de la demande de retrait, par le requérant, de sa demande dans la présente cause: 2.Décide d'agir proprio motu, pour révoquer tout le permis du requérant sauf le permis se référant à son droit de remorquage.Decision The Commission: 1.Acknowledges the applicant's request for withdrawal of his application in the present cause; 2.Decides to act proprio motu to revoke the whole permit of the applicant except the permit relating to its right of haulaway.SÉANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS MCR-841 TF MCR-842 TF MCR-843 TF MCR-844 TF MCR-845 TF MCR-846 MCR-847 MCR-854 MCS-418 TF 09-04-74 09-04-74 09-04-74 09-04-74 09-04-74 09-04-74 09-04-74 10-04-74 10-04-74 20380-V-D-l-TF BRISSETTE TRANSPORT LTEE 30007-D-2-TF SOUTHERN MOTOR CARRIERS RATE CONFERENCE 6577-V-D-l-TF ASBESTOS EXPRESS LIMITEE 20162-V-D-l-TF LEDUC TRANSPORT ENRG.1807-V-D-l-TF DONNAN CARTAGE INC 14604-V-D-l GASTON BARIBEAULT Requérant vendeur A pplicant-vendor TRANSPORT BARIBEAULT LTEE Requérante acquéreur A pplicant-purchaser 23534-V-D-l ROGER CYR 15594-V THIBEAU TRANSPORT LIMITED Mise en cause DELMER THIBEAU MARION THIBEAU GRAHAM WALSK Requérant-vendeurs A ppticant-vendors MARELLEN HOLDINGS LIMITED THOMAS BARKER Requérant acquéreur Applicant purchaser 22752-V-D-l-TF M.DROLET TRANSPORT 110 1548 1290 1548 110 922 923 4930 1547 12-01-74 18-03-74 09-02-74 18-03-74 12-01-74 26-01-74 26-01-74 25-08-73 23-02-74 M-818 M-1070 M-1001 M-1068 M-817 M-965 M-967 m-1066 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106- année, n' 17 3209 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t \t\tA pplicants\t\t\t\tCase MCS-419\t10-04-74\t7306-V-D-l-TF\t\t122\t12-01-74\tM-867 TF\t\tGAUTHIER\t\t\t\t \t\tTRANSPORT ENR'G\t\t\t\t MCS-420\t10-04-74\t186-V-D-2\t\t131\t12-01-73\tM-925 \t\tHOULE EXPRESS LTEE\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t15140-V-D-l\t\t132\t12-01-74\tM-926 \t\tDELSON TRANSPORT\t\t\t\t \t\tLTEE\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t MCS-421\t10-04-74\t23427-V-D-l\t\t325\t19-01-74\tM-890 \t\tHELENE GROSS\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t6793-V-D-19\t\t325\t19-01-74\tM-891 \t\tBRAZEAU TRANSPORT\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t MCS-422\t10-04-74\t23467-V-D-2\t\t920\t26-01-74\tM-946 \t\tGERARD ROY\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t6793-V\t\t\t\t \t\tBRAZEAU TRANSPORT\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t MCS-423\t10-04-74\t5477-V-D-l-TF\t\t1546\t23-02-74\tM-1064 TF\t\tBULK CARRIERS\t\t\t\t \t\t(QUEBEC) LIMITED\t\t\t\t MCS-424\t10-04-74\t14176-V-D-l-TF\t\t1547\t23-02-74\tM-1067 TF\t\tALLIED CARTAGE\t\t\t\t \t\t& WAREHOUSES INC.\t\t\t\t MCS-425\t10-04-74\t7694-V-D-l-TF\t\t1546\t23-02-74\tM-1062 TF\t\tWESTERN CRATING\t\t\t\t \t\t& MOVING LTD.\t\t\t\t MCS-426\t10-04-74\t1256-V-D-l-TF\t\t1546\t23-02-74\tM-1061 TF\t\tA & F BAILLARGEON\t\t\t\t \t\tEXPRESS INC.\t\t\t\t MCS-427\t10-04-74\t13093-V-D-l-TF\t\t1546\t23-02-74\tM-1063 TF\t\tRENE CYR\t\t\t\t \t\tTRANSPORT LTEE\t\t\t\t MCS-428\t10-04-74\t23511-V-D-l\t\t131\t12-01-74\tM-921 \t\tRAYMOND MASSE\t\t\t\t \t\tVoiturier-remorqueur\t\t\t\t \t\tHaulaway operator\t\t\t\t \t\t5427-V-D-2\t\t131\t12-01-74\tM-922 \t\tRIMOUSKI TRANSPORT\t\t\t\t \t\tLTEE\t\t\t\t \t\tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t\t MCS-429\t10-04-74\t19926-V-D-2\t\t922\t26-01-74\tM-966 \t\tTRANS CANADA\t\t\t\t \t\tTRANSFER à\t\t\t\t \t\tSTORAGE INC.\t\t\t\t ML-270\t10-04-74\t5-DYV-D-2\t\t126\t12-01-74\tM-900 TF\t\tDAOUST DRIVE\t\t\t\t \t\tYOURSELF (1964)\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t QCR-518\t05-04-74\t6865-VD1-TF\t\t1119\t02-02-74\tQ-581 TF\t\tTRANSPORT\t\t\t\t \t\tPELLETIER ENRG.\t\t\t\t \t\tModification de tarifs\t\t\t\t \t\tModification of tariffs\t\t\t\t QCR-522\t09-04-74\t10207-V-D-l-TF\t\t1119\t02-02-74\tQ-582 TF\t\tTESSIER & FILS\t\t\t\t \t\tLIMITEE\t\t\t\t \t\tModification de tarisf\t\t\t\t \t\tModification of tariffs\t\t\t\t QCS-285\t08-04-74\tQ-23039-V-D-2\t\t1121\t02-02-74\tQ-590 \t\tSEPT-ILES TRANSPORT\t\t\t\t Décisions Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted 3210 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 37, 1974, Vol.106, No.17 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t No\tDate\tRequérants Applicants\tBulletin\tpage\tdate\tCause Case\tDécisions QPV-270\t05-04-74\t3022-AD-l\t\t913\t26-01-74\tQ-569\tAccordée / Granted \t\tMARCEL ALLARD Requérant-vendeur Applicant vendor AUTOBUS ALLARD INC.Requérant-acquéreur\t\t\t\t\t QL-120\t05-04-74\tApplicant purchaser 1022-DY D-l TF\t\t119\t12-01-74\tQ-540\tAccordée / Granted TF\t\tLEPACK AUTOMOBILES INC.Modification de tarifs\t\t\t\t\t \t\tModification of tariffs\t\t\t\t\tAccordée / Granted QPT-4\t10-04-74\tQ-201043 D-4\t\t1446\t16-02-74\tQ-667\t \t\tJEROME DOUCET Requérant-vendeur A pplicant-vendor 'Jons.-,,-, ALBERTUS TREMBLAY Requérant-acquéreur\t\t\t\t\t QPT-6\t\tA pplieant-purchaser\t\t\t\t\t \t10-04-74\tQ-200914-D-2\t\t1446\t16-02-74\tQ-669\tAccordée / Granted \t\tOSCAR PARENT\t\t\t\t\t \t\tRequérant-vendeur\t\t\t\t\t \t\tA pplicant-vendor\t\t\t\t\t \t\t201028-D-l\t\t\t\t\t \t\tRADIO TAXI GUAY\t\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t\t QPT-6\t10-04-74\tQ-200351\t\t1446\t16-02-74\tQ-664\tAccordée / Granted \t\tLAURENT PARADIS\t\t\t\t\t \t\tRequérant-vendeur\t\t\t\t\t \t\tA pplicant-vendor\t\t\t\t\t \t\t200127\t\t\t\t\t \t\tMICHEL PILOTE\t\t\t\t\t \t\tRequérant-acquéreur\t\t\t\t\t QPT-7\t\tA pplieant-purchaser\t\t\t\t\t \t10-04-74\tQ-200755 JULES BARBER Requérant-vendeur Applicant-vendor 20075B ROLAND TREMBLAY Requérant-acquéreur A pplieant-purchaser\t\t1446\t16-04-74\tQ-665\tAccordée / Granted QPT-8\t10-04-74\tQ-201043-D-6 JEROME DOUCET Requérant-vendeur A pplicant-vendor 201075 MARCEL MARCEAU Requérant-acquéreur\t\t1446\t16-04 74\tQ-666\tAccordée / Granted QPT-9\t\tApplicant-purchaser\t\t\t\t\t \t10-04-74\tQ-200154 FERNAND DROLET Requérant-vendeur A pplicant-vendor 200155 MARTIN BRIERE Requérant-acquéreur A pplieant-purchaser\t\t1446\t16-04-74\tQ-668\tAccordée / Granted DECISIONS DE LA COMMISSION « PROPRIO MOTU » / DECISIONS \"PROPRIO MOTU\" BY THE COMMISSION\t\t\t\t\t\t\t MCR-848\t09-04-74\t19626-V-P-l REA BROTHERS LIMITED\t\t2343\t23-03-74\tM-1304\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n' 17 3211 \t\t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\t\tCause\t No\tDate\t\tBulletin\tpage\tdate\t\tDécisions \t\tApplicants\t\t\t\tCase\t Décision La Commission corrige le nom d'une des actionnaires dans sa décision MCR-613, du 12/1/73.de Mrs.Honora Philomena Rea à Mrs.Honora Philomena Beresford.MCR-849 09-04-74 1623-V-P-l STAR TRUCK TAXI ASS'N LIMITED Décision La Commission corrige sa décision MCR-556 du 7/12/73 relativement au cautionnement déposé par la requérante et en ajoute le nom de Courchesne et Larose Ltée au service a contrat.MCR-850 09-04-74 18510-V-P-2 NORMAND CLOUTIER TRANSPORT INC.Décision La Commission corrige sa décision MCR-579 du 14/12,73 relativement au cautionnement, déposé par la requérante.Decision The Commission corrects in its decision MCR-613.dated 12/1/73, the name of one of the shareholders, that is, Mrs.Honora Philomena Rea to read as follows: Mrs.Honora Philomena Beresford.2342 23-03-74 M-1489 Decision The Commission corrects its decision MCR-556, dated 7/12/73, concerning the deposit made by the applicant, and adds the name of Courchesne et Larose Ltée in the contract service.2342 23-03-74 M-1447 Decision The Commission corrects its decision MCR-579, dated 14/12/73, concerning the deposit made by the applicant.PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique\tNom du requérant\tValidité: de:.à:\tDétails du permis Chronological Repertory No.\tName of Applicant\tValidity Period\tParticulars of permit MS-533 M 505308 S-l M 505308 S-2 MS-534 1310-DY S-l MS-540 M 505304 S-l M 505304 S-2 MS-541 17788-V S-l\tNORMAN GAMACHE INC.GLENGARRY MOTOR SALES LTD.R.J.GUERIN INC.COOPERATIVE DES DEMENAGEMENTS DU 1er MAI\t\tTransporter à l'année aux frais des expéditeurs des moulées et grains en sacs de la région de Montréal aux régions 5 et 0 et retour avec les camions a bascule et souffleurs./ To transport feed (meal) and grain in bags, on a yearly basis and at the shipper's expense, from the Montreal region to regions 6 and G, and return, by dump trucks equipped with blowers.Refusée / Refected.Location à long terme (un an et plus) de véhicules de commerce et de livraison / Leasing of commercial and delivery rehicles on a long-term basis (one year or more).Refusée / Rejected.Transporter à l'année aux frais des expéditeurs des moulées et grains en sacs et en vrac de la région 5 et région 6 et retour avec les camions à bascule et souffleur / To transport feed (meal) and grain in bags and in bulk on a yearly basis, and at the shipper's expense, from region 5 to region 6 and return, by dump trucks equipped with blowers.Refusée / Rejected.De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de 30 milles, pour le transport de meubles neufs originant des Magasins Cooprix.situés à Montréal, et retour avec marchandises refusées ou avariées, pour le compte de la Fédération des Magasins Co-op 1 From Montreal to any point located within a radius of SO miles, for the transportation of new furniture, originated from Magasins Cooprix, located in Montreal, and return with refused or damaged goods, on behalf of Fédération des Magasins Co-op.Refusée / Rejected. 3212 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-544 254-V S-2 Nom du requérant Name of Applicant ACTON VALE TRANSPORT INC.MS-545 22273-V S-3 REAL LAVOIE Validité: de:.à: Validity Period Jusqu'au 1er mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March 1 1976 or pend-ing final de- Jusqu'au 1er mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March 1, 1976 or pending final decision .Détails du permis Particular! of permit c) De Acton Vale.St-Nazaire, Wickham, South Durham.St-Théodore.Lisgar, Danby, Upton, St-Liboire, Ste-Christine et Roxton Falls à à Montréal et retour.d) De Ste-Cécile-de-Milton, St-Valérien.Roxton Pond (à l'exclusion du rayon de 5 milles de Roxton Pond), Sound Roxton, l'Egypte, l'En-fant-Jésus à Montréal, et retour.Restriction : Le service de cueillette et de livraison n'est pas autorisé dans le rayon de 5 milles des limites de Roxton Pond.g) De St-Majorique à Montréal et retour.Droit additionnel : En donnant le service autorisé par les clauses e, d et o de son permis, la détentrice est autorisée à transporter des marchandises pour le compte de Simpson's Sears Ltd.(permis No 118-DYL dans des remorques louées de Simpson's Sears Ltd., enregistrés au ministère des transports par Simpsons Sears Ltd.et à la Commission des transports par la détentrice et tirées par des tracteurs appartenant à la détentrice et enregistrés au ministère des transports et à la Commission des transports par la détentrice.) (c) Prom Acton Vale, St.Notaire, Wickham.South Durham.St.Théodore, Lisgar.Danby, Upton, St.Liboire, Ste.Christine and Roxton Falls to .Montreal and return.(d) From Ste.Cccile-de-Milton.St.Valérien, Roxton Pond (excluding a radius of 5 miles from Roxton Pond), Sound Roxton, L'Egypte, L'En-fanl-Jésue to Montreal and return.Restriction: No pick-up or delivery service shall be authorized within a radius of 6 miles from the limits of Roxton Pond.(g) From St.Majoriqueto Montreal and return.Additional right: When prpvinding the service authorized by clauses c.d and g of its permit, the permit-holder shall be authorized to transport goods on behalf of Simpson's Sears Ltd.(permit No.118-DYL) in trailers rented from Simpson's Sears Ltd., registered with the Department of Transport by Simpson's Sears Limited and with the Transport Commission by the permit-holder, and hauled with the tractors belonging to said permit-holder, which shall also register said tractors with the Department of Transport and with the Transport Commission.Accordée / Granted.De St-David-de-Falardeau et de Price P.Q,, aux frontières Québec/Etats-Unis (tous ports de sortie), pour transport de bois préparé destiné aux états suivants: Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York.New Jersey, Pennsylvania, Delaware.Maryland, Virginia, Rhose Island et Washington, D.C., pour le compte de Furman Lumber Inc.Condition: Le service décïit dans la présente clause devra être donné en conjonction avec un permis complémentaire à être émis par Interstate Commerce Commission, lequel devra être déposé à la Commission sous peine d'annulation du présent permis.De Waterville à Montréal, Québec, Trois-Ri-vières.Sherbrooke, Drummondville, St-Hyacinthe, Granby et Pont-Rouge, pour le transport de bois préparé pour le compte de Furman Lumber Inc. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril Î974, 106' année, u° 17 3213 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Détails du permis Particulars of permit MS-546 22343-V S-l 1079-V S-l MS-547 1051-V S-l MS-548 23714-V S-l 659-V S-3 MS-549 22988-V S-l RAYMOND LALANNE Requérant f Applicant GENESSE TRANSPORT INC.Requérant conjoint Joint applicant CLAUDE LECLERC TRANSPORT ENRG.Requérant acquéreur Applicant purchaser ROBERT LECLERC Requérant vendeur Applicant vendor PAUL G.DOBSON Partie requérante / Applicant SMITH TRANSPORT CO.LTD.Requérant conjoint Joint applicant MERCURE TRANSPORT ENRG.Jusqu'au 1er mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March I 1975 or pending final decision.Jusqu'au 1er mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March 1 1975 or pending final decision.Jusqu'au 1er mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March 1 1976 or pending final décision.Jusqu'au 1er août 1974 ou jusqu'à décision finale.Until August 1 1974 or pending final de- From St.David-de-Falardeau and Price, P.Q., to the Quebec-United States border (all ports of exit), for the transportation of dressed lumber destined to the following States: Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut.New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Rhode Island and Washington, D.C., on behalf of Furman Lumber Inc.Condition: The service described in the foresaid clause shall be operated with a complementary permit to be issued by the Interstate Commerce Commission, said permit shall be filed with the Commission, failing which, it shall be cancelled.From Waterville to Montreal, Québec, Trois-Ri-vières, Sherbrooke, Drummondville, St.Hyacinthe, Granby and Pont-Rouge, for the transportation of dressed lumber, on behalf of Furman Lumber Inc.Accordée / Granted.Le requérant demande l'autorisation de donner un service de voiturier-remorqueur pour le compte et selon les clauses c, j, o et w du permis permanent du roulier: Genesse Transport Inc., qui agira comme courtier en transport / The applicant requests authorization to provide a haulaway service on behalf of, and according to clauses c, j, v and w of permanent permit held by carrier Genesse Transport Inc., which shall act as transport broker.Accordée / Granted.a) De Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville; b) De Montréal à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles de ladite ville, en suivant les routes principales et retour.Condition: Ce permis spécial sera valide à condition que Robert Leclerc cesse immédiatement les opérations autorisées pajr ledit permis.(a) From Montreal and aiiy point not beyond five (6) miles from thelimits of said City; (b) From Montreal to any point located within a radius of thirty (SO) miles from said City, along the main highways and return.Condition: This special permit shall be valid on condition that Robert Leclerc ceases immediately to operate the services authorized by said permit.Accordée / Granted.Autorisation de donner un service de voiturier-remorqueur pour le compte et selon toutes les clauses du permis permanent du roulier: Smith Transport Co.Ltd.qui agira comme courtier en transport / Authorization to provide a haulaway service on behalf of, and according to all the clauses of the permanent permit held by carrier Smith Transport Co.Ltd., which will act as transport broker.Accordée / Granted.Frontières Québec/Ontario à ailleurs au Québec et retour pour le transport de piscines et accessoires pour le compte de Gaudet et Caron Inc., originant de Acton et Burlington, Ont.Condition: Ce permis devra être opéré conjointement avec un permis complémentaire à être émis par l'Onta/io Highway Transport Board.Québec-Ontario border to any point in the Province of Québec and return, for the transportation of swimming pools and related parts originated 3214 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant MS-550 22183-V S-l MS-550 21094-V S-l DICOM CORPORATION Requérant acquéreur Applicant purchaser STAFF COURIERS Requérant vendeur A pplicant vendor FERNAND SAGE MS-557 23689-V S-l JEAN-GUY RIVEST Validité: de:.à: Validity Period Jusqu'au 14 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March 14.1975 or pending final decision.Jusqu'au 31 novembre 1974 ou jusqu'à décision finale.Until November 31st.1974 or pending final decision.Jusqu'au 15 juillet 1974 ou jusqu'à décision finale.UntilJuly 15.1974 or pending final decision.Détails du permis Particulars of permit from Acton and Burlington, Ont., on behalf of Gaudet el Caron Inc.Condition: This permit shall be operated with a complementary permit to be issued by the Ontario Highway Transport Board.Accordée / Gra nted.De Montréal et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas 5 milles des limites de ladite ville, pour le transport de lettres et colis, d'une pesanteur maximum de deux (2) livres.Condition: Ce permis spécial sera valide à condition que Staff Couriers (Division de Staff Selection Services International Limited) cesse immédiatement les opérations autorisées par son permis.From Montreal and any point not beyond 5 miles from the limits of said City, for the transportation of letters and parcels weighing two (£) pounds or less.Condition: This special permit shall be valid on condition that Staff Couriers (Division of Staff Selection Services International Limited) cease immediately to operate the services authorized by its permit.Accordée / Granted.Transport de mousse de tourbe provenant des comtés de Kamouraska, Portneuf, Rivière-du-Loup, Chicoutimi, Beauce, Bellechasse, Drum-mond, Rimouski et Compton aux frontières Québec/U.S.A.(tous ports d'entrée); à destination des états américains suivants: Nouvelle-Angleterre, Connecticut, New-York.New-Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland et District de Columbia; pour le compte de Blue Star Peat Moss Inc.Ce permis devra être opéré conjointement avec un permis de l'Interstate Commerce Commission.Transportation of peat moss originated from the counties of Kamouraska, Portneuf, Riviére-du-Loup, Chicoutimi, Beauce, Bellechasse, Drum-mond, Rimouski and Compton to the Québec-United States border (all ports of entry) ; destination, the following American states: New England, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland and District of Columbia; on behalf of Blue Star Peat Moss Inc.This permit shall be operated with a permit from the Interstate Commerce Commission.Accordée / Granted.Transport dc grains de semences en sacs, de l'entrepôt de David Lord Ltée, situé à l'Assomption à destination des producteurs situés dans un rayon de 80 milles de l'Assomption et retour à l'usine avec les semences non-utilisées.Le transport est payé par David Lord Ltée Transportation of seeds in bags, from the warehouse of David Lord Ltée.located in l'Assomption, to growers' premises located within a radius of 80 miles from l'Assomption and return to the plant ¦j'ith unused seeds.Transportation costs shall be paid by David Lord Ltée.Accordée / Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril Mi, 106- année, n° 17 3215 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Détails du permis Particulars of permit MS-55R 23688-V-S-l MAURICE BESSETTE MS-559 23687-V-S-I LAURENT LANDRY M3-560 23690-V-S-l REAL GUILLET MS-561 11355-V-S-5 MAISLIN TRANSPORT LTD.jusqu'au 15 juillet 1954 ou jusqu'à décision finale.Until July 15.1974 or pending final decision.jusqu'au 15 juillet 1974 ou jusqu'à décision finale.until July 15, 1975 or pending final decision.jusqu'au 15 juillet 1974 ou jusqu'à décision finale.until July 15, 1974 or pending final decision.du 20 mars 1974 au 19 avril 1974.from March SO, 1974 to April 19,1974- Transport de grains de semences en sacs, de l'entrepôt de David Lord Ltée.situé à l'Assomption à destination de producteurs situés dans un rayon de 80 milles de l'Assomption et retour à l'usine avec les semences non-utilisées.Le transport est payé par David Lord Ltée./ Transportation of seeds in bags, from the warehouse of David Lord Ltée.located in l'Assomption to growers' premises located within a radius of 80 miles frdpi l'Assomption, and return to the plant with unused seeds.The transportation cost shall be borne by David Lord Ltée.Accordée / Granted.Transport de grains de semences en sacs, de l'entrepôt de David Lord Ltée, situé à St-Jean à destination des producteurs situés dans un rayon de 80 milles de St-Jean et retour à l'usine avec les semences non-utilisées.Le transport est payé par David Lord Ltée./ Transportation of seeds in bags, from the warehouse of David Lord Ltée, located in St-Jean to growers' premises located within a radius of 80 miles from St.Jean and return to the plant with unused seeds.The transportation cost shall be borne by David Lord Ltée.Accordée / Granted.Transport de grains de semences en sacs, de l'entrepôt de David Lord Ltée, situé à St-Jean à destination des producteurs situés dans un rayon de 80 milles de St-Jean et retour à l'usine avec les semences non-utilisées.Le transport est payé par David Lord Ltée./ Transportation of seeds in bags, from the warehouse of David Lord Ltée, located in St.Jean to growers' premises located in a radius of 80 miles from St.Jean, and return to the plant with usused seeds.The transportation shall be borne by David Lo rd Ltée.Accordée / Granted.Transport de quatre (4) chargements de machines, excédant les dimensions légales, originant du Texas, au Etats-Unis et à destination de Terre-Neuve.Les voyages se feront de la frontière Québec-Etats-Unis (Port d'entrée: Blackpool), en transit à travers la province de Québec, jusqu'à la frontière Québec-Nouveau-Brunswictc (tous ports d'entrée).Ce permis est sujet à l'obtention d'autorisations de l'Interstate Commerce Commission et New Brunswick Motor Carrier Board, s'il y a lieu.Transportation of four (4) loads oj machinery, exceeding legal size, originated fcpjn Texas, United-States and destined to the Province of Nova Scotia.The itinerary shall be: via the Quebec-United-States border (port of entry: Blackpool), in transit through the Province of Québec, to the Québec-New Brunswick border (any port of entry).This permit is subject to the obtaining of authorization from the Interstate Commerce Commission and from the New Brunswick Motor Carrier Board, as the case may bè.Accordée / Granted. 3216 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-562 1317-DY-S-l MS-563 23686-V-S-l 8123-V-D-l MS-564 i18-DYL-S-2 MS-667 23685-V-S-l Nom du requérant Xame of Applicant CHRISTIN AUTO LOCATION INC.F.DESILETS TRANSPORT ENRG.Requérant / Applicant JOHN N.BROCKLESBY TRANSPORT LTD.Requérant conjoint / Joint applicant.SIMPSON'S SEARS LTD.R.D.CARTAGE DKUMMONDVILLE INC.Requérant vendeur A pplicant-rendor MARCEL BERGERON Requérant-acheteur A pplieant-purchaser Validité: de:.à: Validity Period jusqu'au 18 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March IS, 1975 or pending final decision.jusqu'au 1er mars 1975 ou jusqu'à décision finale.nnft7 March 1, 1976 or pending final decision.Détails du permis Particulars of permit jusqu'au 1er mars 1975 or jusqu'à décision finale.until March 1 1976 or pending final decision.jusqu'au 1er mars 1974 ou jusqu'à décision finale.until March 1.1976 or pending final decision.Service de location de véhicules de promenade à court terme, à ses propres clients et aux clients de Christin Automobile pendant que leur véhicule est en réparation et/ou inspection audit garage à l'adresse mentionnée ci.haut./ Servue for the leasing of pleasure vehicles on a short-term basis to its own custo/ners and those of Christin Automobile, while their vehicles are being repaired or inspected at the aforesaid address.Accordée / Granted.Le requérant demande l'autorisation de donner un service de voiturier-remorqueur pour le compte et selon les clauses suivantes: a, b.e, d, f, g, h.k, n, o, p.q.et r et la clause service à contrat pour le compte de Kingsway Transport Limited; du permis permanent du roulier: John N.Brocklesby Transport Ltd.qui agira comme courtier en transport 8123-V./ The applicant requests authorization to provide a haulaway service on behalf of carrier John N.Brocklesby Transport Ltd.according to clauses a, b, c, d.f, g, h, k, n, o, p.q and r and to the contract service clause on behalf of Kingsway Transport Limited of the permanent permit of said carrier (John Ar.Brocklesby Transport Ltd.), with shall act as transport broker (8123-V).Accordée / Granted.Location de véhicules de commerce et de livraison (remorques) à Acton Vale Transport Inc., 364.boul.Rexton, Acton Vale.Cté Johnson, pour le transport de marchandises pour le compte de Simpson's Sears Ltd., conformément au contrat déposé à la Commission en date du 1er août 1973.Condition et restriction: Acton Vale Transport Inc., devra obtenir de la Commission les plaques nécessaires pour être apposées aux véhicules loués de Simpson's Sears Ltd.durant la période de location pour faite la livraison des marchandises pour le compte de Simpson's Sears Ltd.Leasing of commercial and delivery vehicles (trailers) to Acton Vale Transport Inc., 364, Rexton Blvd, Acton Vale, County of Johnson, for the transportation of goods on behalf of Simpson's Sears Ltd., according to a contract dated August 1st.1973, and filed with the Commission.Condition and restriction: Acton Vale Transport Inc, must obtain from the Commission the plates required to be affixed, during the leasing period, to the vehicles rented from Simpson's Sears fiii\"»?' to PTovii' a delivery service on behalf of Simpson's Sears Ltd.Accordée / Granted.«o5ra f°PéreT '«dite clause d du permis 17229-V du requérant-vendeur.Ce permis spécial sera valide à condition que le requérant-vendeur R.D.Cartage Drummond-viiie Inc., cesse immédiatement les opérations autorisées par ledit permis.Urw1 V°»nFral'.-mid daY,e d \"I permit 177229- V of the applicant-vendor.I his special permit shall be valid on condition that the applicant-vendor.R.D.Cartage Drummond-l \"!\"?, immediately to operate the ser-vices authorized by said permit.Accordée / Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1971,, 106- année, n° 17 3217 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicant Détails du permis Particulars of permit MS-568 17491-V-S-2 J.LEBOEUF CARTAGE INC.MS-569 23734-V-S-l MS-570 23516-V-S-2 WALTER PELLEY C.H.HEIST LTD.jusqu'au 15 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.until March 16, 1976 or pending final decision.jusqu'au 25 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.until March SO, 1976 or pending final decision.jusqu'au 20 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.Until March SO, 1976 or pending final decision.Prolongation du permis spécial ci-après: Droit additionel: A l'occasion du service donné par la clause a de son permis, la détentrice aura le droit de transporter les remorques appartenant à des transporteurs américains soumis à la juridiction de l'Interstate Commerce Commission et arrivant par Pen Central Railway Co.à la rampe de Valleyfield et qui doivent être remorquées jusqu'à la cour qui leur est destinée.A la clause a du permis 2911-V qui se lit comme suit: a) St-Stanislas de Kostka et tous les endroits situés sur une distance ne dépassant par 5 milles des limites de ladite municipalité.Extension of the following special permit: Additional right: In operating the service according to clause a of its permit, the permit-holder shall be authorized to haul the trailers belonging to American carriers under the jurisdiction of the Interstate Commerce Commission and arriving by Penn Central Railway Co.at the ramp in Valleyfield, and which are to be hauled to the yards to which they are respectively destined.To clause a of permit 2911-V which reads as follows: (a) St.Stanislas-de-Kostka and any point located over a distance of not niore than 5 miles from the limits of said M unicipality.Accordée / Granted.Montréal-Métrololitain pour le transport d'équipement électronique pour le compte de Univac Development & Manufacturing, division de Sperry Rand Canada Ltd.Restriction : Ce transport ne pourra être effectué avec un camion excédant une capacité de trois (3) tonnes.Greater Montreal for the transportation of electronic equipment on behalf of Univac Development & Manufacturing, division of Sperry Rand Canada Ltd.This transportation service shall be provided only with a truck having a maximum capacity of not more tha n three (3) tons.Accordée / Granted.Montréal-Métropolitain transport de rebuts pétroliers ou dérivés de ces derniers, rebuts chimiques ou autres rebuts par camions citernes spécialement munis d'une pompe servant à l'écu-mage ou à vider les contenants qui contiennent ces rebuts.Dans tous les cas ces produits seront incinérés ou enfouis dans le sol pour le compte de Gulf Oil Canada Limited.Canada Packers Limited.Laurentide Chemicals & Sulphur Ltd., Palmont Packers Ltd.et Petrofina Canada Ltd.Restriction: Ce transport ne sera effectué que si la détentrice a contracté pour le nettoyage de réservoirs ou contenants.Greater Montreal transportation of petroleum waste or by-products, chemical waste or other waste by tank trucks specially equipped with a pump utilized to skim or unload the containers filled with such waste.In each case these products shall be burnt or buried, on behalf of Gulf Oil Canada Limited, Canada Packers Limited, Laurentide Chemicals & Sulphur Ltd., Palmont Packers Ltd.and Petrofina Canada Ltd.Restriction: This transportation service shall be provided on condition that the permit-holder have 3218 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-571 1654-A-S-2 MS-572 23730-V-S-l 158-DYL Nom du requérant Name of Applicant 1IENEAULT TRANSPORT INC.MS-573 23729-V-S-l JEAN-PIERRE MONETTE Partie-requérante / Applicant ROMEO MONETTE LTEE Requérante-conjointe J oint-applicant J.P.GIROUX TRANSPORT ENRG.Validité: de:.à: Validity Period le 29 et 30 mars 1974 29 and 30 March 1974.jusqu'au 25 mars 1975 ou jusqu'à décision finale Until March 25.1975 or pending final decision.jusqu'au 25 mars 1975 ou jusqu'à décision finale.until March 26, or pending final décision.Détails du permis Particulars of permit signed a contract for the cleaning of the tanks or containers.Accordée / Granted.Autorisation de faire le voyage à charte-partie suivant : Point de départ: St-Samuel de Morton Destination: Sherbrooke Date du départ: 29 mars 1974 Retour: 30 mars 1974 Autobus requis: 1 .,,,\u201e., .Authorization to provide the following charter trip-Starting point: St.Samuel de Horton Destination: Sherbrooke Date of departure: March 29.1974 Return: March 30.1974 No.of buses required: I Accordée / Granted.Des raffineries de Montréal-est au plan de Roméo Monette Ltée, situé au 3200 Henri-Bourassa est, à Montréal; pour le transport d'huile à chauffage, par remorque-citerne, et pour le compte de ladite expéditrice.From the rt fineries in Montreal-East to the premises of Roméo Monette Ltée.located at 3200 Henri-Bourassa East, Montreal, for the transportation of heating oU by tank-trailir on behalf of said shipper.Restriction: Pour pouvoir donner le service précité, le détenteur devra utiliser la remorque-citerne appartenant à et louée de Roméo Monette Ltée, qui l'aura immatriculée à Province, et laquelle sera immatriculée à la Commission par Jean-Pierre Monette, en vue pour ce dernier de la tirer avec son tracteur dûment immatriculé à la Province et à la Commission, pour donner le service sus-mentionné pour le compte de Roméo Monette Ltée.Ce service est sujet aux conditions qui s'appliquent habituellement à ce genre de service et dont une copie est annexée à la présente.Restriction- I n order to provide the aforesaid service, the permit holder shall utilize a tank trailer belonging to and rented from Romeo Monette Ltée, which shall have registered said trailer in the Province; said trailer shall be registered with the Commission by Jean-Pierre Monette, so that the latter may haul said trailer with his tractor, duly registered in the Province ana with the Commission, in order to provide the aforesaid service on behalf of Roméo Monette Ltée.This service shall be sub-fed to the conditions which usually apply to this type of service, a copy of the text whereof is attached hereto.Roméo Monette Ltée.(requérante-conjointe) 158-rALr/,?,omi des caisses d'épargne et de crédit et de la Loi de la liquidation des compagnies.Québec, le 27 mars 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57075-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que « LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES » a été dissoute le vingt tt unième jour de mars 1974 et ce, en vertu de la Loi des caisses d'épargne et de crédit et de la Loi de la liquidation des compagnies.Québec, le 27 mars 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57076-o Albert Jessop.CAISSE POPULAIRE DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EST DU QUEBEC (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on November 20, 1973, by the \"CAISSE POPULAIRE DES ENSEIGNANTS DE LEST DU QUEBEC\", changing its name to that of \"CAISSE POPULAIRE DES TRAVAILLEURS DE LEST DU QUEBEC\".Québec, April 1, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57081 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DE T.S.ENFANT-JESUS D'ELY (Savings and Credit Unions Ad) Notice is given that \"LA CAISSE POPULAIRE DE T.S.ENFANT-JESUS D'ELY\" was dissolved on the twenty-first day of March, 1974, the foregoing pursuant to the Savings and Credit Unions Act and to the Winding-Up Act.Québec, March 27, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57075 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that \"LA CAISSE POPULAIRE CHUTE DES PASSES\" was dissolved on the twenty-first day of March, 1974, the foregoing pursuant to the Savings and Credit Unions Act and to the Winding-Up Act.Québec, March 27, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57076 Companies and Cooperatives. 3240 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES GARNIER (Loi des caisses d'épargne el de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 11 décembre 1973, par \" LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES GARNIER » modifiant son territoire qui était « la paroisse de Saint-Charles Gamier » en celui de « Cité de Shawinigan, Ville de Shawinigan-Sud, Ville de Grand'Mère, Paroisse Saint-Gérard-des-Laurentides, Village de Baie-de-Shawinigan, VillageSaint-Boniface-de-Shawinigan ».Québec, le 27 mars 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57074-o Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE BEDFORD (Loi des caisses d'épargne et de crédit) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règlement adopté le 20 novembre 1973, par « LA CAISSE POPULAIRE DE BEDFORD » modifiant son territoire qui était « La paroisse Saint-Damien-de-Bedford » en celui de « Ville de Bedford, Saint-Pierre-de-Vèronne, à Pike River, Canton Stanbridge, Village Philipsburg, Village et Paroisse de Frelighs-burg *.Québec, le 2 avril 1974.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57082-O Albert Jessop.LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES GARNIER (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bylaw adopted on December 11, 1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES GARNIER\" changing its territory, which was the \"Parish of St.Charles Gamier\" to that of \"City of Shawinigan, Town of Shawinigan-South, City of Grand'Mère, Parish of St.Gérard-des-Laurentides, Village of Baie-de-Shawinigan, Village of St.Boniface-de-Shawinigan\".Québec, March 27, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57074 Companies and Cooperatives.LA CAISSE POPULAIRE DE BEDFORD (Savings and Credit Unions Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the bvlaw adopted on November 20, 1973, by \"LA CAISSE POPULAIRE DE BEDFORD\" changing its territory, which consisted of \"The Parish of St.Damien-de-Bedford\", to that of \"Town of Bedford, St.Piene-de-Véronne, in Pike River, Stanbridge Township, Village of Philipsburg, Village and Parish of Frelighs-burg\".Québec, April 2, 1974.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57082 Companies and Cooperatives.Divers Compagnies GASTINON LTEE Les biens de la compagnie seront distribués entre ses actionnaires proportionnellement au montant d'actions qu'ils détiennent dans la compagnie, quinze jours après la publication de ce règlement dans la Gazette officielle du Québec.Jonquière, ce dixième jour d'avril mil neuf cent soixante-quatorze.Le procureur, 57061-o Jean-Pierre Durociier, notaire.LES PLACEMENTS H.G.DUCHESNE LTEE Les biens de la compagnie seront distribués entre ses actionnaires proportionnellement au montant d'actions qu'ils détiennent dans la compagnie, quinze jours après la publication de ce règlement dans la Gazette officielle du Québec.Jonquière, ce dixième jour d'avril mil neuf cent soixante-quatorze.Le procureur, 57062-o Jean-Pierre Durocher, notaire.Miscellaneous Companies GASTINON LTEE Notice is given that the assets of the Company will be distributed among its shareholders proportionately according to the number of shares they hold in the company, fifteen days following the date of publication of this bylaw in the Quebec Official Gazette.Jonquière, this tenth day of April, one thousand nine hundred seventy-four.Jean-Pierre Durocher, notary, 57061 Attorney for the Company.LES PLACEMENTS H.G.DUCHESNE LTEE Notice is given that the assets of the company will be distributed among its shareholders, proportionately according to the number of shares they hold in the company, fifteen days after the publication of this bylaw in the Quebec Official Gazette.Jonquière, this tenth day of April, one thousand nine hundred seventy-four.Jean-Pierre Durocher, notary, 57062 Attorney for the Company, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 37 avril 1974, 106' année, n° 17 3241 CRAWLEY & McCRACKEN COMPANY LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a plu au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de corriger l'avis de changement de directeurs de la compagnie * CRAWLEY & McCRAKEN COMPANY LIMITED », paru dans la Gazelle officielle du 9 mars 1974, numéro 10, à la page 1945, en y remplaçant partout où apparaissait ledit nom, le mot « McCRAKEN » par le mot « McCRACKEN », de manière que le nom se lise ainsi: « CRAWLEY & McCRACKEN COMPANY LIMITED ».Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57056-o 1545-18 CRAWLEY & McCRACKEN COMPANY LIMITED Notice is given that, under Part I of the Companies Act, it has pleased the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to correct the notice regarding the change in the number of administrators of \"CRAWLEY & McCRAKEN COMPANY LIMITED\", published in the Québec Official Gazette dated March 9, 1974, Number 10, on page 1945, by replacing, wherever it appeared, the name of \"McCRAKEN\" by \"McCRACKEN\", in order that the name may read as follows: \"CRAWLEY & McCRACKEN COMPANY LIMITED\".Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.57056 1545-18 Charte \u2014 demandes d'abandon de Charter \u2014 Applications for Surrender of ALOUETTE MEAT INC.Avis est donné par les présentes que « ALOUETTE MEAT INC.», une corporation incorporée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, ayant son siège social à Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, ce 4 avril 1974.Les procureurs de la requérante, Robinson, Siieppard, Borenstein, 57060-o Shapiro & Flam.ALOUETTE MEAT INC.Notice is hereby given that \"ALOUETTE MEAT INC\", a corporation incorporated under Part I of the Companies Act, having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Montreal, April 4th, 1974.Robinson, Sheppard, Borenstein, Shapiro & Flam, 57060-o Attorneys for Petitioner.GASTINON LTEE Avis est donné que « GASTINON LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur, Jean-Pierre Durocher, notaire.Édifice Jules Gauthier, 303 St-Dominique, Jonquière, P.Q.57061-o GASTINON LTEE Notice is given that \"GASTINON LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Jean-Pierre Durocher, notary, Attorney for the Company.Jules Gauthier Building, 303 St.Dominique, Jonquière, P.Q.57061 LES PLACEMENTS H.G.DUCHESNE LTEE Avis est donné que « LES PLACEMENTS H.G.DUCHESNE LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur, Jean-Pierre Durocher, notaire.Edifice Jules Gauthier, 303 St-Dominique, Jonquière, P.Q.57062-o LES PLACEMENTS H.G.DUCHESNE LTEE Notice is given that \"LES PLACEMENTS H.G.DUCHESNE LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Jean-Pierre Durocher, notary.Attorney for the Company.Jules Gauthier Building, 303 St.Dominique, Jonquière, P.Q.57062 3242 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 IMMEUBLES MARQUETTE INC, Avis est par les présentes donné que « IMMEUBLES MARQUETTE INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 16 avril 1974.Les procureurs de la compagnie, Guy, Vaillancourt, Bertrand, 57084-o Bourgeois & Laurent.J.ALFRED LEMIEUX & FILS LTEE Prenez avis que la compagnie « J.ALFRED LEMIEUX & FILS LTEE » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Lévis, ce 19e jour d'avril 1974.Le procureur de la compagnie, Claire Auger, notaire.108, Côte du Passage, Lévis, Québec, G6V 5S9 57087-o IMMEUBLES MARQUETTE INC.Notice is hereby given that \"IMMEUBLES MARQUETTE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal, April 16 1974.Guy, Vaillancourt, Bertrand, Bourgeois & Laurent, 57084-o Attorneys for the Company.J.ALFRED LEMIEUX & FILS LTEE Notice is given that \"J.ALFRED LEMIEUX & FILS LTEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Levis, April 19 1974.Claire Auger, Notary, Attorney for the Company.108, Côte du Passage, Lévis, Québec, G6V 5S9 57087-o Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Change of name \u2014 Applications Act Joseph, Albert Marcel Berger Avis est par les présentes donné que Joseph, Albert, Marcel Berger, gentilhomme, domicilié et résidant_au 715 Rang Saint-Régis, dans la municipalité de L'Epiphanie, district de Joliette, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Marcel Lavoie, ledit nom devant servir à toutes fins légales.Joliette, ce 13 mars 1974.Vraie copie.Les procureurs du requérant, 56981-16-2-0 Landreville & Bourduas.Serge Vasilache-Beauchamp Prenez avis que M.Serge Vasilache-Beauchamp, professeur, demeurant au 776 Place Philippe, Québec 10, G1V 2P7, s'adressera au ministre de la justice afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Vasilach.Le requérant, 57029-16-2-o Serge Vasilache-Beauchamp.Joseph Léo Alfred Guillemette Joseph Léo Alfred Guillemette, concierge, du 648, de la rue Brochu, appartement 3, à Sept-îles, district de Mingan, présente devant le ministre de la justice une requête pour que son nom de Guillemette soit changé en celui de « Richard ».Sept-îles, ce 18 mars 1974.Les procureurs du requérant, 57046-16-2-o Pettigrew & Roy.Joseph, Albert, Marcel Berger Notice is hereby given that Joseph, Albert, Marcel Berger, domiciled and residing at 715 Rang Saint-Régis, L'Epiphanie, district of Joliette, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the change of his name to Marcel Lavoie.Joliette, this March 13, 1974.True copy.Landreville & Bourduas, 56981-16-2-0 Attorneys for the petitioner.Serge Vasilache-Beauchamp Notice is given that Mr.Serge Vasilache-Beauchamp, teacher, residing at 776 Place Philippe, Québec 10, G1V 2P7, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to that of Vasilach.Serge Vasilache-Beauchamp, 57029-16-2 Petitioner.Joseph Léo Alfred Guillemette Notice is given that Joseph Léo Alfred Guillemette, caretaker, domiciled at 648 Brochu Street, apartment 3, in Sept-îles, District of Mingan, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name of Guillemette to that of Richard.Sept-îles, March 18, 1974.Pettigrew & Roy, 57046-16-2 Attorneys for Applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n\" 17 3243 Joseph, Dollard, Iréné Jean Avis est donné que Joseph, Dollard, Iréné, Jean, administrateur, domicilié et résidant au 332 Seignory Crescent, St-Hilaire, district judiciaire de St-Hyacinthe, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec afin de changer son nom à celui de René Jean.Montréal, le 4 avril 1974.Les procureurs du requérant, Guy, Vaillancourt, Bertrand, 57063-17-2-o Bourgeois & Laurent.Courtney Fitzgerald Scantlebury Prenez avis que Courtney Fitzgerald Scantlebury, 5184 Mountain Sights, Montréal, Province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour le changement de son nom en celui de Courtney Fitzgerald Rollock; ledit changement sera applicable également à son épouse Cynthia Elmira Moe.Montréal, le 21 décembre 1973.Le procureur du requérant, 57064-17-2-o Eric S.Helfield.Elias Arditi Avis est par les présentes donne que monsieur Elias Arditi.résidant et domicilié au 5704, avenue Smart, Côte St-Luc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin do changer son nom de Elias Arditi en celui de Elliot Elias Arditi.Montréal, avril, 1974.Le procureur du requérant, 57083-17-2 Norman S.Kessner.Avis divers C.A.C.FUNDS \u2014 REALTY LIMITED Avis est donné que le 7e jour de mars 1974, le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives a accordé à « C.A.C.FUNDS \u2014 REALTY LIMITED » un permis l'autorisant à exercer son commerce dans la province conformément aux dispositions de la Loi des sociétés de prêts et de placements, chapitre 289 des Statuts refondus de 1964.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite corporation est monsieur Ivan E.Phillips, Esquire, suite 930, 1 Place Ville-Marie, Montréal.Le bureau principal de la corporation dans la province est établi au numéro 1, Place Ville-Marie, suite 930, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.56916-15-4-0 SPP: 2-74 Joseph, Dollard, Iréné Jean Notice is given that Joseph, Dollard, Iréné Jean, administrator, domiciled and residing at 332 Seignory Crescent, St.Hilaire, Judicial District of St.Hyacinthe, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of René Jean.Montreal, April 4, 1974.Guy, Vaillancourt, Bertrand, Bourgeois & Laurent, 57063-17-2 Attorneys for the Applicant.Courtney Fitzgerald Scantlebury Take notice that Courtney Fitzgerald Scantlebury, 5184 Mountain Sights, Montreal, Province of Quebec, will take application to the Lieutenant-Governor in Council, for change of his name to that of Courtney Fitzgerald Rollock, and this change will affect also his wife, Cynthia Elmira Moe.Montreal, December 21st, 1973.Eric S.Helfield, 57064-17-2-o Attorney for Applicant.Elias Arditi Notice is hereby given that Mr.Elias Arditi, residing and domiciled at 5704 Smart Avenue, Côte St.Luc in the district of Montreal will apply to the Lieutenant-Governor in Council to have his name changed from Mr.Elias Arditi to Mr.Elliot Elias Arditi.Montreal, April, 1974.Norman S.Kessner, 57083-17-2-o Attorney for Petitioner.Miscellaneous Notices C.A.C.FUNDS \u2014 REALTY LIMITED Notice is given that, on 7th day of March, 1974, a license was granted by the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, to \"C.A.C.FUNDS \u2014REALTY LIMITED\" authorizing it to carry on business in the Province pursuant to the provisions of the Loan and Investment Societies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 289.The chief agent for the purpose of receiving services in proceeding against the said corporation is Mr.Ivan E.Phillips, Esquire, Suite 930, 1 Place Ville-Marie, Montreal.The principal office of the corporation in the Province is at Suite 930, 1 Place Ville-Marie, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.56916-15-4-0 SPP: 2-74 3244 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.IOC, No.17 Succession Dame Andréa Assailly Paquin Avis est donné que Monsieur Henri Bouchard, gérant du personnel à la Celancse Canada Limitée, demeurant ù Drummondville, 330 rue Laurier, en sa qualité de tuteur à l'enfant mineur Robert Paquin, a accepté sous bénéfice d'inventaire, par acte signé devant André Jean, notaire à Drummondville, 215, rue Lindsay, le douze mars mil neuf cent soixante-quatorze, enregistré dans Drummond le quatorze mars mil neuf cent soixante-quatorze sous le numéro 206334, la succession de feue Dame Andréa Assailly Paquin, en son vivant ménagère, demeurant à Drummondville, Pavillon (ïeorges Frédéric.Drummondville, le 12 avril 1974.Le notaire, André Jean.215, rue Lindsay, Drummondville, P.Q.57065-o Estate of Mrs.Andréa Assailly Paquin Notice is given that Mr.Henri Bouchard, personnel manager at Celanese Canada Limited, residing in Drummondville, 330 Laurier Street, in his capacity as tutor to Robert Paquin, a minor chili, has accepted under benefit of inventory, under the terms of a deed executed before André Jean, notary in Drummondville, at 215 Lindsay Street, on the twelfth day of March, one thousand nine hundred seventy-four, registered in Drummond on the fourteenth day of March, one thousand nine hundred seventy-four under number 206334, the estate of the late Mrs.Andréa Assailly Paquin, during her lifetime housekeeper, residing at the Pavilion Georges Frédéric, in Drummondville.Drummondville, April 12, 1974.André Jean, Notary.215 Lindsay Street, Drummondville, P.Q.57065 Conseil No 6290 Portneuf des Chevaliers de Colomb de Portneuf Le « Conseil No 6290 Portneuf des chevaliers de colomb » de Portneuf 110, rue Notre-Dame, Ville Portneuf, Cté Portneuf P.Q.donne avis, par les présentes, qu'il possède son siège social à l'adresse susmentionnée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, Chap.134) à partir du 1er décembre 1973.Portneuf, le 11 décembre 1973.Le Grand Chevalier, Claude E.Marcotte.Le secrétaire archiviste, Julien Marcotte.57069-o CC-12-73 Portneuf Council No.6290 of the Knights of Columbus of Portneuf Notice is given that \"Portneuf Council no.6290 of the Knights of Columbus\", 110 Notre Dame Street in the Town of Portneuf, County of Portneuf, P.Q., has its head office at the aforesaid address and that it avails itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth II.Chapter 134) from December 1, 1973.Portneuf, December 11, 1973.Claude E.Marcotte, Grand Knight.Julien Marcotte, Registrar.57069 CC-12-73 EGLISE ST-JACQUES DES SYRIENS ORTHODOXES ST.JACQUES SYRIAN ORTHODOX CHURCH Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la ïxri des corporations religieuses, chapitre 75 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 9e jour d'avril 1974, constituant en corporation régie par la Loi des corporations religieuses, MM.Abdul Karim lssa, chef comptable, 4702, rue Aramis, Jean El Khal, professeur d'école secondaire, 4605, Place Neuilly, tous deux de Saint-Léonard-de-Port-Maurice et Anton Mardini, homme d'affaires, 1520, boulevard Décarie, app.48, Saint-Laurent.Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder, est de $40,000, Le siège social de la corporation est à Montréal, district judiciaire de Montréal.Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.57056-o 1355-7020 EGLISE ST-JACQUES DES SYRIENS ORTHODOXES ST.JACQUES SYRIAN ORTHODOX CHURCH The minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that, pursuant to the Religious ( 'orporal ions Act.Chapter 75 of the Statutes of 1971, he has granted letters patent dated April 9, 1974, incorporating Messrs.Abdul Karim Issa, chief accountant, 4702 Aramis Street, Jean El Khal, secondary school teacher, 4605 Place Neuilly, both of St.Léonard-de-Port-Maurice and Anton Mardini, businessman, 1520 Décarie Boulevard, Apartment 48, St.Laurent.The amount to which the value of the immoveable property which the corporation mav acquire and hold is to be limited, is $40,000.The head office of the corporation is located in Montreal, Judicial District of Montreal.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.57056-o 1355-7020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3245 LES MINES SELEINE INC.(Libre de responsabilité personnelle) SELEINE MINES INC.(No personal liability) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu des dispositions de la Loi des compagnies minières, il a accordé des lettres patentes en date du 23e jour de janvier 1974, constituant en corporation Gilles de Billy, avocat et conseil en loi de la reine, 1090, Moncton, Québec, Pierre Cantin, 1340, Teillet, Thomas Lavoie, 23368, Maricourt, tous deux de Sainte-Foy, Pierre Gagnon, 1121, Plcërmel, Sillery, Jean Brisset des Nos, 980, Raymond-Casgrain, Québec, tous quatre avocats, Suzanne Plamondon, secrétaire, fille majsure, 855, Moncton, Québec et Joselyne Pelletier, secrétaire, épouse de Denis Chalifour, 918, avenue Ottawa, Sainte-Foy, pour les objets suivants: Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais, sous le nom de « LES MINES SELEINE INC.(Libre de responsabilité personnelle) \u2014 SELEINE MINES INC.(No personal liability) », avec capital total de $5,000,000 divisé en 5,000.000 d'actions ordinaires d'une valeur au pair de $1 chacune.Le siège social de la compagnie est au numéro 2406, Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy, district judiciaire de Québec.Ise directeur du service des compagnies, Pierre Desiardins.57056-o 13553789 LES MINES SELEINE INC.(Libre de responsability personnelle) SELEINE MINES INC.(No personal Liability) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to the provisions of the Mining Companies Act, he has granted letters patent, dated January 23, 1974, incorporating Gilles de Billy, lawyer and Queen's counsel, 1090 Moncton, Québec, Pierre Cantin, 1340 Teillet, Thomas Lavoie, 23368 Maricourt, both of them of Ste.Foy, Pierre Gagnon, 1121 Ploërmcl, Sillery, Jean Brisset des Nos, 980 Raymond-Casgrain, Québec, all four lawyers, Suzanne Plamondon, secretary, spinster, 855 Moncton, Québec and Jocelyne Pelletier, secretary, wife of Denis Chalifour, 918 Ottawa Avenue, Ste.Foy, for the following purposes: To prospect and explore for mines and minerals, under the name of \"LES MINES SELEINE INC.(Libre de responsabilité personnelle) \u2014 SELEINE MINES INC.(No personal liability)\", with a total capital stock of $5,000.000 divided into 5,000,000 common shares of a par value of $1 each.The head office of the company is located at number 2406 Quatre-Bourgeois, Ste.Foy, Judicial District of Québec.Pierre Desjardins, Director for the Companies Service.57056 13553789 Ministère de l'Éducation Department of Education Municipalité scolaire de Rouyn-Noranda Avis est par la présente donné qu'un certain territoire comprenant les cantons de Hébécourt et Duparquet, a été détaché, pour catholiques seulement, de la municipalité scolaire de Rouyn-Noranda.Et ce, en vertu de l'arrêté en conseil numéro 1138-74 du 27 mars 1974, dont le texte suit: Concernant un changement aux limites de lu municipalité scolaire de Rouyn-Noranda.Que les limites de la municipalité scolaire de Rouyn-Noranda soient changées pour catholiques au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique en en détachant le territoire suivant: Les cantons Hébécourt et Duparquet, et ce, conformément aux articles 46 et 49 de la Loi de l'instruction publique, Statuts refondus, 1964, chapitre 235.Ce changement prendra effet le premier juin 1974 pour les fins d'élection, et le premier juillet pour toutes autres fins.Le ministre de l'éducation, François Cix>utiëh.Le 22 avril 1971.57094-o Rouyn-Noranda School Municipality Notice is hereby given that a certain territory comprising the Townships of Hébécourt and Duparquet has been detached, for Roman Catholics only, from the Rouyn-Noranda School Municipality.The foregoing, according to Order in Council number 1138-74, dated March 27, 1974, which reads as follows: Concerning an alteration of the boundaries of the Rouyn-Noranda School Municipality.That the boundaries of the Rouyn-Noranda School Municipality be altered for Roman Catholics within the meaning of section 49 of the Education Act, by detaching therefrom the following territory: The townships of Hébécourt and Duparquet, in accordance with sections 46 and 49 of the Education Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 235.This alteration shall take effect on the first of June, 1974 for election purposes, and on the first of July for all other purposes.François Cloutier, Minister of Education.April 22, 1974 .57094 3246 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Arrêté en conseil Arrêté en conseil Chambre du Conseil Exécutif Numéro 1138-74 Québec, le 27 mars 1974.Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un changement aux limites de la municipalité scolaire de Rouyn-Noranda.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'éducation: Que les limites de la municipalité scolaire de Rouyn-Noranda soient changées pour catholiques au sens de l'article 49 de la Loi de l'instruction publique en en détachant le territoire suivant: Les cantons Hébécourt et Duparquet, et ce, conformément aux articles 46 et 49 de la Loi de l'instruction publique, (Statuts refondus, 1964, chapitre 235.) Le greffier du conseil exécutif, 57094-o Julien Chouinard.Associations coopératives COOPERATIVE D'ARTISANAT L'EMPREINTE DE MONTREAL (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « COOPERATIVE D'ARTISANAT L'EMPREINTE DE MONTREAL».Le siège social de cette association coopérative est situé à Montréal, Québec, dans le district électoral de Saint-Louis.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57068-o Albert Jessop.COOPERATIVE AGRICOLE D'AMOS (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « COOPERATIVE AGRICOLE D'AMOS ».Le siège social de cette association coopérative est situé à Amos, Québec, dans le district électoral d'Abi-tibi-est.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57079-o Albert Jessop Order in Council Order in Council Executive Council Chamber Number 1138-74 Québec, March 27, 1974.Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning an alteration of the boundaries of the Rouyn-Noranda school municipality.It is ordered upon the recommendation of the Minister of Education: That the boundaries of the Rouyn-Noranda school municipality be altered for Roman Catholics within the meaning of section 49 of the Education Act by detaching the following territory therefrom: The townships of Hébécourt and Duparquet, in accordance with sections 46 and 49 of the Education Act, (Revised Statutes, 1964, Chapter 235.) Julien Chouinard, 57094 Clerk of the Executive Council.Cooperative Associations COOPERATIVE D'ARTISANAT L'EMPREINTE DE MONTREAL (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of \"COOPERATIVE D'ARTISANAT L'EMPREINTE DE MONTREAL\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Montreal, Québec, in the Electoral District of St.Louis.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57068 Companies and Cooperatives.COOPERATIVE AGRICOLE D'AMOS (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of \"COOPERATIVE AGRICOLE D'AMOS\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Amos, Québec, in the Electoral District of Abitibi-East.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57079 Companies and Cooperatives. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3247 LA COOPERATIVE DE CRIBLAGE DE HONFLEUR (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé la formation de l'association coopérative « LA COOPERATIVE DE CRIBLAGE DE HONFLEUR.» Le siège social de cette association coopérative est situé à Honfleur, Québec, dans le district électoral de Bellechasse.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57080-o Albert Jessop.LA COOPERATIVE DE CRIBLAGE DE HONFLEUR (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the formation of \"LA COOPERATIVE DE CRIBLAGE DE HONFLEUR\", a cooperative association.The head office of this cooperative association is located in Honfleur, Québec, in the Electoral District of Bellechasse.57080 Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.Liquidation \u2014 Loi de la Winding-Up Act LA CAISSE MUTUELLE DES EMPLOYÉS DU BUREAU DE L'AUDITEUR DE LA PROVINCE (Loi des syndicats coopératifs) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres du syndicat coopératif « LA CAISSE MUTUELLE DES EMPLOYÉS DU BUREAU DE L'AUDITEUR DE LA PROVINCE », tenue à Québec, le 2 février 1972, il a été résolu de liquider la coopérative et de la dissoudre, ce conformément aux dispositions de la Loi des syndicats coopératifs et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Yvan Mathieu soit nommé liquidateur.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 57093-o Albert Jessop.LA CAISSE MUTUELLE DES EMPLOYES DU BUREAU DE L'AUDITEUR DE LA PROVINCE (Cooperative Syndicates Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"LA CAISSE MUTUELLE DES EMPLOYÉS DU BUREAU DE L'AUDITEUR DE LA PROVINCE\" (a cooperative syndicate), held in Québec, on February 2, 1972, it was resolved that the Cooperative be wound up and dissolved, in conformity with the provisions of the Cooperative Syndicates Act and of the Winding-Up Act, and that Mr.Yvan Mathieu be appointed liquidator.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 57093 Companies and Cooperatives.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies Licenses CENTURY PLAZA LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « CENTURY PLAZA LIMITED » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.William Desmond Thomas, avocat et conseil de la Reine, 505 ouest, boulevard Dorchester, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au 505 ouest, boulevard Dorchester, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056-o PA: 20-74 CENTURY PLAZA LIMITED Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"CENTURY PLAZA LIMITED\" has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.William Desmond Thomas, advocate and Queen Counsel, 505 Dorchester Boulevard West, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 505 Dorchester Boulevard West, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056 PA: 20-74 3248 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 ADVANCE PROCESS SUPPLY COMPANY Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères la compagnie « ADVANCE PROCESS SUPPLY COMPANY » a été autorisé à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur Bernecbe, 3069.rue Masson, Longueuil.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au numéro 445, boulevard Guimond, Longueuil, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 62-73 ADVANCE PROCESS SUPPLY COMPANY Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"ADVANCE PROCESS SUPPLY COMPANY\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Gabnel Beraeche, 3069 Masson Street, Longueuil.The principal office of the company in the Province is at 445 Guimond Boulevard, Longueuil, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 62-73 HILL & HILL TRUCK LINE, INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères la compagnie « HILL & HILL TRUCK LINE, INC.¦> a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur F.A.Cheftechi, 700, édifice de la Banque Royale, Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au numéro 700, édifice de la Banque Royale, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 17-74 HILL & HILL TRUCK LINE, INC.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"HILL & HILL TRUCK LINE, INC.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.F.A.Cheftechi, 700 Royal Bank Building, Montreal.The principal office of the company in the Province is at 700 Royal Bank Building, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 17-74 NAARDEN INTERNATIONAL HOLLAND B.V.Avis est donne qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères la compagnie « NAARDEN INTERNATIONAL HOLLAND B.V.» a été autorisé à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur Herman A.Van Rootselaar, 11, Laurier Court, Bea-consfield.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au numéro 717, avenue Halpern, Dorval, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies ct coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 12-74 NAARDEN INTERNATIONAL HOLLAND B.V.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"NAARDEN INTERNATIONAL HOLLAND B.Y.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Herman A.Van Rootselaar, 11 Laurier Court, Beaconsfield.The principal office of the company in the Province is at 717 Halpern Avenue, Dorval, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 12-74 STEWART EQUIPMENT AUCTIONEERS (INTERNATIONAL), INC.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères la compagnie « STEWART EQUIPMENT AUCTIONEERS (INTERNATIONAL), INC.» a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur STEWART EQUIPMENT AUCTIONEERS (INTERNATIONAL), INC.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"STEWART EQUIPMENT AUCTIONEERS (INTERNATIONAL), INC.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Thomas GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3249 Thomas Justin McKenna, c.r., suite 1010, 606 rue Cathcart, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au 606, rue Cathcart, suite 1010, Montreal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 10-74 Justin McKenna, Q.C.Suite 1010, 606 Cathcart Street, Montreal.The principal office of the company in the Province is at Suite 1010, 606 Cathcart Street, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 10-74 COMCHEQ SERVICES LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères la compagnie « COMCHEQ SERVICES LIMITED » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est mademoiselle Patricia Bordignon, de Montréal.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au numéro 40, Brome, Place Bonaventure, Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 8-74 COMCHEQ SERVICES LIMITED Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"COMCHEQ SERVICES LIMITED\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Miss Patricia Bordignon, of Montreal.The principal office of the company in the Province is at 40 Brome, Place Bonaventure, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 8-74 CHERRY HILL PHOTO ENTERPRISES CHERRY HILL PHOTO ENTERPRISES Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères la compagnie « CHERRY HILL PHOTO ENTERPRISES » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est CT.Corporation System (Canada), Ltd., 220, Grande-Allée est, Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au numéro 220, Grande-Allée est, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 4-74 Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"CHERRY HILL PHOTO ENTERPRISES\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is CT.Corporation System (Canada), Ltd., 220 Grande-Allée East, Québec.The principal office of the company in the Province is at 220 Grande-Allée East, Québec, judicial District of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 4-74 CANADIAN NURS-ETTE DISTRIBUTORS LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères la compagnie « CANADIAN NURS-ETTE DISTRIBUTORS LTD.» a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est M.Hubert Walters, de Québec.Le bureau principal de la compagnie dans la province est situé au 500, Grande-Allée est.Suite 609, édifice La Laurentienne, Québec, district judiciaire de Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 2-74 CANADIAN NURS-ETTE DISTRIBUTORS LTD.Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act, \"CANADIAN NURS-ETTE DISTRIBUTORS LTD.\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Hubert Walters, of Québec.The principal office of the company in the Province is at Suite 609, La Laurentienne Building, 500 Grande-Allée East, Québec, judicial District of Québec.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 2-74 3250 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 37, 1974, Vol.106, No.17 PROTO EXPLORATIONS & HOLDINGS INC.PROTO EXPLORATIONS & HOLDINGS INC.Notice is given that \"PHOTO EXPLORATIONS & HOLDINGS INC.\" has been authorized to sell, or otherwise alienate in the Province of Québec, its shares, stocks, stock-certificates, debentures and other securities.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the said company, is Mr.Fhilip f.Vineberg q.c, 930, 1 Place Ville Mane, Montreal.The principal office of the said company in the Province is at 930.1 Place Ville Marie, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PVA: 9-72 Avis est donné que la compagnie « PHOTO EXPLORATIONS & HOLDINGS INC.» a été autorisée à vendre, ou autrement aliéner dans la province de Québec, ses actions, stocks, certificats d'actions, obligations et autres valeurs.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie est M.Philip f.Vineberg, ch., 930, 1, Place Ville Marie, Montréal.Le bureau principal de ladite compagnie dans la province est situé au numéro 930, 1, Place Ville Marie, Montréal, district j'udiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PVA: 9-72 ATLANTIC SALVAGE & DREDGING LIMITED ATLANTIC SALVAGE & DREDGING LIMITED Avis est donné qu'en vertu de la Loi des compagnies étrangères, la compagnie « ATLANTIC SALVAGE & DREDGING LIMITED » a été autorisée à exercer son commerce dans la province.L'agent principal aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre la compagnie est monsieur Timothy Ross Carsley, 454 Elm, Westmount.Le bureau principal de la compagnie dans la province de Québec est établi au numéro 129, rue St-Jacques, Montréal, district j'udiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57056 PA: 22-74 Notice is given that, under the Extra-Provincial Companies Act.\"ATLANTIC SALVAGE & DREDGING LIMITED\", has been authorized to carry on business in the Province.The chief agent for the purpose of receiving services in proceedings against the company is Mr.Timothy Ross Carsley, 454 Elm, Westmount.The principal office of the company in the Province is at 129 St.James Street, Montreal, judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.57056-o PA: 22-74 Syndicats professionnels Professional Syndicates SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DES LAURENTIDES (Loi des syndicats professionnels) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 22 février 1974, il a autorisé le changement de nom de « SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA REGION DES LAURENTIDES », dont la constitution, sous le nom originaire de l'« ASSOCIATION CATHOLIQUE DES INSTITUTRICES RURALES DU DISTRICT No 11 », a été autorisée le 26 mai 1944, et dont le siège social est situé à St-Jérôme, en celui de < SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DES LAURENTIDES », et ce, en vertu de la Loi des syndicats professionnels.Statuts refondus, 1964, chapitre 146.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.57066-o SP: 1127-44 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DES LAURENTIDES (Professional Syndicates Act) The Minister of Financial Institutions Companies and Cooperatives gives notice that, on February 22, 1974, the \"SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA REGION DES LAURENTIDES\", incorporated on May 26, 1944, under the original name of \"L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES INSTITUTRICES RURALES DU DISTRICT No.11\", and having its head office located in St.Jérôme, has been authorized to change its name to that of \"SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT DES LAURENTIDES\", the foregoing in conformity with the Professional Syndicates Act, Revised Statutes 1964 Chapter 146.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.°'066 SP: 1127-44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n\" 17 3251 Proclamations Canada, Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut: Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Saguenay, comprenant l'ajouté de l'île 67, située dans la division d'enregistrement de Charlevoix No 1, avec un livre de renvoi relatif à ce plan ; Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagnée d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Charlevoix No 1, à La Malbaie; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Charlevoix No 1, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Saguenay; À ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 1031-74, du 20 mars 1974, Nous avons décrété ct ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent», qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Charlevoix No 1, à La Malbaie, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Saguenay, comprenant l'ajouté de l'Ile 67, située dans la division d'enregistrement de Charlevoix No 1 ; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article Proclamations Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern, Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Saguenay, comprising the addition of island 67, located in the Charlevoix No.1 Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan ; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Charlevoix No.1 Registration Division Office, in La Malbaie by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Charlevoix No.1 Registration Division, and, at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Township of Saguenay; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 1031-74, dated March 20, 1974, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister c f Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Charlevoix No.1 Registration Division Office, in La Malbaie, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Saguenay, comprising the addition of island 67, located in the Charlevoix No.1 Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 3252 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement, relativement à ladite partie du canton de Saguenay; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi.Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingtième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-quatorze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-troisième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 René I.angevin.Folio: 212 57067-o Canada.Province de HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.) ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que, conformément à l'article 1 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), il a été préparé, sous la direction du ministre des terres et forêts, un plan d'une partie du canton de Bousquet, comprenant l'ajouté du bloc 19, située dans la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda, avec un livre de renvoi relatif à ce plan; 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Saguenay; (c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof, We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twentieth day of March in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-third year of Our Reign.By command, René Langevin, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 212 57067 Canada, Province of HUGUES LAPOINTE Québec.[L.S.] ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God, of the United Kingdom, Canada and Her Other Realms and Territories, Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all those to whom these present letters shall come, or whom the same may concern.Greeting.Proclamation Whereas, pursuant to section 1 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), the Minister of Lands and Forests has caused to be prepared, under his superintendence, a correct plan of a part of the Township of Bousquet, comprising the addition of block 19 located in the Rouyn-Noranda Registration Division, with a book of reference relating to this correct plan ; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3253 Attendu que le plan de cette partie dudit canton qui est signé par le ministre des terres et forêts est dans les archives de son bureau; Attendu Qu'une copie de ce plan correct, accompagnée d'une copie de ce livre de renvoi, a été déposée par le ministre des terres et forêts au bureau de la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda, à Rouyn; Attendu que, maintenant, il y a lieu d'annoncer, selon les prescriptions de l'article 2169 du Code civil, par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, le dépôt des plan et livre de renvoi originaires dans la division d'enregistrement de Rouyn-Xoranda, et, en même temps, le jour auquel les dispositions de l'article 2168 y deviendront en vigueur, le tout relativement à ladite partie du canton de Bousquet;  ces causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 1032-74, du 20 mars 1974, Nous avons décrété et ordonné et, par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre des terres et forêts et conformément aux articles 1 et 2 de la Loi du cadastre (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 320), ainsi qu'aux articles 2166 à 2176c inclusivement du Code civil, c'est-à-dire ceux constituant la section II de ce Code dont le titre est « Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s'y rattachent», qu'il y a lieu: a) d'annoncer le dépôt, par le ministre des terres et forêts, au bureau de la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda, à Rouyn, des plan et livre de renvoi originaires d'une partie du canton de Bousquet, comprenant l'ajouté du bloc 19, située dans la division d'enregistrement de Rouyn-Noranda; 6) de fixer à la date de la publication de la présente proclamation le jour auquel les dispositions de l'article 2168 deviendront en vigueur, dans cette division d'enregistrement; relativement à ladite partie du canton de Bousquet; c) de rappeler que, dans les deux ans qui suivent cette date, l'enregistrement de tout droit réel, sur un lot de terre désigné sur ces plan et livre de renvoi, doit être renouvelé par l'enregistrement par dépôt, d'un avis désignant l'immeuble affecté, en la manière prescrite dans l'article 2168 et en observant les autres formalités prescrites dans l'article 2131 pour le renouvellement ordinaire de l'enregistrement des hypothèques; d) d'informer qui de droit que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.En foi de quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Whereas the correct plan of this part of the said Township signed by the Minister of Lands and Forests, is in the Archives of his office; Whereas a copy of this correct plan, together with a copy of this book of reference has been deposited in the Rouyn-Noranda Registration Division Office, in Rouyn by the Minister of Lands and Forests; Whereas it is now expedient, pursuant, to the provisions of article 2169 of the Civil Code, to announce, by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, the deposit of the original plan and book of reference in the Rouyn-Noranda Registration Division, and, at the same time, the day on which the provisions of article 2168 will become effective, the whole in relation to the said part of the Township of Bousquet; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in a decree numbered 1032-74, dated March 20.1974, We have decreed and ordered, and do hereby decree and order, upon the recommendation of the Minister of Lands and Forests and pursuant to sections 1 and 2 of the Cadastre Act (Revised Statutes of Québec, 1964, Chapter 320), and articles 2166 to 2176c inclusive of the Civil Code, that is to say, those constituting Section II of this Code, the title of which is \"of the Official Plans and Books of Reference and of Matters Connected Therewith\", that it is expedient: (a) to announce the deposit in the Rouyn-Noranda Registration Division Office, in Rouyn, of the original plan and book of reference of a part of the Township of Bousquet located in the Rouyn-Noranda Registration Division, by the Minister of Lands and Forests; (6) to fix the date of the publication of this proclamation as the day on which the provisions of article 2168 will become effective in this Registration Division, in relation to the said part of the Township of Bousquet.(c) to direct attention to the fact that, within two years from this date, the registration of any real right upon a lot of land described in this plan and book of reference must be renewed by means of the registration, by deposit, of a notice describing the immoveable affected, in the manner prescribed in article 2168 and in conformity with the other formalities prescribed in article 2131 for the ordinary renewal of the registration of hypothecs; (d) to notify whom it may concern that if such renewal be not effected, the real rights preserved by the first registration will have no effect against other creditors or subsequent purchasers whose claims have been registered in due form.Of all of which all Our loving subjects and all others whom these presents may concern are hereby required to take notice and to govern themselves accordingly; In testimony whereof.We have caused these Our present letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; 3254 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r., lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingtième jour de mars en l'année mil neuf cent soixante-quatorze de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-troisième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint, Libro: 501 René L angevin.Folio: 213 57067-o Witness: Our Right-Trusty and Well-Beloved the Honourable Hugues Lapointe, p.c, q.c, Lieutenant-Governor if Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twentieth day of March in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-four and in the twenty-third year of Our Reign.By command, René Langevin, Libro: 501 Assistant Deputy Attorney General.Folio: 213 57067 Ministère des institutions financières, compagnies et coopératives Department of Financial Institutions, Companies and Cooperatives Lettres patentes supplémentaires\tSupplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes supplémentaires à:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Incorporation L.P.S./ S.L.P.Modifications Nom / Name Date Date Changes\t ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SEPTIEME LAC INC.12522-62 CANADIAN MERRILL LTD.5178-50 LES CEDRES DE RIVIERE-BLEUE LIMITEE BLUE RIVER CEDAR LIMITED 14174-60 CELLIER ST-BERNARD INC.714603 CENTRE HOSPITALIER GEORGE6 FREDERIC 1231-65 CHI BEX LIMITED.CHIBEX LIMITEE 796-70 CONTINENTAL RESORT CO.LTD.13164-58 DELTA COMPAGNIE D'IMMEUBLES LIMITEE 12624-59 19 07 62 25 01 74 Ancien nom / Former name: CLUB DE PECHE ET DE CHASSE DE JOLIETTE 04 07 50 05 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital 07 11 60 18 01 74 Modifiant le capital / Altering the capital 01 09 71 22 01 74 Modifiant le capital / Altering the capital 23 03 65 16 01 74 1) Ancien nom / Former name PAVILLON GEORGES-FREDERIC 2) étendant les pouvoirs / Extending the powers 06 03 70 12 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital 02 10 68 14 02 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Changeant le siège social / Changing the head office 3) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.Il 05 59 30 01 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2) Modifiant certaines dispositions des lettres patentes / Amending certain provisions of the letters patent GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3255 Nom / iVame Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changée LEOPOLD DESMARAIS & FILS INC.29 07 68 17 12 73 Ancien nom / Former name: 3221-68 LEOPOLD DESMARAIS INC.LES ENTREPRISES CAR-MAT LTEE.07 02 66 20 09 73 Modifiant le capital / Altering the capital 506-66 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES GUAY 09 04 69 05 03 74 Ancien nom / Former name: INC.BENOIT POULIN ELECTRIQUE 1564-69 INC.LES FERMES LOUISBOURG INC.22 07 66 21 03 74 1) Ancien nom / Former name: LOUISBOURG FARMS INC.MARIO TADREO INC.3026-66 2) Modifiant le3 pouvoirs / Modifying the powers FOOD SERVICES LIMITED.01 03 63 12 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 898-63 2) Modifiant certaines dispositions des let- tres patentes / Amending certain provisions of the letters patent 3) Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions FORMO INC.13 04 53 01 02 74 Modifiant le capital / Altering the capital 6891-53 HAMPSTEAD GARDENS INC.06 II 68 11 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 5211-68 2) Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions LAMOTHE TRANSPORT INC.11 05 54 18 02 74 Ancien nom / Former name: TRANSPORT LAMOTHE INC.COUTU TRANSPORT EXPRESS 11143-54 LIMITEE THE LIVE STOCK BREEDERS 19 10 10 10 01 74 Modifiant le capital / Altering the capital ASSOCIATION OF THE DISTRICT OF BEAUHARNOISINCORPORATED 3207-10 MONTREAL BY-PRODUCTS LTD.07 05 71 08 03 74 Ancien nom / Former name: LES SOUS-PRODUITS DE MONTREAL WELLS BY-PRODUCTS INC.LTEE 2399-71 W.H PERRON & CO.LIMITED.05 11 28 08 01 74 Modifiant le capital / Altering the capital 2157-28 P.E.POIRIER ET FILS INC.04 10 73 31 01 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital P.E.POIRIER AND SON INC.2) Modifiant certaines dispositions des let- 734380 tres patentes / Amending certain provi- sions of the letters patent QUEFROST INC.05 06 69 12 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 2525-69 2) Modifiant certaines dispositions des let- tres patentes / Amending certain provisions of the letters patent.REDISTOMATIQUES INC.27 08 63 14 01 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital ifiK4_6X 2) Anoien nom / Former name: SEVEN-UP TROIS-RIVIERES (1963) INC.ROTOTECH-SMITH INC.24 09 62 14 03 74 1) Modifiant le capital / Altering the capital 13790-62 2) Modifiant certaines dispositions des let- tres patentes /Amending certain provisions of the letters patent SAFARI PAVING LTD.06 11 73 12 02 74 Modifiant les dispositions des lettres paten- PAVAGE SAFARI LTEE.tes I Amending the provisions of the letters 734876 patent SA VA INC.01 03 71 08 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital 764-71 3256 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, Avril 27, 1974, Vol.106, No.17 Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes SERACO INC.02 08 73 22 03 74 Modifiant le capital / Altering the capital 733470 SERVICES NOVA INC.16 02 72 15 03 74 Anoien nom / Former name: NOVA SERVICES INC.LES BARDEAUX DE CEDRES 720916 DU QUEBEC INC.\u201e,\u201e QUEBEC CEDAR SHINGLES INC.SIMON, VOYER & CASTELLI INC.02 02 66 21 03 74 Ancien nom / former name: 132-66 SIMON LEBLOND & CASTELLI INC.TREMUR & CO.INC.09 03 72 03 01 74 Modifiant le capital / Altering the capital 721384 LES VINS ANDRES DU QUEBEC LTEE____ 15 09 71 19 03 74 Ancien nom / Former name: ANDRES WINES OF QUEBEC LTD.VINS CALONA INC.714845 67056-o\tLe directeur du service dee compagnies, Pierre Desjarlins.\t57056-o\tPierre Desjardins.Director of the Companies Service.\tSociété d'habitation du Québec\t\tQuébec Housing Corporation \tCite de Jonquière\t\tCity of Jonquière \tProgramme de rénovation\t\tRenewal program \tzone « Centre-Ville »\t\tzone \"Centre-Ville\" \t(Modifications)\t\t(Modifications) Avis est donné qu'en vertu de l'article 40 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (\"1966-67, chapitre 55), le lieutenant-gouverneur en conseil a, par l'arrêté en conseil numéro 1282-74 en date du 3 avril 1974, ratifié les modifications adoptées par le règlement numéro 849 en date du 14 janvier 1974 de la cité de Jonquière à son programme de rénovation pour la partie de son territoire appelée « Centre-Ville », décrétée « zone de rénovation » par l'arrêté en conseil numéro 4298 en date du 18 novembre 1970, modifié par l'arrêté en conseil numéro 1585-72 en date du 6 juin 1972 et décrété « zone de rénovation » le territoire additionnel qui fait l'objet de ce programme.La Société d'habitation du Québec a, par sa résolution numéro 7435 en date du 25 mars 1974, approuvé ces modifications.Le secrétaire, 57071-o Me Jean-Luc Lesage, notaire.OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GREENFIELD PARK MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF GREENFIELD PARK Avis est donné qu'en vertu de l'article 55 de la Loi de la Société d'habitation du Québec (chapitre 55 des lois 1966-1967, le lieutenant-gouverneur a délivré, sous le grand sceau de la province, des lettres patentes, en Notice is given that pursuant to section 40 of the Québec Housing Corporation Act (1966-67, Chapter 55).the Lieutenant-Governor in Council has, by Order number 1282-74 dated April 3, 1974, ratified the modifications adopted by by-law number 849 dated January 14, 1974, of the City of Jonquière in its renewal program for the part of its territory known as \"Centre-Ville\", declared a \"renewal zone\" by Order number 4298 dated November 18, 1970, amended by Order number 1585-72 dated June 6, 1972 and declared a \"renewal zone\" the additional territory covered by the said program.The Québec Housing Corporation has, by its resolution number 7435 dated March 25, 1974, approved these modifications.Me Jean-Luc Lesage, Notary, 5707 l-o Secretary.OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GREENFIF.LD PARK MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF GREENFIELD PARK Notice is given that under Article 55 of the Québec Housing Corporation Act (1966-1967, Chapter 55), the Lieutenant-Governor has issued letters patent under the Great Seal of the Province, bearing date of the GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3257 date du quatrième jour de mars 1974, constituant en corporation sans but lucratif: Maurice King, maire, 155, rue Section; T.J.Stoker, échevin, 375, avenue Fairfield, R.V.Barber, échevin, 789, rue Devty; S.R.Adey, surintendant, 690, avenue Miller et VV.E.Board, retraite, 168, Third Street, tous domiciliés à Greenfield Park; pour les fins suivantes: acquérir, construire et administrer des immeubles d'habitation à loyer modique pour personnes à faible revenu.Le siège social de la corporation est situé dans les limites du territoire de la ville de Greenfield Park, district judiciaire de Montréal.Société d'habitation du Québec.Le secrétaire, 57070-o Me Jean-Luc Lesage, notaire.Soumissions \u2014 Demandes de Cité de Rimouski Comté de Rimouski Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Hubert Dubé, greffier.Hôtel de ville, 205, rue de la Cathédrale, Rimouski, comté de Rimouski, P.Q., jusqu'à 8.30 heures du soir, lundi, le 13 mai 1974, pour l'achat de $736,000 d'obligations de la cité de Rimouski, comté de Rimouski, datées du 1er juin 1974 et remboursables en série du 1er juin 1975 au 1er juin 1994 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8J%.nor more than 9%, payable semiannually on June 1st and December 1st of each year, except for bonds maturing from June 1, 1984, on which the maximum rate of interest allowed in fixed at 9' 2%- The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.Kor adjudication purposes only, interest will be calculated as from June 1, 1974.Redemption table \u2014 $594,000 \u2014 20 years Date Capital $ 9,000 11,000 11,000 13,000 13,(100 14,000 15,000 17,000 18,000 323,000 01 06 1975 .$24,000 01 06 1985 01 06 1976 .25,000 01 06 1986 01 06 1977 .26,000 01 06 1987 01 06 1978 .29,000 01 06 1988 01 06 1979 .6,000 01 06 1989 01 06 1980 .7,000 01 06 1990 01 06 1981 .7,000 01 06 1991 01 06 1982 .8,000 01 06 1992 01 06 1983 .9.000 01 06 1993 01 06 1984 .9.000 01 06 1994 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série avec le solde reporté à la cinquième année, à la dixième année ou à la quinzième année selon le cas.2° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la cinquième année.4° Obligations échéant en série 1 à 5 ans avec le solde reporté à ia cinquième année pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.5° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la cinquième année pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.6° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, dans le cas où des soumissions pourront être faites pour des obligations échéant à terme fixe 20 ans, le montant ainsi émis ne devra pas être inférieur à 829.000 ct si supérieur à ce dernier montant, l excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er juin 2014 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er juin 1994 au montant de 8323,000 comprend un solde de 8304,000 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans, et échéant comme suit: Date Capital 01 06 1995 .8 6,000 01 06 1996 .7.000 01 06 1997 .7,000 01 06 1998 .8,000 01 06 1999 .9,000 01 06 2000 .10,000 01 06 2001 .10,000 01 06 2002 .12,000 01 06 2003 .12,000 01 06 2004 .13,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital ct les intérêts sont payables à toutes les succursales dans la province de Québec de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.I.esdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.Bonds maturing serially with the balance carried forward to the fifth year, the tenth year or the fifteenth year; 2.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds; 3.1 to 10-year bonds with the balance carried forward to the fifth year; 4.1 to 5-year serial bonds with the balance carried forward to the fifth year for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds; 5.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the fifth year for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds; 6.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $29.000 and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of June 1, 2014 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of June 1, 1994 in the amount of $323,000 includes a balance of $304,000 renewable for an additional 20-ycar period, maturing as follows: Date Capital 01 06 2005 .$15,000 01 06 2006 .16,000 01 06 2007 .16,000 01 06 2008 .18,000 01 06 2009 .20,000 01 06 2010 .21,000 01 06 2011 .23,000 01 06 2012 .25,000 01 06 2013 .27,000 01 06 2014 .29,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in the Province of Québec of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-ycar fixed-terra GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 197i, 100' année, n° 17 3265 fixe 20 ans pour un montant supérieur à $323,000 et seul cet excédent sera raclietalile par anticipation au pair le 1er juin de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de St-Roch-de-l'Achigan s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er juin 1974 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Les obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 108 \u2014 $60.000 \u2014 aqueduc, égouts; 112-71 \u2014 $22,800 \u2014 aqueduc, égouts; 113-A-1972 \u2014 $60.010 \u2014 aqueduc, égouts; 115-1972 \u2014 $56,400 \u2014 aqueduc, égouts: 119-1972 \u2014 $106,000 \u2014 voirie; 120-1972 \u2014 $28,000 \u2014 aqueduc, égouts; 121-1972 \u2014 $124.000 \u2014 aqueduc, égouts; 123-1973 \u2014 $36.800 \u2014 voirie; 127-1974 \u2014 8100,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mardi, le 14 mai 1974, à 8 heures du soir, sous-sol de l'église, rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan, comté de L'Assomption, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Roch-de-l'Achigan, (Comté de L'Assomption), ce 19 avril 1974.Le secrétaire-trésorier, Luc Amirault.Bureau municipal, 457, rue Principale, Saint-Roch-de-l'Achigan, Comté de L'Assomption, Québec.Téléphone: 588-2326, code 514.57089-o bonds for an amount greater than $323.000 and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on June 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Parish of St.Roch-de-1'Achigan agrees not to bring out new bonds on the Canadian Market within the sixty days upon, from and after June 1, 1974.without written authorization from tlie successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 108 \u2014 $60,000 \u2014 waterworks, sewers; 112-71 \u2014 $22,800 \u2014 waterworks, sewers; 113-A-1972 \u2014 $60.000 \u2014 waterworks, sewers; 115-1972 \u2014 $56,400 \u2014 waterworks, sewers; 119-1972 \u2014 $106,000 \u2014 roads; 120-1972 \u2014 $28,000 \u2014 waterworks, sewers; 121-1972 \u2014 $124.000 \u2014 waterworks, sewers; 123-1973 \u2014 $36.800 \u2014 roads; 127-1974 \u2014 $100,000 \u2014 waterworks, sewers, roads.Tenders will be opened and considereil at a meeting of the Council to be held on Tuesday, May 14, 1974, at 8:00 o'clock p.m., in the basement of the Church, Principale Street.St.Roch-de-l'Achigan, County of L'Assomption, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.St.Roch-de-l'Achigan (County of L'Assomption), April 19, 1974.Luc Amirault, Secretary-Treasurer.Municipal Office, 457 Principale Street, S t-Roch -de-1' Ach igan, County of L'Assomption, P.Q.Telephone: 588-2326, code 514.57089 Vente d'effets non réclamés Sale of Unclaimed Baggage LA CIE DE MESSAGERIES CP LIMITEE Avis est par les présentes donné que tous les effets reçus avant le 1er jour de juin, 1973, et non réclamés aux bureaux des « CP EXPRESS LIMITEE » à divers endroits de la province de Québec, seront vendus aux enchères publiques au plus haut enchérisseur par Frank Waddington, encanteur, 189 est, rue Queen, Toronto, Ontario, à onze heures du matin, le 6e jour de juin, 1974, à moins que lesdits effets ne soient réclamés et tous les frais payés avant cette date.56967-15-0-o Le vice-président, W.M.Riley.CP EXPRESS LIMITED Notice is hereby given that all goods received previous to the first day of June, 1973.still remaining unclaimed in the offices of the \"CP EXPRESS LIMITED\" at different points in the Province of Québec, will be sold at Public Auction to the highest bidder by Frank Waddington, Auctioneer, at 189 Queen Street East, Toronto, Ontario, at eleven o'clock in the forenoon, on the 6th day of June, 1974, unless same shall be called for before that date, and all charges paid thereon.56967-15-6-o W.M.Riley.Vice-President. 3266 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Demandes à la Législature Applications to Legislature Jocelyne Girard Avis est donné que Jocelyne Girard, résidante et domiciliée dans les cité et district de Montréal, connue comme étant le sexe masculin s'adressera à l'Assemblée législative de la province de Québec afin d'obtenir une loi changeant son sexe conformément à sa nouvelle situation de fait et la correction des registres de l'état civil.Montréal, le 26 mars 1974.Les procureurs de la pétitionnaire, 56854-14-4-0 Archambault & Lapierre.Ville de Boucherville Avis public est par les présentes donné que la Ville de Boucherville s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte et la Loi constituant la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal, sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.Pour autoriser le conseil à adopter des règlements pour accorder une pension aux membres du conseil; 3.Pour remplacer pour la Ville de Boucherville l'article 122 de la Loi des cités et villes concernant la mise en candidature ou la nomination des personnes au poste de maire ou de conseiller de la ville; 4.Pour amender les paragraphes 1 et le de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre à la ville de réglementer les lots qui doivent être utilisés pour fins de parcs publics et pour établir une nouvelle procédure d'approbation des règlements de zonage; 5.a) pour remplacer le 3e alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de 825 la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; b) pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale; 6.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la ville d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés.7.Pour remplacer le paragraphe 2 de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances sur les terrains et l'enlèvement de telles nuisances aux frais des propriétaires; 8.Pour remplacer l'article 593 de la Loi des cités et villes pour établir une nouvelle procédure dans le cas de l'adoption de règlements d'emprunts; 9.Pour autoriser la ville à adopter des règlements sur réception de requêtes de propriétaires pour la construction de travaux publics; Jocelyne Girard Notice is given that Jocelyne Girard, residing and domiciled in the City and District of Montreal, known as being of the male sex, will apply to the Legislative Assembly of the Province of Québec for a private bill, changing her sex, according to her new actual statuts and for correction of the Civil Status Registers.Montreal, March 26, 1974.Archambault & Lapierre, 56854-14-4 Attorneys for the petitioner.Town of Boucherville Public notice is hereby given that the Town of Boucherville will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act amending its charter and the Act incorporating the Montreal South Shore Transit Commission, for the following purposes; 1.To add paragraph 2a to article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to sell at conditions indicated by the Municipal Commission certain immoveables acquired with a restriction; 2.To authorize the Council to enact by-laws to grant a pension to the members of the Council; 3.To replace for the Town of Boucherville article 122 of the Cities and Towns Act regarding the nomination of persons for or appointment of persons to the office mayor or alderman of the Town; 4.To amend paragraphs 1 and lc of article 426 of the Cities and 1 owns Act to authorize the Council to regulate the use of lands as public parks and to establish a new procedure for the approval of zoning by-laws; 5.(a) To replace the 3rd sub-paragraph of paragraph 17 of article 426 of the Cities and Towns Act to authorize the City to set at a maximum of 825 the fine provided for infractions to the traffic by-law; (6) to add after paragraph 17 of article 426 paragraph 17a which authorizes, in the case of infringement to the traffic by-law, the issuance of a summary notice; 6.To add paragraph 20a to article 429 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to enact a bylaw indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks or private properties; 7.To replace paragraph 2 of article 472 of the Cities and Towns Act relating to nuisances; 8.To replace article 593 of the Cities and Towns Act to prescribe a new procedure in the case of the adoption of borrowing by-law; 9.To authorize the Council to enact by-laws upon receipt of a petition of propriators for the construction of public works; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3267 10.Pour autoriser le conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par le ministre des affaires municipales et la Commission municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 11.Pour autoriser le conseil à constituer ce qu'il est convenu d'appeler un fonds de stabilisation des dépenses de déneigement; 12.Pour autoriser le conseil à prohiber par règlement l'utilisation des armoiries de la ville; 13.Pour autoriser le conseil à adopter par règlement un plan quinquennal de dépenses en immobilisation; 14.Pour amender pour la ville l'article 21 de la Loi sur l'évaluation foncière concernant la taxation des terrains de fermes ou boisés; 15.Pour amender pour la ville l'article 25 de la Loi .sur l'évaluation foncière afin de permettre l'envoi d'une copie du compte de taxes foncières générales municipales aux créanciers hypothécaires; 16.Pour amender pour la ville l'article 3 de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal pour en exclure la Ville de Boucherville.Et pour toutes autres fins.Montréal, ce 18 avril 1974.Les procureurs de la Ville de Boucherville, VlAU, bélanger, hébert, MaILLOUX, 57095-17-4-o Beauregard, Paquet & Pinard.Ville de Pierrefonds Avis public est donné que la Ville de Pierrefonds s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente ou à une prochaine session, pour les fins suivantes: 1.Pour demander un amendement au projet de loi proposé amendant la Loi de la Communauté Urbaine de Montréal, pour obtenir l'adoption d'une loi amendant la Loi de la Communauté Urbaine de Montréal, pour décréter que toutes les dépenses encourues par un service de la Communauté.excédant $100,000 au cours d'un même exercice financier, et occasionnées par un projet ou une manifestation organisé ou parrainé par une municipalité en dehors du cadre des services de la Communauté approuvés par le Conseil, seront à la charge de cette seule municipalité; 2.Pour obtenir l'adoption d'une loi amendant la charte de la Ville de Pierrefonds en amendant l'article 429-8° de la Loi des cités et villes pour augmenter à dix pourcent (10%) la superficie de terrain ou la somme à être donnée à la ville pour fins de parc ou de terrain de jeux comme condition préalable à l'approbation d'un plan de subdivision ; et pour toutes autres fins.Montréal, ce 23 avril 1974.Les procureurs de la Ville de Pierrefonds, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57100-17-4-q Beaurecard, Paquet & Pinard.10.To authorize the Council to acquire immoveables, to install public services and to sell said immoveables-at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for said purposes; 11.To authorize the Council to constitute a \"Snow removal expenses stabilization fund\"; 12.To authorize the Council to prohibit by by-law the use of the coat of arms of the Town ; 13.To authorize the Council to enact by by-law a \"Five-year plan for capital expenditures\"; 14.To amend for the Town article 21 of the Real Estate Assessment Act concerning the taxation of land used as farms or wood lots; 15.To amend for the Town article 25 of the Real Estate Assessment Act to authorize the insuance of a copy of the account for municipal general real estate taxes to the mortgage creditors; 16.To amend article 3 of the Act incorporating the Montreal South Shore Transit Commission to exclude Boucherville of the Montreal South Shore Transit Commission.And for all other purposes.Montreal, April 18th, 1974.VlAU, BÉLANGER, HÉBERT.MaILLOUX, Beauregard, Paquet & Pinard, 57095-17-4-o Attorneys for the Town of Boucherville.City of Pierrefonds Public notice is hereby given that the City of Pierrefonds will apply to the National Assembly of Québec, at its present or next session, for the following purposes: 1.To request an amendment to the proposed Bill amending the Montreal Urban Community Act, or to obtain the adoption of an Act amending the Montreal Urban Community Act, to provide that all expenses incurred by a department of the Community, exceeding 8100,000 in the course of a same fiscal year, and caused by a project or a manifestation organized or sponsored by a municipality outside of the framework of community services approved by the Council, shall be the responsibility of this single municipality; 2.To obtain the adoption of an Act amending the Charter of the City of Pierrefonds by amending article 429-8° of the Cities and Towns Act to increase to ten percent (10%) the area of land or the sum to be given to the City for park or playground purposes as a condition precedent to the approval of a subdivision plan; and for all other purposes.Montreal, April 23rd, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57100-17-4-q Attorneys for the City of Pierrefonds. 3268 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.100, No.17 Cite de Lachine Avis public est par les présentes donné que la Cité de Lachine s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, la disposition ou l'échange, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.a) Pour remplacer le troisième alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités ct villes pour permettre de fixer à un maximum de vingt-cinq dollars ($25) la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; 6) Pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités ct villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale; 3.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permetre à la Cité d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés; 4.Pour remplacer le paragraphe deuxième de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances; 5.Pour autoriser le Conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par la Commission municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 6.Pour ajouter le paragraphe 4a à la Loi des fonds industriels afin qu'au cas d'expropriation des lots 548, 549 et 550, la cité en devienne propriétaire sur dépôt du montant de l'offre; 7.Pour permettre au Conseil, par règlement, d'octroyer des subventions en matière de rénovation urbaine; 8.Pour permettre au Conseil, par règlement, de constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de stabilisation des dépenses de déneigement » ; 9.Pour permettre au Conseil, par règlement, de modifier son règlement numéro 1003 pour la jetée extérieure du Canal Lachine; 10.Pour ratifier un échange de terrain entre la cité et Dominion Bridge Company Ltd.; 11.Pour abroger l'article 14 du chapitre 78 des lois de 1945 (9 Geo.VI); 12.Pour abroger l'article 15 du chapitre 78 des lois de 1945 (9 Geo.VT); 13.Pour abroger l'article 6 du chapitre 72 des lois de 1951-52 (15-16 Geo.VI) et pour toutes autres fins.Montréal, ce 23 avril 1974.Les procureurs de la Cité de Lachine.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57097-17-4-q Beauregard, Paquet & Finaud.City of Lachine Public notice is hereby given that the City of Lachine will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an act amending its charter for the following purposes: 1.To add paragraph 2a to Article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the sale, disposal or exchange, at the conditions indicated by the Municipal Commission, certain immoveables acquired with a restriction; 2.(a) To replace the third sub-paragraph of paragraph 17 of Article 426 of the Cities and Towns Act to allow Council to fix at a maximum of twenty-five dollars ($25) the penalty provided for infraction to the traffic by-law; (6) To add after paragraph 17 of Article 426 of the Cities and Towns Act, paragraph 17a which permits, in the case of contravention to the traffic and public security by-law, the issuance of a summary notice prior to any penal prosecution; 3.To add paragraph 20a to Article 429 of the Cities and Towns Act to allow the City to adopt a by-law indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks and private properties; 4.To replace the second paragraph of Article 472 of the Cities and Towns Act concerning nuisances; 5.To authorize the Council to acquire immoveables, to install therein public services and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for such purposes; 6.To add paragraph 4a to the industrial funds Act so that in the case of the expropriation of lots 548, 549 and 550.the City shall become owner upon deposit of the amount of the offer; 7.To authorize Council to give grants, by by-law.for urban renewal; 8.To authorize Council to constitute by by-law a snow removal expenses stabilization fund; 9.To authorize Council, by by-law, to amend its by-law number 1003 for the exterior jetty for the Lachine Canal; 10.To ratify an exchange of land between the City and Dominion Bridge Company Ltd.; 11.To repeal Article 14 of Chapter 78 of the laws of 1945 (9 Geo.VI); 12.To repeal Article 15 of Chapter 78 of the laws of 1945 (9 Geo.VI); 13.To repeal Article 6 of Chapter 72 of the laws of 1951-52 (15-16 Geo.VI) and for all other purposes.Montreal, April 23, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard Paquet & Pinard.57097-17-4-o Attorneys for the City of Lachine. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 197J,, 106- année, n\" 17 3269 Ville de Kirkland Avis public est donné que la Ville de Kirkland s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, la disposition ou l'échange, aux conditions fixées par la Commission Municipale, d'immeuble acquis avec une restriction; 2.Pour obtenir l'adoption d'une Loi amendant la charte de la Ville de Kirkland en amendant l'article 429-8° de la Loi des cités et villes pour augmenter à dix pourcent (10%) la superficie de terrain ou la somme à être donnée à la ville pour fins de parc ou de terrain de jeux comme condition préalable à l'approbation d'un plan de subdivision; et pour toutes autres fins.Montréal, ce 23 avril 1974.Les procureurs de la Ville de Kirkland, Viau, Bélanger, Hébert, Maidloux, 57096-17-4-o Beauregard, Paquet & Pinard.La Cité de Verdun Avis public est par les présentes donné que la Cité de Verdun s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.Pour remplacer les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du paragraphe le de l'article 426 de la Loi des cités et villes afin d'établir une nouvelle procédure dans le cas d'amendements au règlement de zonage de la cité; 3.a) Pour remplacer le 3e alinéa'du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de $25.00 la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; b) pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale.4.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la cité d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés; 5.Pour amender l'article 449 de la Loi des cités et villes pour permettre à la cité de décréter par règlement que dans le cas d'immeubles de plus de 7 logements, la compensation pour l'usage de l'eau devra être payée par les propriétaires et pour décréter une diminution de la compensation pour l'usage de l'eau dans le cas d'immeubles inoccupés; 6.Pour remplacer le paragraphe 2 de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances; Town of Kirkland Public notice is hereby given that the Town of Kirkland will apply to the National Assembly of Québec, at its present or next session, for the following purposes: 1.To add paragraph 2a to Article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the sale, disposal or exchange, at the conditions indicated by the Municipal Commission, certain immoveables acquired with a restriction; 2.To obtain the adoption of an Act amending the Charter of the Town of Kirkland by amending article 429-8° of the Cities and Towns Act to increase to ten percent (10%) the area of land or the sum to be given to the City for park or playground purposes as a condition precedent to the approval of a subdivision plan; and for all other purposes.Montreal, April 23, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquft & Pinard, 57096-17-4-o Attorneys for I he Town of Kirkland.The City of Verdun Public notice is hereby given that the City of Verdun will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act amending its charter, for the following purposes: 1.To add paragraph 2a to article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to sell at conditions indicated by the Municipal Commission cerrain immoveables acquired with a restriction; 2.To replace the 2nd, 3rd, 4th and 5th sub-parapraph of paragraph lc of article 426 of the Cities and Towns Act, to establish a new procedure in the case of amendments to the zoning by-law of the City; 3.(a) To replace the 3rd sub-paragraph of paragraph 17 of article 426 of the Cities and Towns Act to authorize the City to set at a maximum of $25.00 the fine provided for infractions to the traffic by-law; (b) to add after paragraph 17 of article 426 paragraph 17a which authorizes, in the case of infringement to the traffic by-law, the issuance of a summary notice; 4.To add paragraph 20a to article 429 of the Cities and Towns Act to enact a by-law indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks or private properties; 5.To amend article 449 of the Cities and Towns Act to authorize the City to decree by by-law that in the case of immoveables of more than seven apartments, the compensation for water shall be paid by the proprietors and to decree a reduction of said compensation in the cases of vacant premises; 6.To replace paragraph 2 of article 472 of the Cities and Towns Act relating to nuisances; 3270 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 7.Pour autoriser le conseil à acquérir des immeubles, y aménager des services publics et les vendre aux conditions déterminées par la Commission municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 8.Pour autoriser le conseil à constituer ce qu'il est convenu d'appeler un fonds de stabilisation des dépenses de déneigement; 9.Pour autoriser le conseil à prohiber par règlement l'utilisation des armoiries de la cité; 10.Pour autoriser le conseil à adopter par règlement un plan quinquennal de dépenses en immobilisation; 11.Pour autoriser le conseil à constituer par règlement un fonds de stationnement; 12.Pour autoriser le conseil à décréter par règlement l'exécution de travaux permanents de rues, trottoirs, éclairages, etc.et à effectuer à cette fin des emprunts approuvés par le ministre des affaires municipales et la Commission municipale de Québec; 13.Pour autoriser le conseil à adopter des règlements pour accorder une pension aux membres du conseil; 14.Pour autoriser le conseil à réunir certaines taxes en une seule taxe appelée « taxes de services »; 15.Pour accorder à la cité le pouvoir d'effectuer elle-même son rôle de valeur locative; 16.Pour répartir tout ou partie du déficit de la cité accumulé au 31 décembre 1972 sur une période n'excédant pas 15 ans et contracter des emprunts à cette fin; 17.Pour abroger certains articles de la charte de la cité, soit: a) l'article 7 du chapitre 103 des lois de 1961 (9-10 Elizabeth 11); 6) l'article 4 du chapitre 83 des lois de 1950 (14 Geo.VI); c) l'article 8 du chapitre 102 des lois de 1971.d) l'article 3 du chapitre 76 des lois de 1964 (12-13 Elizabeth II).et pour toutes autres fins.Montréal, ce 17 avril 1974.Lea procureurs de la Cité de Verdun, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux.57101-17-4-o Beauregard.Paquet & Pinard.Ville de La Prairie Avis public est par les présentes donné que la Ville de la Prairie s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte, sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission Municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.Pour remplacer les 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du paragraphe le de l'article 426 de la Loi des cités ct villes afin d'établir une nouvelle procédure dans le cas d'amendements au règlement de zonage de la ville; 3._ a) Pour remplacer le 3e alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la I-oi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de $25 la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; 7.To authorize the Council to acquire immoveables, to install public services therein and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for said purposes; 8.To authorize the Council to constitute a \"Snow removal expenses stabilization fund\"; 9.To authorize the Council to prohibit by by-law the use of the coat of arms of the City; 10.To authorize the Council to enact by by-law a \"Five-year plan for capital expenditures\"; 11.To authorize the Council to constitute by by-law a \"Parking Fund\"; 12.To authorize the Council to enact by by-law the execution of public works and to adopt borrowing by-laws for each purpose which shall be approved by the Minister of the Municipal Affairs and the Municipal Commission; 13.To authorize the Council to enact a by-law to grant a pension to the members of the Council; 14.To authorize the Council to join certain taxes into a \"Service Tax\"; 15.To authorize the City to prepare its own roll of rental values; 16.To apportion all or part of the deficit accumulated on the 31st of December 1972 over periods not to exceed 15 years and to adopt borrowing by-laws for such purpose.17.To repeal certain articles of the charter of the City, to wit: (a) Section 7 of Chapter 103 of the Statutes of 1961 (9-10 Elizabeth II); (6) Section 4 of Chapter 83 of the Statutes of 1950 (14 Geo.VI); (c) Section 8 of Chapter 102 of the Statutes of 1971.(d) Section 3 of Chapter 76 of the Statutes of 1964 (12-13 Elizabeth II).and for all other purposes.Montreal, April 17, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57101-17-4-o Attorneys for the City of Verdun.Town of La Prairie Public notice is hereby given that the Town of La Prairie will apply to the National Assembly of Québec, at its present session, for the adoption of an Act amending its charter, for the following purposes; 1.To add paragraph 2a to the article 26 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to sell at conditions indicated by the Municipal Commission, certain immoveables acquired with a restriction; 2.To replace the 2nd, 3rd, 4th and 5th sub-paragraphs of paragraph lc of article 426 of the Cities and Towns Act, to establish a new procedure in the case of amendments to the zoning by-law of the Town; 3.(a) To replace the 3rd sub-paragraph of paragraph 17 of article 426 of the Cities and Towns Act to authorize the City to set at a maximum of $25 the fine provided for infractions to the traffic by-law; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n° 17 3271 6) pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale ; 4.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la ville d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs et terrains privés; 5.Pour amender l'article 427-1 le de la Loi des cités et villes pour permettre au conseil de décréter par règlement que la compensation prévue à cet article est payable par les propriétaires; 6.Pour ajouter le paragraphe 8° à l'article 442 de la Loi des cités et villes pour décréter une diminution de la compensation pour l'usage de l'eau dans le cas d'immeubles inoccupés; 7.Pour remplacer le paragraphe 2° de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances sur des terrains et l'enlèvement de telles nuisances aux frais des propriétaires; 8.Pour autoriser le conseil à acquérir des immeubles, y aménager des service's publics et les vendre aux conditions déterminées par la Commission Municipale et à contracter des emprunts à cette fin; 9.Pour autoriser le conseil à constituer ce qu'il est convenu d'appeler un fonds de stabilisation des dépenses de déneigement; 10.Pour autoriser le conseil à prohiber par règlement l'utilisation des armoiries de la ville; Et pour toutes autres fins.Montréal, ce 18 avril 1974.Les procureurs de la Ville de La Prairie, VlAU, bélanger, hébert, MaILLOUX, 57098-17-4-O Beauregard, Paquet & Pinard.Cité de LaSalIe Avis pubiic est par les présentes donné que la Cité de LaSalle s'adressera à l'Assemblée Nationale de Québec, à sa présente session, pour l'adoption d'une loi amendant sa charte sur les matières suivantes: 1.Pour ajouter le paragraphe 2a à l'article 26 de la Loi des cités et villes pour permettre la vente, aux conditions fixées par la Commission municipale, d'immeubles acquis avec une restriction; 2.a) Pour remplacer le troisième alinéa du paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes pour permettre de fixer à un maximum de vingt-cinq dollars ($25) la pénalité prévue pour infraction au règlement de circulation; 6) Pour ajouter après le paragraphe 17 de l'article 426 de la Loi des cités et villes, le paragraphe 17a qui permet, dans le cas de contravention au règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique, la remise d'un avis sommaire avant toute poursuite pénale; 3.Pour ajouter le paragraphe 20a à l'article 429 de la Loi des cités et villes pour permettre à la cité d'adopter un règlement indiquant que la neige pourra être soufflée ou déposée sur les trottoirs ct terrains privés; (b) to add after paragraph 17 of article 426 paragraph 17a which authorizes, in the case of infringement to the traffic by-law, the issuance of a summary notice; 4.To add paragraph 20a to article 429 of the Cities and Towns Act to authorize the council to enact a by-law indicating that snow may be blown or deposited on sidewalks or private properties; 5.To amend article 427-llc of the Cities and Towns Act to authorize the Council to enact by by-law that the compensation prescribed by said article is payable by the proprietors; 6.To add paragraph 8° to article 442 of the Cities and Towns Act to decree a reduction of the compensation in the cases of vacant premises; 7.To replace paragraph 2° of article 472 of the Cities and Towns Act relating to nuisances; 8.To authorize the Council to acquire immoveables to install public services and to sell said immoveables at the conditions determined by the Municipal Commission and to borrow for said purposes; 9.To authorize the Council to constitute a \"Snow removal expenses stabilization fund\"; 10.To authorize the Council to prohibit by by-law the use of the coat of arms of the Town.And for all other purposes.Montreal, April 18th, 1974.VlAU, bélanger, hébert, MaILLOUX, Beauregard, Paquet & Pinard, 57098-17-4-o Attorneys for the Town of La Prairie.City of LaSalle Public notice is hereby given that the City of LaSalle will apply to the Québec National Assembly, at its present session, for the adoption of an act amending its charter for the following purposes: 1.To add paragraph 2a to section 26 of the Cities and Towns Act to authorize the sale, at the conditions set by the Québec Municipal Commission, of immoveables acquired with a restriction; 2.(a) To replace the third sub-paragraph of paragraph 17 of Section 426 of the Cities and Towns Act to authorize Council to set at a maximum of twenty-five dollars ($25) the penalty provided for infraction to the traffic by-law; (6) To add after paragraph 17 of Section 426 of the Cities and Towns Act.paragraph 17a which authorizes, in the case of contravention to the traffic and public security by-law, the issuance of a summary notice prior to any penal prosecution ; 3.To add paragraph 20a to Section 429 of the Cities and Towns Act to authorize the city to adopt a by-law indicating that the snow shall be blown or deposited on the sidewalks and private properties; 3272 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.April 27, 1974, Vol.IOC, No.17 4.Pour remplacer l'article 449 He la Loi des cités et villes afin de permettre au Conseil do décréter par règlement que la compensation pour l'usage de l'eau sera payée par les propriétaires dans les cas d'immeubles de plus de cinq (5) logements ou dans les cas d'immeubles commerciaux comprenant plusieurs commerces ainsi que d'accorder une diminution de cette compensation lorsque le logement aura été inoccupé pendant au moins trois (3) mois; 5.Pour amender le paragraphe 11c de l'article 427 de la Loi des cités et villes afin d'autoriser le Conseil à décréter par règlement que la compensation pour l'enlèvement des vidanges sera payée par les propriétaires dans les cas d'immeubles de plus de cinq (5) logements tt dans les cas d'immeubles commerciaux comprenant plusieurs commerces ainsi que pour accorder une diminution de cette compensation pour toute période pendant laquelle une unité de logement aura été inoccupée pcndanl au moins Irois (3) mois; (i.Pour amender l'article 122 de la Loi des cités et villes afin de préciser dans quels cas les locataires pourront être mis en candidature, élus ou nommés maire ou conseiller de la cité; 7.Pour remplacer le paragraphe deuxième de l'article 472 de la Loi des cités et villes relatif aux nuisances; 8.Pour permettre au Conseil, par règlement, de constituer un fonds connu sous le nom de « fonds de stabilisation des dépenses de déneigement » ; 9.Pour autoriser le Conseil à prohiber par règlement l'utilisation du nom, de l'écusson ct des armoiries de la cité; 10.Pour amender l'article 517 de la Loi des cités ct villes afin de permettre au conseil de déterminer le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes scolaires que la cité doit percevoir; 11.Pour autoriser le Conseil à accorder par règlement une pension aux membres du Conseil; et pour toutes autres fins.Montréal, ce 22 avril 1974.Les procureurs de la CM de IxtSalle, Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, 57099-17-4-o Beauregard, & Paquet, Pinard.Ventes par Shérifs AVIS PUBLIC est par la présente donné que les TERRES et HÉRITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.MONTRÉAL Fieri Fadas de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal ( T A SOCIETE D'HYPOTHE-No 05-014079-73X ^ QUES DU BAS-CANADA v INC., demanderesse, vs J.ROLAND ROBERT & YVAN DAGENAIS, défendeurs, et LE REGISTRATEUR de Montréal, mis en cause.4.To replace Section 449 of the Cities and Towns Act to authorize the council to enact by by-law that the compensation for the use of water shall be paid by the owners in the case of immoveables of more than five (5) dwellings and in the case of commercial immoveables housing more than one business as well as to grant a reduction of said compensation when the dwelling has been inoccupied for at least three (3) months; 5.To amend paragraph 11c of section 427 of the Cities and Towns Act to authorize Council to enact by by-law that the compensation for garbage removal shall be paid by the owners in the case of immoveables of more than five (5) dwellings and in the case of commercial immoveables housing more than one business as well as to grant a reduction of said compensation for the period during which said dwelling shall have remained inoccupied for more than three (3) months; 6.To amend section 122 of the Cities and Towns Act to specify in what cases the tenants may be nominated, elected or appointed Mayor or councillor of the city; 7.To replace the second paragraph of Section 472 of the Cities and Towns Act concerning nuisances; 8.To authorize the Council to create by by-law a snow removal expenses stabilization fund; 9.To authorize Council to prohibit by by-law the use of the City's name and coat of arms; 10.To amend section 517 of the Cities and Towns Act to authorize the Council to set the rate of interest on the school tax arrears which the city must collect; 11.To authorize the Council to grant by by-law a pension to the members of Council; and for all other purposes.Montreal, April 22, 1974.Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, 57099-17-4-o Attorneys for the City of LaSalle.Sheriff's Sales PUBLIC NOTICE, is herebv given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal (TA SOCIETE D'HYPOTHE-No.05-014079-73X *-< QUES DU BAS-CANADA I INC., plaintiff, vs J.ROLAND ROBERT and YVAN DAGENAIS, defendants, and THE REGISTRAR for Montreal, mi en cause. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.27 avril 1974.106' année, n\" 17 3273 « Un emplacement ayant front sur l'Avenue Hôtel île ville, en la ville de Montréal composé comme suit, savoir: a) La subdivision un de la subdivision deux cent cinquante et un du lot cent trente-sept (137-251-1) aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte St-Louis; et 6) La partie sud-est de la subdivision deux cent cinquante et un dudit lot cent trente-sept (137Ptie S.E.251) auxdits plan et livre de renvoi officiels mesurant vingt-cinq pieds de largeur sur soixante-quinze pieds de profondeur, mesure anglaise, et bornée comme suit: en front par l'Avenue Hôtel de ville, en arrière par une partie des lots cent trente-neuf et cent quarante desdits plan et livre de renvoi officiels, d'un côté par la subdivision deux cent cinquante dudit lot cent trente-sept et de l'autre côté par le résidu de ladite subdivision deux cent cinquante et un dudit lot cent trente-sept; Avec toutes les bâtisses dessus érigées, notamment la maison portant le numéro civique 4895 Avenue Hôtel de ville.Tel que le tout se trouve présentement, sans exception ni réserve avec toutes servitudes et droits quelconques se rattachant audit emplacement.Cet immeuble doit être annoncé à charge de l'hypothèque en faveur du Crédit Foncier Franco Canada, enregistré le 12 octobre 1971, sous le numéro 2306265 à Montréal.» Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de justice en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56.le VINGT-HUITIÈME jour de MAI 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 17 avril 1974.57085-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C T A BANQUE CANADIENNE No 05-010384-73.< IMPÉRIALE DE COM-* MERCE, demanderesse, tu SANDER VAN DEN HOEK.domicilié au 11246-48 Ubald Paquin, Montréal Nord, P.Q., défendeur.« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro deux cent trente-neuf de la subdivision du lot numéro vingt-trois (23-239) aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Sault au Récollet, de forme irrégulière, borné en front au nord-est par le lot No.23-146 (Avenue Ubald-Paquin), au sud-est par le lot No.23-238, au sud-ouest par les lots Nos.23-197 et 23-198 et au nord-ouest par le lot No.23-240; mesurant trente-cinq pieds et vingt-huit centièmes de pied (35.28') au nord-est, cent vingt et un pieds et quatre-vingt-quinze centièmes de pied (121.95') au sud-est, trente-sept pieds et soixante-six centièmes de pied (37.66') au sud-ouest et cent vingt et un pieds et quatre-vingt trois centièmes de pieil (121.83') au nord-ouest; contenant en superficie quatre mille, quatre cent quarante-cinq pieds carrés ct trois dixièmes de pied carre (4,445.3 pi.car.) m.a.\"An emplacement fronting on Hôtel de ville Avenue, in the City of Montreal, comprising the following, to wit: (a) Subdivision one of subdivision two hundred fifty-one of lot one hundred thirty-seven (137-251-1) on the official plan and in the book of reference for the Incorporated Village of Côte St.Louis; and (6) The southeast part of subdivision two hundred fifty-one of said lot one hundred thirty-seven (137 S.E.Pt.251) on said official plan and in said book of reference, measuring twenty-five feet in width by seventy-five feet in depth.English measure, and bounded as follows: in front by Hôtel de ville Avenue, in the rear by a part of lots one hundred thirty-nine and one hundred forty on said official plan and in said book of reference, on one side by subdivision two hundred fifty of said lot one hundred thirty-seven and on the other side by the remainder of said subdivision two hundred fifty-one of said lot one hundred thirty-seven; With all the buildings erected thereon, namely a house bearing civic number 4895 Hôtel de ville Avenue.As the whole now subsists, without any exception or reservation, with any servitude and right attaching to said emplacement.Said immoveable shall be reported as subject to a mortgage in favour of Credit Foncier Franco Canada, registered the 12th.October 1971, under number 2306265 in Montreal.\" To be sold at the Sheriff's Office, in the City of Montreal Court House, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56.on the TWENTY-EIGHTH day of MAY 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 17th, 1974.57085-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal C THE CANADIAN IMPERIAL No.05-010384-73A -1- BANK OF COMMERCE, I plaintiff, m SANDER VAN\" DEN HOEK.domiciled at 11246-48 Ubald Paquin, Montreal-North, P.Q., defendant.\"An immoveable known and described as being lot number two hundred thirty-nine, subdivision of lot number twenty-three (23-239) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Sault-au-Récollet, of irregular configuration, bounded in front on the northeast by lot number 23-146 (Ubald-Paquin Avenue), on the southeast by lot number 23-238, on the southwest by lots numbers 23-197 and 23-19S and on the northwest by lot number 23-240: measuring thirty-five and twenty-eight hundredths feet (35.28') on the northeast, one hundred twenty-one and ninety-five hundredths feet (121.95') on the southeast, thirty-seven and sixty-six hundredths feet (37.66') on the southwest and one hundred, twenty-one and eighty-three hundredths feet (121.S3') on the norhtwest; covering an area of four thousand four hundred forty-five and three tenths square feet (4.445.3 sq.ft.), E.M. 3274 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, April 27, 1974, Vol.106, No.17 Avec la bâtisse portant le numéro civique 11246-48 Avenue Ubald-Paquin, Montréal Xord, P.Q.» Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice, en la Ville de Montréal, 10 est, rue Craig.10e étage, chambre 56, le TRENTE ET UNIÈME jour de MAI 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 17 avril 1974.57090-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l /\"VMER MARTINEAU, demeu-No 05-013416-72X V-' rant et domicilié dans les v cité et district de Montréal, demanderesse, vs ROMANI DOGANIERI, demeurant et domicilié au 5291 rue Chabot à Montréal, dit district, défenderesse, et LE REGISTRATEUR du Bureau d'enregistrement de Montréal, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin, Quartier Rivièrc-des-Prairies, Montréal, et connu et désigné comme étant une partie du lot originaire cent cinquante (Ptie 150) des plan ct livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des-Prairies; mesurant soixante pieds et quinze centièmes de pied (60.15') de largeur, en front dans la ligne sud-est; sur une profondeur de cent soixante-deux pieds (162') dans la ligne nord-est; et borné en front, vers le sud-est par le Boulevard Gouin; en arrière vers le nord-ouest par la Rivière-des-Prairies, d'en côté vers le sud-ouest par partie du même lot appartenant à M.Lajeumi; et de l'autre côté du nord-est, par partie du même lot appartenant à M.Lévesque, sans bâtisse; Tel que le tout se trouve présentement, avec tous droits y inhérents, et toutes servitudes actives et passives apparentes ou occultes s'y rattachant; » Pour être vendu au bureau du Shérif, au Palais de Justice en la ville de Montréal, 10 est, rue Craig, 10e étage, chambre 56, le TRENTIÈME jour de MAI 1974, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du Shérif, Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, ce 17 avril 1974.57091-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal C T A BANQUE D'EPARGNE No 05-016 564-73.S *-> DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL, corporation légalement constituée ayant son principal établissement et siège social au 276 ouest rue St-Jacques, dans la ville et le district de Montréal, demanderesse-saisissante es MAURICE JASMIN, résidant au 35 rue Jules-Roches, dans la cité de Longueuil, district de Montréal, et LES HABITATIONS JASMAU INC., corporation ayant son siège social à St-Janvier-de-Blainville et un principal établissement à Longueuil, district de Montréal, co-défendeurs-saisis.With the building bearing civic number 11246-48 Ubald-Paquin Avenue, Montreal-North, P.Q.To be sold at the Sheriff's Office, at the Court House, in the City of Montreal, 10 Craig Street East, 10th Floor, Room 56, on the THIRTY-FIRST day of MAY, 1974, at ELEVEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office, Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal, April 17, 1974.57090 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal C f~\\MER MARTINEAU, residing No.05-013416-72.S and domiciled in the City Québec Progressive Realty Limited (The).3165 Québec Seed Growers Limited.3165 Quigley Steeplejack Co.Ltd.3165 Quincaillerie moderne (limitée) (La).3165 R.I.Humidifyer & vent Companv of Canada Ltd.3165 Rachel Investors Limited.3165 Racine Advertising Services Ltd.3165 Racine (Albert) inc.3165 Racine's (Alphonse) Building Specialties Limited.3165 Radio Accessories Limited.3165 Radio cinéma limitée.3165 Radio Programme Producers Limited.3166 Radio Publications Limited.3166 Railroad Porter's Social Club.3166 Rainbow Pearls Corp.3166 Rambert Investments Limited.3166 Rambler Gold Syndicate Limited.3166 Ramsay Vutomobilcs Inc .3166 Ramsley Lingerie Co.Limited.3166 Ramsev Gold Mines Limited.3166 Randolph (David) Dress Inc.3166 Randolph Sportswear Mfg.Co.Ltd.3166 Ravis Incorporated.3166 Rayex électrique ltée.3166 Ravlartic Consolidated Mines Limited.3166 Realties Ltd.3166 Red Rock Cola (Québec) Limited.3166 Regal Dress Mfg.Co.Ltd.3166 Regal Investments Limited.3166 Regal Specialty Shoppes Incorporated.3166 Regency Clothes Inc.3166 Regina Pen Corp.3166 Reliable Agencies Limited.3166 Reliable Dress Company.3166 Reliable Trimming Mfg.Co.3166 Reliance Machine & Welding Company Limited.3166 Reliance Sportswear Co.3166 Remèdes Faguet inc.(Les).3166 Renaissance Films Distribution Inc.3166 Renaissance Films Inc.3166 René Lingerie Shoppes Inc.3166 Reo Service Stores Limited.3166 Resorts Limited.3166 Restall Slipper Co.Limited.3166 Restaurant Chez Fred inc.3166 Restaurant Robil inc.3166 Reynolds (G.H.) Québec Gold Mines Ltd.3166 Richard, amusement limitée.3167 Richelieu Greeting Cards Limited.3167 Richer Drug Co.3167 Rikois Theatre (Rimouski) Ltd.3167 Rolo-moto inc.3167 Rouking Inc.3167 Roy & Cloutier plomberie et chauffage inc.3167 S.K.D.& Associés ltée.3167 Safari inc.3167 Salaberry Auto Neige inc.3167 Samovar Amusement Ltd.3167 Samson (Germain) inc.3167 Samuels (Leo) Inc.3167 Sanctae Rosallis Mining Corporation.3167 Sandford Investment Corporation.3167 Sandfold Realty Corporation.3167 Sangster's Garage Limited.3167 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 avril 1974, 106' année, n\" 17 3289 Lettres patentes annulées: Letters Patent Annulled: (suite) (continued) Sanguinet Grain & Feed Company Limited.3167 Sarmac Gold Mining Corporation.3167 Saturnyte Gold Mines Limited.3167 Liability).3167 Sauvé Baron limitée.3167 Saving Waste Paper Co.Ltd.3167 Sawyer's Limited.3167 Schering (Canada) Limited.3167 Schilling (J.L.) Co.(Canada) Ltd.3167 Schneiderman Incorporated.3167 Scientific Enterprises Ltd.3167 Scotts Montreal Limited.3167 Scrivens (E.C.) & Co.Ltd.3167 Seeboard Export and Import Corporation.3167 Seale & Son Ltd.3167 Secrétariat des syndicats catholiques et nationaux de Sorel.3167 Segal (Lionel) Textiles Ltd.3167 Selby Furniture Mfg.Ltd.3167 Seneca Construction Inc.3167 Senneterre Prospectors Limited.3167 Service Enterprises Limited.3168 Service des loisirs St-Zotique.3168 Services immobiliers d'Alma inc.(Les).3168 Sherbrooke Metal & Supply Co.Ltd.3168 Smoll's Incorporated.3168 Snowdon Electrical Appliances Inc.3168 Société éducationnelle de la plomberie sanitaire.3168 Société des amis de l'enfance.3168 Société des amis de l'enfance abandonnée.3168 Société d'archéologie de la côte nord.3168 Société de bienfaisance des enfants nécessiteux.3168 Société chorale de Dolbeau incorporée.3168 Société de développement industriel et commercial ltée.3168 Société générale d'immeubles limitée.3168 Société médicale de Québec incorporée (La).3168 Société post-études secouristes.3168 Société de prêts et finance incorporée (La).3168 Société des rendez-vous artistiques inc.(La).3168 Société St-Jean-Baptiste de Chicoutimi (La).3168 Société St-Jean-Baptiste de Clermont (La).3168 Société St-Jean-Baptiste de Dolbeau (La).3168 Société St-Jean-Baptiste de Notre-Dame-de-la- Recouvrance inc.3168 Solomon's Incorporated.3168 Sol val limitée.3168 Sorel Glass Limited.3168 Soroda Gold Mines Limited.3168 South Lamaque Gold Mines Limited.3168 South Ridge Lumber Company.3168 Soutien mutuel incorporée.3168 Specialty Sales Corporation.3168 Speers (R.James) Incorporated.3168 Sphinx Abitibi Mines Corporation.3168 Sport & Guns Incorporated.316S Springings (Cecil) and Company Limited.3168 Stadium Meat Market Inc.3168 Stainless & Alloy Metal Corp.3168 Stainless Steel Speciality Limited.3169 Standard Cloak & Suite Co.Ltd.3169 Standard Duplicators Limited.3169 Standard Plumbing Protective Corporation Limited.3169 Standard Window Cleaning Limited.3169 Stanfield Securities Limited.3169 Stanich Gold Mines Limited.3169 Stanrod Limited.3169 Stanstead Fur Farming Company Limited.3169 Star Cloak Corp.3169 Star Dress Incorporated.3169 Star Finance Corporation.3169 Star Produce Co.3169 Steamship Gear Limited.3169 Steel Auto Body Co.3169 Sténotype Institute of Montreal Inc.3169 Sterl-A-Fone Corporation of America Ltd.3169 Sterling Chocolate Co.Ltd.3169 Sterling Corporation (The).3169 Sterling Printing Service Limited (The).3169 Steson Clothing Co.3169 Steven Corp.3169 Stevens Agencies Limited.3169 Stober's Department Stores Ine.3169 Stool Furniture Manufacturing Company.3169 Stone (J.T.) & Company Limited.3169 Stone & Quarry Limited.3169 Stonecraft Ltd.3169 Storfer Cartage Co.Limited.3169 Strachan Brothers Ltd.3169 Strand Cloak Company.3169 Stratacite Industries Ltd.3169 Strate Utility Corporation.3169 Strong Forget Footwear Limited.3169 Style Berber Shop & Beauty Salon Inc.3169 Taverne Viau Hochelaga inc.3169 Tiblemont (Raymond) Gold Mines Québec Limited.3169 Topping & Leblanc Inc.3170 Trans World Marketing Inc.(Erratum).3276 Trempe (Guv) électrique inc.3170 Will (Ken) Metal Products Limited.3170 Windsor Manufacturing Company Ltd.3170 Révocation de Revocation of dissolution: Dissolution: Blumers Ltd.3170 Bureau de crédit de l'Estrie inc.3170 Bying Fish and Game Club.3170 Club de tir de Boucherville inc.3170 Club des Trois Geais.3170 Club Henri.3170 Club Odanak.3170 Club Patrick Est.3170 Ferncraftlnc.3170 Franchise-Marketing Consultants (Montreal) Inc.3170 Immeubles Coulombe ltée (Les).3170 3290 QUÉBEC.OFFICIAL GAZETTE.April 27, 1974, Vol.106, No.17 Revocation de Revocation of dissolution: Dissolution: (suite) (continued) Joshua Lake Club.3170 Marie Paule Inc.3170 Restaurant Au Fin Gourmet Asbestos inc.3170 Sauna Aquarius inc.3170 Wilkins (W.M.) Inc.3170 Société d'habitation Québec Housing du Québec Corporation Jonquière, cité-city (Programme de rênovation-Renewal program).3256 Municipal Housing Bureau of Greenfield Pard (L.P.).3256 Office Munucipal d'habitation de Greenfield Park (L.P.).3256 SOUMISSIONS \u2014 TENDERS \u2014 demandes de Requests for Lapointe, c.s.r.'-r.s.b.3259 Rimouski, cité-city.3257 Saint-Roch-de-l'Achigan, par.3263 Val-Monts, c.s.-s.b.3261 SYNDICATS PROFESSIONAL PROFESSIONNELS SYNDICATES Syndicat des travailleurs de l'enseignement des Laurentides (Nom-Name ch.).3250 VENTES SALES Effets non réclamés Unclaimed Goods CP.Express Limited.3265 Cie des Messageries CP Limitée (La).3265 Par Shérifs By Sheriffs Montréal Montreal Banque Canadienne Impériale de Commerce (La) vs Sander Van Den Hoek.3273 Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal (La) vs Jasmin et ai.3274 Canadian Imperial Bank of Commerce (The) vs Sander Van Den Hoek.3273 Martineau vs Doganieri.3274 Montreal City and District Savings Bank (The) vs Jasmin et ai.3274 Société d'hypothèques du Bas-Canada inc.(La) »f Robert et al.3272 Québec Québec Engrais chimiques Lévis ltée (Les) vs Drouin.3275 Taxes Taxes Kénogami, cité-city.3229 Richmond, ville-town.3230 St-Hubert, ville-city.3069 Sherbrooke, comté-county.3231 SOMMAIRE SUMMARY Arrêté en conseil.3246 Associations coopératives.3246 Avis divers.3243 Caisses d'épargne et de crédit.3239 Changement de nom.Loi du: Accordés.3181 Demandes.3242 Commission des transports du Québec.3182 Compagnies, Loi des: Abandon de charte.3227 Changement de nom.3228 Demandes d'abandon de charte.3241 Divers.3240 Fusion.3228 Lettres patentes (1\" partie).3171 Lettres patentes (3e partie).3226 Lettres patentes supplémentaires.3254 Compagnies étrangères: Permis.3247 Demandes à la Législature.3266 Liquidation des compagnies, Loi de la.3247 Ministères: Affaires municipales.3237 Éducation.3245 Proclamations.3251 Renseignements sur les compagnies: Avis de dissolution éventuelle de corporation.3146 Erratum.3171 Lettres patentes annulées.3156-3276 Révocation de dissolution.3170 Société d'habitation du Québec.3256 Soumissions.3257 Syndicats professionnels, Loi dfs.3250 Ventes: Effets non réclamés.3265 Par shérifs: Montréal.3272 Québec.3275 Pour taxes.3069-3229 Applications to Législature.3266 Change of Name Act: Applications.3242 Granted.3181 Companies Act: Amalgamation of companies.3228 Applications for surrender of charter.3241 Change of name.3228 Letters patent (Part I).3171 Letters patent (Part III).3226 Letters patent supplementary.3254 Miscellaneous.3240 Surrender of charter.3227 Compagnies Information Act: Erratum.3171 Notice of eventual dissolution of corporations.3146 Letters Patent Annulled.3156-3276 Revocation of dissolution.3170 Cooperative Associations.3246 Departments: Education.3245 Municipal Affairs.3237 Extra-Provincial Companies Act: Licences.3247 Miscellaneous Notices.3243 Order in Council.3246 Proclam ations.3251 Professional Syndicates Act.3250 Québec Housing Corporation.3256 Québec Transport Commission.3182 Sales: By Sheriffs: Montreal.3272 Québec.3275 For taxes.3069-3229 Unclaimed Goods.3265 Savings and Credit Unions.3239 Tenders.3257 Winding-Up Act.3247 nouveautés Ministère des Affaires sociales Régie de l'assurance-maladie du Québec 1.2.1.\u20141753 Statistiques annuelles 1972 / Annual Statistics Québec, 1973.328 p.$ 5.00 Ministère des Communications 4.2.3\u20141786 Répertoire téléphonique.Le réseau gouvernemental intercentre.Les postes téléphoniques, les postes de téléscripteurs Québec, mars 1974.312 p.S 2.00 3.2.2\u2014797 Le Drapeau québécois Québec, 1974.96 p., 23 ill.couleurs $ 3.00 Retrace l'histoire des drapeaux, armoiries et emblèmes utilisés en Nouvelle-France et au Québec jusqu'à l'avènement du fleurdelisé.Contient aussi le protocole complet de déploiement du fleurdelisé et une bibliographie complète relative au drapeau, compilée par la Bibliothèque nationale.Ministère des Finances Bureau du contrôleur des finances 4.2.2.\u20141777 Comptes publics de la province de Québec 1972/73 pour l'année financière terminée le 31 mars 1973 Pu6//c Accounts of the Province of Québec 1972/73 tor the fiscal year ended March 31, 1973.QuèbèTTS?Caisse de degptfttfllflftanient < u Québec 2.3.3\u20144776 Rapport annueT'dai^efffoflPWiitfe 1973 flight Annua) Rep art 1973.Québec, 1974.82 p.S 7.50 te exercice $ 1.00 Ministère du Revenu 4.2.2.\u20141778 Loi de la taxe sur les télécommunications Telecommunications Tax Act 1965 (1ère sess.) ch.28 avec modifications 7965 (1st sess.) c.28 and amendments Québec, 1972.6 p.Codification administrative Office consolidation 1972 S 0.50 Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche 2.3.2.\u20141751 Rapport annuel du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pèche (1972/73).Québec, 1974.266 p.s ta! .tabl.S 3.00 Ministère des Travaux publics et Approvisionnement 4.2.3\u20141750 Rapport annuel du ministère des Travaux publics (1972/73).Québec, 1973.33 p.S 1.00 Service général des achats 4.2.3\u20141752 Répertoire des taux de location Effectif le 1er avril 1974 Québec, 1974.Paginations diverses (polycopié) S 3.00 JL l'éditeur officiel ?du québec 675, EST BOUL.ST-CYRILLE QUÉBEC "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.