Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 février 1975, Partie 1 samedi 22 (no 8)
[" AVIS JURIDIQUES PARTIE 1 JURIDICAL NOTICES 107e ANNÉE 22 FÉVRIER 1975 NO 8 $, GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\t\tL 71\t\t\t\t\u20141\t C++.:.+/+:.:? GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 février 1975.107' année.n° 8 1635 PARTIE 1 Atefe PART 1 AVIS AUX ANNONCEURS ?*CjJL 1 NOTICE TO READERS 1.Prière d'adresser aux bons soins de l'Éditeur officiel^ 1.Address all communications to the Québec Official du Québec.Québec, toute communication d'avis desti- \\ Gazette, c o The Québec Official Publisher, Québec, née à la Gazette officielle du Québec.2.La Gazelle officielle du Québec est composée de deux parties, dont chacune est bilingue conformément au Règlement de la Gazelle officielle du Québec.La partie 1 paraît le samedi matin et conl ient des avis généraux, proclamations, avis légaux diver* et certains décrets.3.Pour éviter aux annonceurs tout retard «lans la publication de leurs avis, ils sont priés de les communiquer, si possible, dans les deux langues officielles.L'Editeur officiel du Québec peut toutefois différer la publication de certains avis, à cause de leur longueur ou pour des motifs d'administration.4.Indiquer le nombre d'insertions.5.Payer comptant et avant publication le coût des annonces, suivant le tarif ci-dessous, excepté lorsque ces annonces doivent être publiées plusieurs fois.En ce cas.l'intéressé doit acquitter la facture sur réception et avant la deuxième insertion: sinon, cette dernière insertion est suspendue, sans autre avis et sans préjudice des droits de l'Éditeur officiel du Québec, qui rembourse, chaque fois, s'il y a lieu, toute somme versée en plus.6.L'abonnement, la vente de documents, etc.sont strictement payables à l'avance.7.Tout paiement doit être fait par chèque ou mandat à l'ordre du ministre des finances du Québec.S.La Gazelle officielle du Québec (Partie 1) est publiée le samedi matin de chaque semaine: mais l'ultime délai pour la réception des avis, documents ou annonces, expire à midi, le mardi, à moins que ce jour ne soit un jour férié.Dans ce cas.l'ultime délai expire à midi, le lundi.Les avis, documents ou annonces reçus en retard sont publiés dans une édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec a le droit de retarder la publication de certains documents, à cause de leur longueur ou pour des raisons d'ordre administratif.9.Toute demande d'annulation ou lout paiement sont soumis aux dispositions de l'article 7.10.Si une erreur typographique se glisse dans une première insertion, les intéressés sont priés d'en aviser l'Éditeur officiel du Québec, avant la seconde insertion et ce.afin d'éviter de part et d'autre des frais onéreux de reprise.2.The Québec Officiai Gazette is published in two parts, and is bilingual in compliance with the Regulation respecting the Québec Official Gazette.Part 1 is issued every Saturday morning and contains nolices of a general character, proclamations, certain Orders in Council and various classes of other statutory notices.3.To avoid delayed publication, advertisers should supply their copy in both official languages simultaneously, whenever possible.The Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.4.The number of insertions must be specified.5.Advertisements are payable in advance at the rates set forth below, except where they are to be published more than once.In such case, remittance must be made Upon receipt of the invoice and before the second insertion, otherwise the second insertion will be automatically cancelled without prejudice to the Québec Official Publisher.Any overpayment will be refunded.6.Fees for subscription, sale of documents and the like are payable in advance.7.Remittance must be made by cheque or money order payable to the Minister of Finance of Québec.8.The Quebec Official Gazette (Part 1) is published every Saturday morning.All notices, documents or advertisements must reach the Québec Official Publisher not later than Tuesday noon: if Tuesday is a holiday, the deadline is Monday noon.Material not delivered in time will appear in a subsequent edition.Moreover, the Québec Official Publisher reserves the right to defer publication of certain documents because of their length or for administrative reasons.9.Any request for cancellation or refund is subject to the provisions of Rule 7.10.If a typographical error occurs in the first insertion, interested parties are requested to notify the Québec Official Publisher before the second insertion, in order to avoid costly duplication.L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ, Québec Official Publisher 1636 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22.1975, Vol.107, No.8 TARIF DES ANNONCES, ABONNEMENTS, etc.Première insertion: 40 cents la ligne agate, pour chaque version, (14 lignes au pouce, soit 220 lignes par page, pour les deux versions).Insertions subséquentes: 20 cents la ligne agate pour chaque version.La matière tabulaire (listes de noms, de chiffres, etc.) est comptée double.Traduction: $5 des 100 mots.Exemplaire séparé: SI chacun.Feuilles volantes: $3 la douzaine.Périodes d'abonnement (Partie 1): du 1er janvier au 31 décembre, 820; du 1er avril au 31 décembre, $15 et du 1er juillet au 31 décembre, $10.N.B.\u2014 Les chiffres placés au bas des avis ont la signification suivante: Le premier nombre réfère à notre numéro de facture; le deuxième à celui de l'édition de la Gazelle pour la première insertion; le troisième à celui du nombre d'insertions, et la lettre « o » signifie que la matière n'est ni de notre composition ni de notre traduction.Les avis publiés une seule fois ne sont suivis que de notre numéro de facture.L'Editeur officiel du Québec, Chari.f.s-Hrnri Dubê.Cité Parlementaire.Québec.25 octobre 1972.ADVERTISING RATES, SUBSCRIPTION, etc.First insertion: 40 cents per agate line, for each version (14 lines to the inch, or 220 lines per page, for both versions).Subsequent insertions: 20 cents per agate line, for each version.Tabular material (list of names, figures, etc.) at double rate.Translation: $5 per 100 words.Single copies: $1 each.Slips: 83 per dozen.Subscription periods (Part 1): from 1 January to 31 December, $20, from 1 April to 31 December, $15 and from 1 July to 31 December, $10.N.B.\u2014 Key to figures below notices: The first figure is our invoice number; the second, that of the edition of the Gazette carrying the first insertion; the third, the number of insertions.The letter \"o\" indicates that the text was not composed or translated by the Québec Official Publisher personnel.Notices published only once are followed by our invoice number.Charles-Henri Dubé, Québec Official Publisher.Parliament Buildings.Québec.October 25.1972.Pour toute demande de renseignements concernant publication d'avis, tirés-à-part ou abonnement à la Gazelle officielle du Québec, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Téléphone: (418) 643-5195 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec.Cité Parlcmcntaire, Québec G1R 4V7.P.Q.For information concerning the publication of notices, off-prints or subscription rates to the Québec Official Gazette, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazette Telephone: (418) 643-5195 All correspondence should be sent to the office of the Quebec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec G1R 4Y7, P.Q.Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Postage paid-in-cash \u2014 Third class matter (permit No.107) GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1637 AVIS JURIDIQUES\t\tJURIDICAL NOTICES\t\t\t Compagnies \u2014 Loi des\t\tCompanies Act\t\t\t Lettres patentes (lre partie)\tLetters Patent (Part I)\t\t\t\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, il a accordé des iettres patentes constituant en corporation:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part I of the Companies Act, he has granted letters patent incorporating:\t\t\t\t Nom / Name\t\tIncorporation Siège social / Head Office Date\t\t\t ACCOMMODATION EXPRESS QUATRE BOURGEOIS INC.1360-9136\t\t3225, de Galais, Sainte-Foy.\t18\t12\t74 AGENCE DE VOYAGES ROCK FOREST INC____\t\tPlaza Rock Forest, Rock Forest.\t11\t11\t74 et sa version anglaise ROCK FOREST TRAVEL AGENCY INC.1360-2008\t\t\t\t\t \t\t957, avenue Royale, Beauport\t29\t01\t76 1361-4904\t\t\t\t\t LES AMENAGEMENTS PANET-PLESSIS INC.and its English version PANET-PLESSIS DEVELOPMENTS INC.1361-2114\t\t5810, Côte Saint-Luc, suite 36, Montréal.\t10\t01\t75 AMEUBLEMENTS IDEALS DE ST-HILAIRE INC.1370-4226\t\t406, boulevard Laurier, Saint-Hilaire.\t18\t11\t74 APPROVISIONNEMENT RENE PANKALLA LTEE and its English version RENE PANKALLA CATERING LTD.1370-3624\t\t3450, rue Drummond, suite 1915.Montréal.\t12\t11\t71 ASSOCIATION DES CADRES MOYENS DU CHEMIN DE FER DU QUEBEC et sa version anglaise RAILWAY MIDDLE MANAGEMENT ASSOCIATION OF QUEBEC 1369-8865\t\t1669, Ringuet, app.212, Saint-Bruno-de-Montarville.\t29\t11\t74 LES ASSURANCES GAGNON, AUGUSTIN, LAPLANTE ASSOCIES INC.1361-1199\tA\t695, rue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe\t08\t01\t75 1360-8377\t\t11.341, Place Salk, Montréal-Nord.\t16\t12\t74 1370-8722\t\t3802, rue Monselet, Montréal-Nord.\t03\t01\t75 ATELIER ORIENTAL ANTIQUES LEOPOLD & COTE INC.and its English version THE ORIENTAL LOFT ANTIQUES LEOPOLD * COTE INC.1370-3764\t\t\t13\t11\t74 et sa version anglaise ST-LUC AUTO (1974) INC.1361-0415\t\t174, boulevard Saint-Luc, Asbestos.\t30\t12\t74 AUTOBUS ROGER VILLENEUVE INC.1370-8847\t\t12480, boulevard Gouin ouest, Pierre-fonds.\t06\t01\t75 1638 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Nom / Name BAR SALON ALINE, GRANBY INC.1360-7692 BAR-SALON SALLE A MANGER VAL-MARTIN INC.1359-6374 JEAN-CHARLES BEDARD INC.1370-2733 BELMA INC.1360-7791 BIJOUTERIE DU NORD INC.1361-0571 ROBERT BILODEAU INC.1360-7817 BOIS EXPRESS LTEE.et sa version anglaise EXPRESS LUMBER LTD.1370-6619 BOURGAULT ET FILS INC.1370-7567 BOUSQUET ET DUCHARME INC.1360-1426 BOUTIQUE EPICURIENNE LTEE.1360-8120 LA BOUTIQUE GINI INC.1360-7577 BOUTIQUE DU SEXE DE LAVAL INC.et sa version anglaise LAVAL SEX SHOP INC.1361-0696 LE CAFE-RESTAURANT JACQUES BLAIS INC.1360-5464 CAMPING PLEIN AIR DES LAURENTIDES INC.1355-7400 AURELE CARON INC.1361-3914 LES CARPETTES DU SAGUENAY INC.1360-9649 CENTRE D'APPAREILS MENAGERS SHERBROOKE INC.1360-9599 CENTRE DE L'ASPIRATEUR SAINT-JEAN INC.1370-8615 CHADOLAUX INC.1360-9755 CHA-MAL INC.1360-9763 CIMENTERIE BEAUDOIN INC.1360-9532 CLINIQUE MEDICALE ST-VALLIER INC.1361-2650 LE CLUB AERONAUTIQUE DOYON DE ST-VICTOR DE BEAUCE INC.1360-9623 Incorporation Siège social / Head Office Date 800, rue Principale, Granby.11 12 74 Val-Morin.Il 10 74 4003, boulevard Décarie, Montréal.04 11 74 1305.des Patriotes, Ancienne-Lorette.12 12 74 L'Annonciation.03 01 75 89, rue Principale nord, Windsor.12 12 74 9240, boulevard Viau, Saint-Léonard.11 12 74 406, Principale, L'Avenir.17 12 74 4087, boulevard Laurier, Douville .26 11 74 Dollard-des-Ormeaux.13 12 74 Rue Saint-Philippe, Clermont.11 12 74 75, boulevard Labelle, Laval.03 01 75 717 boulevard St-Joseph, Hull.02 12 74 640, George-Muir, Notre-Dame-des- 09 01 75 Laurentides.Saint-Clément.23 01 76 370.rue Du Havre, Chicoutimi 20 12 74 1376, King ouest, Sherbrooke.23 12 74 7, rue Alcide-Côté, Saint-Jean.30 12 74 8550, rue Georges, Lasal le.20 12 74 99, du Chalet, Saint-Pierre.20 12 74 Pont-Rouge.23 12 74 6915, rue St-Denis, Montréal.15 01 75 Saint-Victor, Beauce.23 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1975, 107' année, n° 8 1639 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date COMPAGNIE DE TAPIS ORIENTAUX ARABAT LTEE.and its English version ARABAT ORIENTAL RUG COMPANY LTD.1360-9771 CONSEILLERS EN GESTION PLIMREC LTEE.and English version PLIMREC MANAGEMENT CONSULTANTS LTD.1360-9029 CONSEL INC.1360-5175 LES CONSTRUCTIONS A.L.M.INC.et sa version anglaise A.L.M.CONSTRUCTIONS INC.1370-9217 CONSTRUCTION B.D.G.INC.1359-4924 LES CONSTRUCTIONS B.O.S.LTEE.and its English version B.O.S.CONSTRUCTION LTD.1361-0126 CONSTRUCTION DOMINO LTEE.et sa version anglaise DOMINO CONSTRUCTION LTD.1361-4490 CONSTRUCTION DORA LTEE.and its English version DORA CONSTRUCTION LTD.1370-6478 LES CONSTRUCTIONS EMMANUEL LTEE.et sa version anglaise EMMANUEL CONSTRUCTION LTD.1370-6874 CONSTRUCTION FRAPIVIAN LTEE.et sa version anglaise FRAPIVIAN CONSTRUCTION LTD.1370-7500 CONSTRUCTION JOBELIN INC.1370-7054 CONSTRUCTION PREFATELINC.et sa version anglaise PREFATEL CONSTRUCTION INC.1370-9654 CONSTRUCTION RICHARD DAIGLE INC.1370-7104 CONSTRUCTION DU VALET INC.et sa version anglaise DU VALET CONSTRUCTION INC.1359-0575 CORPORATION AGRO-FORESTIERE TRANSCONTINENTALE INC.1360-1554 CORPORATION M.B.R.and its English version M.B.R.CORPORATION 1356-9306 Monréal 5695, boulevard des Grandes-Prairies, Montréal.20 12 74 18 12 74 67, Côte du Passage, Levis.29 11 74 Saint^Laurent.10 01 75 8878, boulevard St-Michel, suite 12, 08 11 74 Montréal.Saint-Sauveur.27 12 74 Laval.28 01 75 3305, boulevard Losch, Saint-Hubert.10 12 74 Dollard-des-Ormeaux.13 12 74 Montréal.17 12 74 Sept-Ues.13 12 74 Saint-Bruno.14 01 75 168, rue de Normandie, Longueuil.13 12 74 59, rue Turgeon, Sainte-Thérèse.17 09 74 Saint-Elzéar.07 11 74 70, rue Molière, Montréal.03 06 74 1640 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 22.7375, Vol.107, No.8 Nom / Name COUTEAUX CONTINENTAL INC.et sa version anglaise CONTINENTAL CUTTING TOOLS INC.1370-3194 JACQUES CREPEAU ci ASSOCIES INC.1360-9151 DECOR NAD INC.1360-2768 DEMOLITION MARCEL FORTIN INC.1361-0878 DENACINC.1370-8508 LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES LEO LAROCHE INC.1370-4820 DISTRIBUTION GINA RIVTERE-DU-LOUP INC.1361-1025 DISTRIBUTION ITALIE INC.1360-7478 DRAPERIES C.LAROCHE INC.1370-7211 DUBE & BERGERON INC.1360-0440 ECOLE DE CONDUITE DE L'ESTRIE INC.1361-3732 ECOLE DE CONDUITE MONT-ROYAL INC.et sa version anglaise MOUNT-ROYAL DRIVING SCHOOL INC.1370-7641 ECONOPAC INC.1370-8573 EDITIONS LE CITOYEN DE MONTREAL-NORD INC.1370-6098 LES ENTREPRISES AGRICOLES G.P.INC.1361-0175 LES ENTREPRISES B.L.C.LTEE.1361-1470 LES ENTREPRISES B.LEBLANC INC.1361-0142 ENTREPRISES DE CHAUSSURES PANDA INC.et sa version anglaise PANDA SHOE ENTERPRISES INC.1358-3380 LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE DELSON INC.1360-2883 ENTREPRISE DE FOURRURES GERARD LAVOIE INC.1361-4482 LES ENTREPRISES G.ET F.LAMARRE INC.1359-3900 LES ENTREPRISES G.FOURNIER INC.1359-8248 LES ENTREPRISES J.-A.PEPIN & FILS INC.1360-6661 Incorporation Siège social / Head Office Date 3171, rue Sainte-Catherine est.08 11 74 Montréal 5775, Fadette, Saint-Léonard.18 12 74 309, rue Principale, Cowansville.14 11 74 235, Léonard, Québec.06 01 75 Verdun.17 01 75 63, rue Lapointe.Longueuil.25 11 74 Rivière-du-Loup.18 12 74 Matane.11 12 74 8460, 13e Avenue, Saint-Michel.16 12 74 200, rue Saint-Jacques ouest, 01 11 74 suite 401, Montréal Sherbrooke.22 01 75 118, Mont-Royal est, Montréal.18 12 74 Rue Cormier, Drummondville.30 12 74 Montréal-Nord.06 12 74 Beloeil.27 12 74 Pointe-Gatineau.09 01 75 534, rue Frontenac.Longueuil.27 12 74 3552, Hyacinthe, Fabreville, 07 08 74 Laval Delson.15 11 74 Sherbrooke.27 01 75 1244, Fénélon, Sainte-Foy.07 11 74 Sept-Iles.21 10 74 106, avenue Gauvin, Vanier.06 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975.107' année, n° 8 1641 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date LES ENTREPRISES J.M.BOUDREAU INC.1360-9714 ENTREPRISES M.D.CHICOUTIMI INC.1360-6264 LES ENTREPRISES MAURICE & DENIS INC.1359-8230 LES ENTREPRISES MERYNIC INC.1360-8443 LES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARCEL BOIVIN INC.1361-1769 EQUIPEMENT P.C.R.INC.1361-2080 FERPAC LTEE.et sa version anglaise FERPAC LTD.1360-6850 FERRAILLE ET DEMOLITION RAICEK INC.and its English version RAICEK'S SCRAP AND DEMOLITION INC.1370-8151 Carleton.27 01 75 766.rue Aima.Chicoutimi.05 12 74 48.rue Jauffret, Chicoutimi.21 10 74 Saint-Georges-Ouest.16 12 74 Val-Bélair.14 01 76 Val-d'Or.10 01 75 7645, 7e Rue, Montréal.09 12 74 Montréal.03 12 74 FORMAGEST LTEE.1360-5126 LES FORMES P.S.T.INC.1370-3178 658, rue Ste-Angèle, Trois-Rivières GARAGE DIESEL COTE NORD INC.1360-2677 GARAGE TURBIDE & LABRIE INC.1360-8492 GARAGE YERGEAU & FRERES INC.1360-6314 GAUTHIER ET PILOTE INC.1359-0559 28 05 74 08 11 74 Centre Industriel, Hauterive.14 11 74 Gagnon.24 01 75 05 12 74 Chicoutimi.10 09 74 16 12 74 370, rue Saint-Michel.Saint-Paul-l'Ermite.Boulevard Saint-Joseph, Saint-Nicéphore.GESTION HALNIS LTEE.630, boulevard Dorchester ouest, and its English version Montréal.HALNIS MANAGEMENT LTD.1370-7377 GESTION JULUC LTEE.and its English version JULUC MANAGEMENT LTD.1370-7443 630, boulevard Dorchester ouest, 22e plancher, Montréal.16 12 74 984, Marie-Victorin, Saint-Nicolas.GESTION NORMANDE INC.1360-5894 GESTION PAMALACA LTEE.630.boulevard Dorchester ouest, and its English version Montréal.PAMALACA MANAGEMENT LTD.1370-7351 GESTION THERLAW LTEE.630, boulevard Dorchester ouest and its English version Montréal.THERLAW MANAGEMENT LTD.1370-7385 03 16 12 74 12 74 16 12 74 ARTHUR GIRARD & FILS LTEE.1361-2932 1933, rue Beaugrand, Montréal.17 01 75 1642 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February S3, 1975, Vol.107, No.8 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date JACQUES ET YVAN GIROUX, INC.1361-4193 GOBEIL & POTVIN INC.1361-0779 GRAPHIQUES CANA INC.et sa version anglaise CANA GRAPHICS INC.1371-2070 PIERRE GREENDALE INC.1370-8797 GERARD GUERETTE LIMITEE.1361-2809 GUSKAR LTEE.and its English version GUSKAR LTD.1370-9522 LES HOTELLERIES M.C.P.INC.1360-9565 LES IMMEUBLES ATHENES INC.and its English version ATHENS REALTIES INC.1370-2808 IMMEUBLES ELGON LTEE.and its English version ELGON REALTIES LTD.1370-6411 IMMEUBLES G.D.S.INC.1361-0035 LES IMMEUBLES ROUSSEL INC.1361-1124 IMMEUBLES SOANIM INC.1361-0506 LES IMPORTATIONS CIOT LTEE.and its English version CIOT IMPORTS LTD.1370-6627 LES IMPORTATIONS DE TUILES D.P.F.INC.et sa version anglaise D.P.F.TILES IMPORTING INC.1370-3376 IMPRIMERIE J.-J.NANTEL INC.et sa version anglaise J.-J.NANTEL PRINTING INC.1370-6379 LES INVESTISSEMENTS ADAMS INC.1370-6049 LES INVESTISSEMENTS FOSCO INC.and its English version FOSCO INVESTMENTS INC.1370-8326 JANFEL LTEE____.et sa version anglaise JANFEL LTD.1370-8532 JARDINS BAIE-JOLIE INC.1360-5472 158, rue Saint-Albert, Sainte-Thérèse-de-Lisieux Jonquière.525, rue Hodge, Saint-Laurent.Saint-Jean.825, Perrier, Brassard.1, Place Ville-Marie, suite 1734, Montréal.151, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts 7750, rue Birnam, Montréal.1, Place Ville-Marie, suite 3636, Montréal.48, rue Parent ouest, Port-Cartier.Rivière-du-Loup.Route 8, Masson.24 01 75 .06 01 75 .03 02 75 .03 01 75 16 01 75 13 01 75 23 12 74 .05 11 74 10 12 74 .27 12 74 .29 10 74 9225, boulevard Saint-Laurent, Montréal.6466, boulevard Saint-Laurent, Montréal.7535, boulevard Taschereau, Brossard.1303, avenue Greene, Westmount.Montréal.03 01 75 11 12 74 12 11 74 09 12 74 05 12 74 27 12 74 4837, avenue Vézina, Montréal.30 12 74 540, Baie-Jolie, Pointe-du-Lac.02 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.' février 1975, 107' année, n° 8 1643 Incorporation Siège social / Head Office Date Montréal.18 09 74 825, Grand-Boulevard, Saint-Luc.06 01 75 Saint-Basile-le-Grand.27 11 74 249, Place Colbert, Boisbriand.10 01 75 2182, rue Sainte-Catherine ouest, 04 12 74 Montréal.Rivière-au-Renard, Gaspé.24 10 74 Montréal.11 10 74 Montréal.19 12 74 L'Annonciation.20 12 74 1380, rue Barré, Montréal.29 01 75 3e rang, Sainte-Cécile-de-Milton.03 12 74 484, Mercure, Saint-Jovite.07 01 75 350, boulevard Charest est, Québec.26 11 74 1488, Gouin est, Montréal.06 01 75 Longueuil.23 01 75 750, boulevard Labelle, suite 106.15 01 75 Chomedey, Laval.415, rue Denison ouest, Granby.27 11 74 4272, rue Dollard, Lac-Mégantic.12 12 74 805, Scott ouest, Aima.26 12 74 LaSalle.13 12 74 Nom / Name JARDIN MONTREAL INC.and its English version MONTREAL GARDEN INC.1369-6935 LUC LAGUEINC.1361-0845 LARECO LTEE.1360-4566 DANIEL LEFEBVRE INC.1370-9324 LIBRAIRIE RENOUF LIMITEE.1360-6207 LINDANNO INC.1359-9899 LITHOCHROME (1974) INC.1370-0125 LOCATION CAPITOL INC.and its English version CAPITOL LEASING INC.1360-9268 LOCATION GALOU INC.1370-8003 LES LOCATIONS MURRAY HILL LTEE.and its English version MURRAY HILL LEASING LTD.1361-4888 MACHINERIE JACQUES COUTURE INC.1370-5777 MAISONS JACQUES LABELLE LTEE.1370-8987 LA MAISON DU MEUBLE ALLEMAND M.I.T.INC.et sa version anglaise M.I.T.HOUSE OF GERMAN FURNITURE INC.1360-5142 MALOPAINC.1361-0803 MANDRECO LTEE.1361-3831 MANUFACTURE BEN INC.1370-9787 GEORGES MARCHAND, DEPANNEUR INC.1360-4723 MARCHE DE FRUITS ET LEGUMES J.LEBLANC INC.1360-7858 MATERIAUX ALMA INC.et sa version anglaise ALMA MATERIALS INC.1360-4434 MATERIAUX DE CONSTRUCTION R.GENEST (LASALLL) LTEE et sa version anglaise R.GENEST LUMBER (LASALLE) LTD.1370-7088 1644 QUÉBEC OFFICIAI GAZETTE, February 33, 1975, Vol.107, No.8 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date MATHECRIT INC.1360-5084 METAL M.DAIGNAULT INC.1370-5629 LES MEUBLES NOUVEAU QUEBEC INC.et sa version anglaise NEW QUEBEC FURNITURE INC.1360-5951 Y.MEUNIER & FRERES INC.1370-5892 MOBILIER J.A.E.LTEE____ and its English version J.A.E.FURNITURE LTD.1370-7708 MODE EXPRESS INC.1359-7208 MODE PRINCE CONTI INC.1360-7338 MOTEUR CH.INCORPOREE 1360-8872 MOULAGES ET MATRICES ALPLAX INC.and its English version ALPLAX MOULD AND DIE INC.1370-9142 MOUREAUX, HAUSPY, JEFFREY & ASSOCIES INC.1370-7138 ALBERT NAULT ET FILS INC.1360-9236 GERARD NOLIN (1975) LTEE.1361-4912 PAGETECH INC.1360-9938 LE8 PANNEAUX DE REVETEMENT V.D.INC.et sa version anglaise V.D.DRY WALLS INC.1370-9043 PAPIER DE REBUT ST-LEONARD INC.et sa version anglaise ST.LEONARD WASTE PAPER INC.1371-1016 PARONIEL INC.1370-8300 26, Marleau, Mercier.28 7480, 19e Avenue, Montréal.03 Gagnon.04 Saint-Jean-Baptiste.04 4845, avenue Roslyn, Montréal.18 1184, rue St-Jean, Québec.17 6415.rue St-Hubert, Montréal.11 Route numéro 49 nord.23 Plessisville.10014.boulevard Saint-Vital, Montréal-Nord.1808, rue Sherbrooke ouest, Montréal.OS 18 64, Principale Nord, Maniwaki.19 Saint-Jean-Chrysostome.29 200, rue Saint-Jean-Baptiste, 23 Granby Montréal.08 11 74 12 74 12 74 12 74 12 74 10 74 12 74 01 75 01 76 12 74 12 74 01 76 12 74 01 76 8610, boulevard Langelier, Saint-Léonard.27 01 76 Montréal.27 {oA,!I,S.SJRIE PETIT PARIS INC.26>.rue Bernard ouest, Montréal.18 LES PAVAGES DE VARENNES INC.1370-6628 Varennes.10 PHOTO FAUVEAINC.390, Saint-Vallier est, Québec.23 et sa version anglaise FAUVEA PHOTO INC.1361-3880 12 74 12 74 12 74 01 76 PHOTO PROCILAB INC.1674.avenue Van-Horne 1370-8292 Outremont.27 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1645 Nom / Name Siège «oci.il / Head Office Incorporation Date PIECES D'AUTOS LE PORTAGE LTEE.et sa version anglaise LE PORTAGE AUTO PARTS LTD.1370-8771 PLACEMENTS RENAL INC.1371-0090 PLANIF.INC.1361-0720 LES PLASTIQUES H.L.INC.et sa version anglaise H.L.PLASTICS INC.1359-1854 PLOMBERIE B.M.S.INC.1361-3369 POISSONNERIE BOISVERT INC.1360-9540 PROBITEC INC.1361-3997 PRODUCTELINC.1370-8383 PRODUITS FORESTIERS COLONIAL INC.et sa version anglaise COLONIAL LUMBER INC.1370-6791 PRODUITS MUNICIPAUX B.C.M.LTEE.1360-7999 PROPRIETES INTERNATIONALES COIN DE SOLEIL INC.and its English version SUN SPOTS INTERNATIONAL PROPERTIES INC.1360-8310 LES PROVISIONS L.V.D.INC.1361-1736 HENRI RADERMAKER & FILS INC.1370-8623 REBUTS 4 METAUX CASTOR LTEE.et sa version anglaise BEAVER METAL Ac SCRAP LTD.1358-9049 LES RECOUVREMENTS BECANCOUR INC.1360-9631 RESTAURANT AU COQ NORMAND INC.1370-8698 RESTAURANT AUX DEUX COMMERES INC.1360-8914 REVETEMENTS LES AMIS INC.1370-4796 ARTHUR ROULEAU & FILS, INC.1361-1611 MARCEL M.ROY INC.1370-6635 ROYAUME DU SILENCIEUX DU SAGUENAY, INC.1361-2171 710, rue Marsolais, L'Assomption.03 01 75 8436, rue Lévrard, Saint-Léonard.11,114, avenue Royale.Beaupré.Montréal.179, rue Lafontaine, Sept-Iles.Sherbrooke.,.35.rue de Varennes, local 7, Boucherville.Montréal.856.boulevard Labelle, Blainville.1.rue Néron, Chicoutimi.2015.rue Peel, suite 200.Montréal.1300, rue Fort.Montréal.Saint*-Véronique-de-Turgeon.1928, rang Saint-Ange, Sainte-Foy.1005, Nicolas-Perrot, Bécancour.1768, rue Dollard, LaSalle.Montréal.267, rang Haut Saint-Amable, Saint-Barnabé-Sud.399, 3c Rue.Québec.Saint- Liboire., 144, rue Sainte-Famille, Kénogami.17 01 76 06 01 75 17 07 74 20 01 76 23 12 74 23 01 76 27 12 74 12 12 74 13 12 74 16 12 74 14 01 76 30 12 74 29 08 74 23 12 74 20 01 76 18 12 74 26 11 74 08 01 75 11 12 74 10 01 75 1646 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, February SS.1975, Vol.107, No.8 Nom / Name SALON DE BARBIER RIVIERA (SAINT-LAURENT) INC.1370-8078 SATELINC.1360-4970 LES SERVICES DENTAIRES P.E.N.J.INC.and its English version P.E.N.J.DENTAL SERVICES INC.1360-3048 SERVICE D'EMBELLISSEMENT F.M.QUEBEC INC.1361-0241 LES SERVICES D'ENTRETIEN BORDEAUX LTEE.and its English version BORDEAUX MAINTENANCE SERVICES LTD.1370-4762 SERVICES D'ENTRETIEN CHALEC LTEE.1371-0595 SERVICES PETROLIERS DU NORD-OUEST INC.,.et sa version anglaise NORTH-WEST PETROLEUM SERVICES INC.1370-9373 SERVICES DE PUBLICITE ET DE PROMOTION M.J.INC.and its English version M.J.PUBLICITY AND PROMOTION SERVICES INC.1307-5769 SOCIETE D'ADMINISTRATION NEHVA INC.1370-2915 LA SOCIETE D'EDITION JEAN-FRANÇOIS LTEE.1371-0785 SOCIETE DE GESTION D.G.B.INC.1370-9175 LA SOCIETE JACQUES DEGEAY LTEE.1370-6510 SOUDURES INDUSTRIELLES DU RICHELIEU METROPOLITAIN INC.et sa version anglaise METROPOLITAN RICHELIEU INDUSTRIAL WELDING INC.1360-4681 SUPER MARCHE HALLE INC.et sa version anglaise HALLE SUPER MARKET INC.1370-7161 TABAGIE J.M.R.TREMBLAY INC.1370-8052 TABAGIE JACQUES & MAURICE TREMBLAY INC.1370-8060 TANET INC.1360-8765 LES TERRAZZOS GAUDREAULT LIMITEE.1361-4599 LES TEXTILES & DRAPERIES JACK INC.and its English version JACK'S TEXTILES ci DRAPERIES INC.1361-2940 Incorporation Siège social / Head Office Date Saint-Laurent.20 12 74 42 est, 6e Rue, Rimouski.23 01 75 23, Valois Bay, Pointe-Claire.18 11 74 Québec.30 12 74 Greenfield Park.25 11 74 7440, Décarie, Montréal.23 01 75 Malartic.10 01 75 5016, boulevard Saint-Laurent, 03 12 74 Montréal 3454, Saint-Denis, Montréal.06 11 74 Montréal.23 01 75 201, Corot Rive, suite 1412, Ile-des- 09 01 75 Soeurs, Verdun.157, Saint-Joseph, L'Assomption.10 12 74 Contrecoeur.27 11 74 5021, rue Perras, Montréal-Nord.16 12 74 880, rue Thomas-Chapais, Duvernay, 20 12 74 Laval.880, rue Thomas-Chapais, Duvernay, 20 12 74 Laval.2010.Bruxelles, Montréal.16 12 74 Chicoutimi.27 01 75 4223, rue Ontario est, Montréal.17 oi 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975.107' année.n° 8 1647 Nom / Name Incorporation Siège social / Head Office Date 9858, rue Meilleur.Montréal.26 11 74 1245, rue Galt est, Sherbrooke.11 12 74 30, rue Prévost, Saint-Rémi.23 12 74 600, boulevard Sauvé, Laval-Ouest, 30 12 74 Laval.3872, Allen, Verdun.18 12 74 125.route 33.Saint-Roch-de- 28 02 74 l'Achigan.Rouyn.30 10 74 9475.rue Meilleur, chambre 501, 18 10 74 Montréal.88, rue Parissi, Laval-des-Rapides.17 12 74 6335, rue Beauvais, Saint-Léonard____ 08 11 74 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.LES TISSUS CHAMBORD INC.and its English version CHAMBORD FABRICS INC.1360-4459 TOYOTA DE SHERBROOKE-EST INC.et sa version anglaise SHERBROOKE-EST TOYOTA INC.1360-7676 TRANSPORT BOYER & FILS LTEE.1370-8128 TRANSPORT G.SUREAU INC.et sa version anglaise G.SUREAU TRANSPORT INC.1370-8631 TRANSPORT METRO B.B.INC.1370-7724 TREMBLAY & DESROCHES LIMITEE.746550 TONY VERRET ET ASSOCIES INC.1360-0093 VETEMENTS L'HOMME ELEGANT INC.1370-0844 VETEMENTS ZARAA LTEE.1370-7542 G.ZOCCALI INC.1370-3228 Le directeur du service des compagnies, 60016-o Pierre Desjardins.60016-o Lettres patentes (3e partie) Letters Patent (Part III) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis, qu'en vertu de la troisième partie Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to Part III de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes of the Companies Act, he has granted letters patent incor- constituant en corporation: porating: Nom / A'ame Siège social / Head Office Incorporation Date AMICALE JUIVE FRANCOPHONE DE L'AGE D'OR.1370-7195 LES ARQUEBUSIERS DU CANADA INC.et sa version anglaise STRAIGHT SHOOTERS OF CANADA INC.746357 ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET LOCATAIRES DE PLACE RICHMOND (A.C.L.P.R.) INC.1360-5613 ASSOCIATION DES FABRICANTS DE LENTILLES OPHTALMIQUES A.F.L.O.1370-5934 5497A, avenue Victoria, chambre 104, 16 12 74 Montréal.221.Brochu, Sept-Iles.07 02 74 New Richmond.17 12 74 5120, Courtrai, Montréal.04 12 74 1648 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Nom / Name ASSOCIATION DES POMPIERS DE NEW-RICHMOND.1355-6378 ASSOCIATION SPORTIVE ROYAUX ANJOU INC.1360-4731 LE CARNAVAL DE L'ESTRIE INC.1360-6090 CENTRE DE PLEIN AIR MONT CHAUDRON INC.1360-3055 CENTRE DE RENSEIGNEMENTS ET D'INFORMATION DUBERGER 1360-4996 CENTRE VIDEO LOTBINIERE INC.1360-7726 CLUB DE L'AGE D'OR DE ST-LEON-DE-STANDON INC.1360-1208 CLUB DE LA JEUNESSE SLOVENE SLOMSEK.et sa version anglaise SLOVENIAN YOUTH CLUB SLOMSEK 1370-3162 CLUB DE MOTO LES REVOLTES INC.1360-9821 LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BEACON8FIELD INC.and its English version BEACONSFIELD FIGURE SKATING CLUB INC.1370-9332 LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE GREENFIELD PARK INC.and its English version THE GREENFIELD PARK FIGURE SKATING CLUB INC.1361-3294 CLUB QUATRE PAR QUATRE SAGUENAY INC.1360-2024 LE CLUB SOCIAL DE SAINT-ALBERT-LE-GRAND, QUEBEC.1358-7845 CLUB SPORTIF ST.SISTO INC.1370-8334 FESTIVAL DE LA PATATE DE ST-AMBROISE INC.1360-4707 FESTIVAL PROVINCIAL DE LA MOTO-NEIGE INC.1360-7387 HOCKEY MINEUR DE LA RIVE SUD INC.1361-4110 LA LIGUE DE TAXIS DE GASPE INC.1360-3287 LE MOUVEMENT SOCIO-CULTUREL DE LA TUQUE INC.1361-0191 LES PRODUCTIONS LA NOIX DE COCO.1370-5843 RESEAU HERTZIEN DRUMMOND INC.1360-7916 Incorporation Siège social / Head Office Date New-Richmond.05 04 74 8040, rue Dade, Anjou.27 11 74 Bromont.04 12 74 76, Perreault est, Rouyn.18 11 74 67, boulevard Central Nord, Québec.28 11 74 Saint-Agapit.12 12 74 Saint-Léon-de-Standon.06 11 74 1695, Godin, Saint-Hubert.08 11 74 132, rang Saint-Pierre ouest, 23 12 74 Chicoutimi.Beaconsfield.10 01 76 156, boulevard Churchill, 20 01 76 Greenfield Park.Chicoutimi.11 11 74 3065, 2e Avenue, Québec.26 08 74 11413, rue Garon, Montréal-Nord____ 27 12 74 78, du Couvent, Saint-Ambroise.27 11 74 Saint-Gabriel, Joliette.11 12 74 Nicolet.24 01 76 Gaspé.06 01 75 625, rue Saint-Eugène, La Tuque.30 12 74 825, avenue Bloomfield, Outremont.03 01 75 177, rue Lapointe, Drummondville .12 12 74 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1649 Nom / Name Siège social / Head Office Incorporation Date SERVICE DE DEPANNAGE A DOMICILE DE L'ABITIBI- TEMISCAMINGUE 1357-9396 LA TROUPE ZOOGEP INC.1360-2818 ZONE DE SKI DES CANTONS DE L'EST.1370-8896 Rouyn.15 08 74 Granby.18 12 74 Foster.06 01 75 60016-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.60016-0 Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Lettres patentes supplémentaires Supplementary letters patent Le ministre des institutions financières, compagnies et cooperatives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a accordé des lettres patentes supplémentaires a: The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has granted supplementary letters patent to: Nom / Name Incorporation L.P.S./ S.L.P.Date Date Modifications Changes ARMOIRES DE CUISINE BERNIER INC.et sa version anglaise BERNIER KITCHEN CABINETS INC.1159-5071 AUTOMOBILE BELLEVOIX INC.et sa version anglaise BELLEVOIX AUTOMOBILE INC.716798 LES BOUTIQUES RODIER (QUEBEC) INC.1360-0747 19 07 65 10 12 71 04 11 74 BRASSERIE LE CARREFOUR DE LA JETEE 04 07 74 INC.1368-8882 CENTRE AGRICOLE HARNOIS INC.09 01 73 736044 CORPORATION PROVOST LTEE.17 03 69 et sa version anglaise PROVOST CORPORATION LTD.773-1969 DOMAINE LE FAMILIAL INC.01 12 72 726641 DROUIN AUTOMOBILES LTEE.18 07 61 1174-6856 LES ENTREPRISES BERNARD SHAPIRO 13 11 73 INC.BERNARD SHAPIRO ENTERPRISES INC.738713 LES INDUSTRIES A.N.MILLER INC.23 03 62 and its English version A.N.MILLER INDUSTRIES INC.1117-9629 21 01 75 Ancien nom / Former name: MENUISERIE MAURICE BERNIER INC.05 12 74 Ancien nom / Former name: BELLEVOIX AUTO BODY INC.08 01 75 Ancien nom / Former name: LA BOUTIQUE RODIER (QUEBEC) INC.30 12 74 Ancien nom / Former name: BRASSERIE AU VIEUX CANAL INC.18 12 74 Modifiant le capital / Altering the capital.04 07 74 Ancien nom / Former name: TRANSPORT CENTRE INC.26 11 74 Ancien nom / Former name: CAMPING LE FAMILIAL INC.30 12 74 Modifiant le capital / Altering the capital.27 11 74 Modifiant le capital / Altering the capital.30 12 74 1.Ancien nom / Former name: MILPONT CONSTRUCTION LTEE MILPONT CONSTRUCTION LTD.2.Modifiant les pouvoirs / Modifying the powers. 1650 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol J07, No.8 Incorporation L.P.S./ SX.P.Modifications Nom / Name Date Date Changes MEUNERIE MOBILE LEMAY & FRERES 16 LIMITEE 1172-0729\t10\t64\t25\t10\t74\tModifiant les pouvoirs / Modifying the powers.VALMONT NADON TRANSPORT INC.01 722294\t05\t72\t23\t12\t74\tModifiant les pouvoirs / Modifying the powers.729491\t12\t72\t09\t12\t74\tModifiant les pouvoirs / Modifying the powers.2861-66\t08\t66\t04\t12\t74\t1.Modifiant le capital / Altering the capital.2.Modifiant les pouvoirs /Modifying the powers.RELY CONSTRUCTION INC.13 2170-70\t05\t70\t24\t01\t75\t1.Modifiant les privilèges et restrictions Modifying the privileges and restrictions.2.Modifiant les dispositions des lettres patentes / Amending the provisions of the letters patent.T.L.T.(1964) LTEE.14 4542-1964\t10\t64\t04\t12\t74\tModifiant le capital / Altering the capital.TRANSPORT CENTRE INC.17 773-1969\t03\t69\t02\t07\t74\tModifiant le capital / Altering the capital.Le directeur du service des compagnies.60016-o Pierre Desjardin!\ti.\t60016-0\t\t\t\tPierre Desjardinb, Director of the Companies Service.Administrateurs (Article 84)\t\tDirectors (Section 84)\t\t\t\t Avis est donné que les compagnies et corporations dont les noms suivent ont modifié le nombre de leurs administrateurs tel qu'indiqué ci-après.\t\tNotice is hereby given that the companies and corporations whose names follow have changed the number of their directors as indicated hereinafter.\t\t\t\t Nom de la compagnie Name of company\t\tDate de constitution Dale of incorporation\t\t\t\tNombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Nouveau nombre Previous number New number ACIER PROFILE S.B.B.INC.\t\t17\t12\t73\t\t3 4 S.B.B.FORMED STEEL INC.735704\t\t\t\t\t\t \t\t01\t12\t69\t\t4 3 6753-69\t\t\t\t\t\t C P ASSOCIATES LIMITED.\t\t30\t04\t71\t\t3 6 2258-1971\t\t\t\t\t\t \t\tin\t12\t69\t\t5 4 6040-69\t\t\t\t\t\t\" * CHATELAINE ORIGINAL INC.\t\t12\t10\t62\t\t3 4 1109-8787\t\t\t\t\t\t J.A.COUSINEAU LTEE.\t\t29\t12\t56\t\t5 3 13611-65\t\t\t\t\t\t DAKEN CONSTRUCTION (MONTREAL) INC.\t\t20\t09\t7 1\t\t3 4 6 3 714977 DUMONT EXPRESS (DIVISION CITERNE) LTEE.DU MO NT EXPRESS (.TANK DIVISION) LTD.3381-65\t\t23\t07\t65\t\t GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 février 1975.107' année.«' 8 1051 Nom de la compagnie Name of company Date de constitutions Dale of incorporation Nombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Nouveau nombre Previous number New number EDMAKO INC.13 02 74 1355-9802 LES ENTREPRISES DE J.EMILE LANGLOIS LTEE.27 11 30 2206-30 FILION & COMEAU LTEE.19 12 72 726715 FONDATION CARDIOLOGIQUE SAINT-LUC.21 01 74 738962 GREENSHIELDS INCORPOREE.15 05 61 GREENSHIELDS INCORPORATED.1118-9925 HOPITAL VETERINAIRE DURAND INC .21 09 68 4314-1968 LABORATOIRE OLEON MONTREAL INC.01 08 74 1358-2580 LAGENAIS INC.17 01 73 730147 MERIT DISTRIBUTORS LTD.07 12 64 1141-7425 MEUBLES GUITO INC.15 02 74 1355-1643 MINTO CORPORATION.11 09 52 12405-52 NANKING CAFE (MONTREAL) INC.08 06 64 CAFE NANKING (MONTREAL) INC.1102-4379 O.T.J.ST-SACREMENT INC.25 05 62 11424-1962 OPTIQUE GILOT LIMITEE.12 02 72 720594 PHOTO S.R.T.INC.01 05 74 S.R.T.PHOTO INC.1368-0400 PLACE AYLMER INC.20 09 71 1218-8637 LES PLACEMENTS GIM INC.28 10 74 and its English version GIM INVESTMENTS INC.1370-1800 LES PLACEMENTS P.B.L.LTEE.02 12 74 1360-5514 PRETTY TALK FASHIONS INC.20 04 64 1115-4325 ST.MICHEL PLASTICS LTD.IS 04 73 LES PLASTIQUES ST-MICHEL LTEE.736868 SECURITE SELECT INC.05 04 74 et sa version anglaise SELECT SECURITY INC.1367-6887 3 5 .! 6 39 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 7 3 4 8 27 4 4 3 6 5 4 3 10 4 4 4 4 4 3 4 1652 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February S3,\t\t7975.Vol.107.A'o.S Nom de la compagnie Xamc of company\tDate de constitutions Date of incorporation\tNombre d'administrateurs Number of directors Ancien nombre Nouveau nombre Previous itumber New number SETON DEVELOPMENT LTD.714945\t17 09 71\t3 4 SPINO CONSTRUCTION CIE LTEE.SPIKO CONSTRUCTION CO.LTD.1117-6138\t30 06 60\t5 7 UNIVERSAL TELECOM M ( NIC A TION SYSTEMS LTD.SYSTEMES DES TELECOMMUNICATIONS UNIVERSELS LTEE.1355-0801\t18 02 74\t3 6 VITRERIE TIFFANY DU QUEBEC INC.QUEBEC TIFFANY GLAXIERY INC.738218\t21 09 73\t3 6 Le directeur du service des compagnies, 00016-O Pierre Desjardins.\t60016-0\tPierre Desjardins, Director of the Companies Service.Abandon de charte\tSurrender of Charter\t Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies, il a accepté l'abandon de la charte de:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has accepted the surrender of the charter of:\t Nom / Name\t\tIncorporation Dissolution Date Date BERUBE ET LACHANCE LTEE.282-68 BOULANGERIE PROVENCHER INC.1176-4438 LES CANOTS RADISSON LTEE .519-70 CREPAVLT AGENCIES LIMITED.AGENCES CREPAULT LIMITEE 13184-54 LE DISCOPHILE DE THETFORD LTEE.2827-65 LIONEL GOSSELIN LTEE.13280-60 LES INDUSTRIES DION INC.DION INDUSTRIES INC.1152-5177 KLEIN & SHILLER INC.12320-56 LABEAUSOL INC.733876 LA LIBERTE LTEE.1107-8664 LA SOCIALE STE THERESE INC.41179-53 25 01 68 05 04 61 19 02 70 22 12 54 16 06 65 29 07 60 01 09 61 07 08 56 20 08 73 10 12 48 01 10 53 07 03 75 21 02 75 21 02 75 07 03 75 21 02 75 27 02 75 07 03 75 28 02 75 21 02 75 14 02 75 21 02 75 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S3 février 737.5.10T année, 11° 8 1653 Nom / Name Incorporation Dissolution Date Date MT.ST.HILAIKE CONSTRUCTION INC.12121-58 MINES DE POIRIER INC.418-64 MONDIAL MACHINE RENTAL COMPANY, LTD.1651-71 MORGAN INSURANCE SERVICES LTD.LES SERVICES D'ASSURANCE MORGAN LTEE 6379-47 NORTHWAY INVESTMENTS INC.5005-68 NOUVEAU DOMAINE ETCHEMIN INC.3518-64 THE OTTAWA FOREST PROTECTIVE ASSOCIATION .L'ASSOCIATION DE PROTECTION DES FORETS DE L'OUTAOUAIS.5055-65 PINO TRANSPORT INC.12750-58 LES PLACEMENTS M.P.D.INC.4152-1968 CHARLES E.POIRIER & FILS INC.512-65 4492 SHERBROOKE STREET WEST (INC.).11662-56 A.WURM INC.1115-9845 12 06 58 29 01 64 31 03 71 22 10 47 21 10 68 05 08 64 11 11 65 19 09 5S 13 09 68 03 02 65 23 05 56 29 10 59 14 02 75 21 02 75 21 02 75 21 02 75 21 02 75 14 02 75 21 02 75 07 03 75 21 02 75 28 02 75 26 02 75 21 02 75 60016-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.60016-O Pierre Desjardinb, Director of the Companies Service.Avis de correction (Lettres patentes) Notice of correction (Letters patent) Le ministre des institutions financières, compagnies et The Minister of Financial Institutions, Companies and coopératives donne avis qu'en vertu de la Loi des compagnies, Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Com-il a autorisé la correction de lettres patentes suivantes: panies Act, he has authorized the correction of the letters patent issued to the following companies or corporations: Nom I Name Siège social Incorporation Head office Date Modifications Corrections LES ASCENSEURS INTER-CITE INC.et sa version anglaise INTER-CITY ELEVATORS INC.1370-0497 Montréal.16 10 74 Corrigeant le nom: / Correcting the name: « LES ASCENCEURS INTER-CITE INC.et sa version anglaise INTERCITY ELEVATORS LTD.» par / by « LES ASCENSEURS INTER-CITE INC.et sa version anglaise INTERCITY ELEVATORS INC.» 60016-0 Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.60016-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service. 1654 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February S3, 1975, Vol.107, No.S Domicile légal (Article 30) Legal Domicile (Section 30) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont établi leur bureau principal ou l'ont changé whose names follow have established their principal office or tel qu'indiqué ci-après.have changed it as indicated hereinafter.Domicile légal Incorporation Legal domicile Nom de la compagnie \u2022- Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address ACADIAN REALTIES LTD.04 10 62 4018, rue Ste-Catherine, 1255.Carré Phillips.14053-62 suite 217.Montréal.suite 210, Montréal.ACIER PROFILE S.B.B.INC.17 12 73 108.rue Bord de l'Eau.2919.boulevard Dagenais, S.B.IS.FORMED STEEL INC.Laval.Laval.735704 ACTON VALE TRANSPORT INC.28 02 68 Acton Vole.364.boulevard Roxton, 1100-5485 Acton Vale.AIR CONDITIONING A SERVICES LTD.17 10 55 Montréal.423, rue Mayor, Montréal.12519-55 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DC 16 10 74 Saint-Mathieu.265.de la Montée, Monette, DOMAINE VALBOISE INC.Saint-Mathieu.1369-7792 THE BARK LAKE PROTECTIVE ASSOCIA- 01 06 59 Montréal.3495.rue de la Montagne, TION INCORPORATED suite 1005, Montréal.CI: 423-59 BEAVER BUILDING CORP.12 11 49 Montréal.423.rue Mavor, Montréal.8435-49 BENEVOLENT SOCIETY LADIES' OF 10 03 60 Montréal.10822.James-Morrire.CASTORIA Montréal.14677-58 A.H.BERGERON INC.21 05 65 Shawinigan.806, 4e Rue, Shawinigan 1100-3837 6 BOCODES INC.12 07 74 Kénogami.46.rue Rembrandt, 1357-7911 Kénogami.BONBONS GUAY CANDIES LTD.08 10 59 Montréal.070, rue Jean-Talon, est 1102-3629 Montréal.BOUTIQUE EGO INC.10 01 72 Les Galeries Laehine, \"20125 Laehine.MnR(îoEnS LTD02 12 52 Montré»\".5557, avenue Monkland, i îuj-j.'sa Montréal.CENTRES CITADELLE LIMITEE.20 06 64 Suite 1300, Tour de la 2, Place Ville-Marie CITADEL CENTRES LIMITED Bourse.Montréal.Montréal.2944-64 TIP £2>EESE SH01>I>E (MONTREAL) LTD.04 12 68 Montréal.611, boulevard de Maison- 11U.-129.2 neuve ouest Montréal.VEHiiSPIDK LTEE \"\" \"\u2022¦ 10 01 67 Montréal.340, Sainte-Catherine est, 1102-2605 Montréal.ÇHK7 ULIANNE INC.M °5 41 2195, rue Crescent.7096.rue St-Hubert, 11022-9080 Montréal.Montréal.OCR 60-1951* BLANCHE24 10 51 chiR ATED 1204-30311 L.M.J.CO.INC.3781-65 30 12 70 8863, rue Longe.Verdun.3895.rue Le-:ige.Verdun.22 08 65 121.Kern lea-Cre>cent.Mont-Koyal.21 12 51 Lac-Petit-Cayamanl 375.avenue Dobie, Mont-Koyal.Lac-Petit-Cayamnnt.LANDIKAOAMA PIS H *: CAME CLUB C.C.P.0-1952 L'EVEIL Ml'SICAL D'ANJOU .03 05 73 7931.rue Wilfrid-Pelletier, 7701, boulevard LoOfe-H.736982 GASTON LEVESQUE INC 1157-9653 KOGKli LORD INC 1359-6085 M & H INC .1102-6306 MARCHE JOSEPH INC.JOSEPH MARKET 7 AT 1101-1046 MARCHE ST-CHARLES MARKET INC.1100-S521 Anjou.28 12 57 Viinier.10 1\" 74 Lebel-ur-Quévillon.26 01 68 4819.rue Van-Horne.Montréal.16 01 63 Montréal MILPAHK INC.1735-68 MISS SNOWDON PUMPERMK'S LTD.1102-4247 Il 07 55 Montréal.16 04 6S Montréal 21 12 44 Montréal .MOBRUN COPPER LTD.07 03 56 1, Carré Westinount.(No Personal Liability) 10729-56 MOTEL PHENIX.AMOS INC.1360-3998 G.NADEAC LTEE.1103-1689 NATIONAL MERCHANDISE MANUFACTURING CO.INC.7313-48 26 II 74 Amos 17 12 63 545, 63e Rue est.Char-lesbourg.18 II 48 Montréal XM LANAUDIERE INC.Il 03 (ill Joliette sus r,;.NOTRE-DAME LIMBER INC.1105-3659 PARADIS DES ENFANTS INC.1104-7339 04 01 51 Montréal.25 05 54 Montréal Lafontaine, Anjou.100.rue Chabot.Vanter.1110.Pare Industriel.Lehel-sur-Quévil Ion.4933, rue Van-Horne.Montréal.7700.Fabre.Montréal.2124.rue Centre, Montréal 1010.rue Sainte-Catherine ouest.Montréal.5131.boulevard Décarie, Montréal.Edifice delà Banque Royale 1.Place Ville-Marie, suite 750, Montréal.Route 45 est, Amos.6815.avenue Poirier.Charles bourg.1449.rue Saint-Alexandre, Montréal.5!14, rue Lalandc, Juliette.2315, rue Cadillac.Montréal.7341, rue Saint-Dc'iiis.Montréal.LES PLACEMENTS MIRACLE INI 2» 02 88 Montréal .4240, rue Horhelaga.1100-2953 QUEBEC ENTERPRISES LTD.4261-48 Montréal.10 06 48 Montréal.4M0, chemin Côte St-Luc, app.1004, Montréal.RANDY INVESTMENTS INC.20 06 72 Montréal.723696 RITZ MONACO RESTAURANT INC.12 02 59 Montréal.1102-7746 EUGENE ROY (DIVISION DE LA FERME), 06 06 63 142, avenue du Parc, LTEE L'Assomption.1139-7551 720, 800, Carré Victoria, Montréal.8551, boulevard Saint-Laurent.Montréal.30.Terrasse Laurier.L'Assomption. CA/.ETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.'-'février 1970.107' année.>i° S 1657 Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Domicile légal Legal domicile Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse .A/eu» address ST.JAMES RESOURCES LIMITED.1823-71 08 04 71 S00.boulevard Dorchesler ouest, app.2010.Montréal.SALAISONS DESMAlfAÏS INC.14 1101-441 SETON DEVELOPMENT LTD.I 714945 SPOHTS GERALD MONTPLAISIR INC.23 HERALD MONTPLAISIR SPORTS INC.733695 STATIONNEMENT RAMADA INC.05 RAMADA PARKING INC.725559 SUPER MARCHE MAVRAND & FRERES INC.27 1101-1194 THIBEAULT.RONDEAU INC.22 730819 TRANSPORT FELICO INC.03 1361-0555 IN I TED INVESTMENT SERVICES (QCEBEC) 31 LTD.SERVICES DE PLACEMENTS UNIS (QUEBEC) LTEE 11465-60 VALEY CONSERVATION CLUB.20 C.C.P.11-57 GEO.WEI NE II LTD.26 1100-5725 WONDERLAND INC.29 13905-59 07 65 5003, Louis-Veillot.Montréal.7 09 71 Montréal.08 73 1451, rue Laurier est, Montréal.10 72 1005, rue Guy, Montréal.11 04 Montréal 02 73 93-A, rue des Sorbiers, Drummondville.01 75 Matagami.03 60 Montréal 01 57 Wakefield 10 50 Montréal 00 59 243, Mont-Royal ouest, Montréal.800, Carré Victoria, app.720, Montréal.5855.De Jumonville.Montréal.1010, rue Sainte-Catherine ouest, suite 340, Montréal.2222.rue Mont-Royal est, Montréal.1, Place Ville-Marie, suite 3436, Montréal.2450, rue Bélanger est, Montréal.430, rue Saint-Georges, Drummondville.68, rue Demers, Matagami.2055.rue Peel.app.950, Montréal.Route rurale numéro 3, Route Mill, Wakefield.2310, avenue Benny.Montréal.9200, rue Meilleur, Montréal.Le directeur du service des compagnies, 60016-o Pierre Desjardins.\tPierre Desjardins, 60016-o Director of the Companies Service.Changement de nom\tChange of name Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, qu'en vertu de la Loi des compagnies il a approuvé les règlements de changement de nom suivants:\tThe Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives hereby gives notice that, pursuant to the Companies Act, he has approved the by-laws changing the name of: Nouveau nom / New name\tAncien nom Incorporation Former name Date \t.SILVER PROVISIONS INC.13 03 46 et sa version anglaise SILVER FOODS INC.1139-9284\t \tI.es salaisons REAITRIF.N INC nil na «¦> 11539-62\t 165S QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February 2S.1975.Vol.107.No.S Nouveau nom / New name Ancien nom Former name Incorporation Date ATPRO INC.1354-8185 BOUTHILLIER-RIOUX INC.729090 BRASSERIE D'AUTEUIL INC.1142-2193 CERCLE DE LA PLACE D'ARMES.1113-7379 CLUB DE MOTO-NEIGE AUX QUATRE VENTS INC.726241 CONSTRUCTION REA LTEE .4926-63 LES CULTIVATEURS NAPIERVILLE INC.et sa version anglaise NAPIERVILLE GROWERS INC.1148-6925 JEAN DEMERS (GENTILLY) INC.1188-1109 LES DISTRIBUTEURS DE LEGUMES DU QUEBEC INC.et sa version anglaise QUEBEC VEGETABLE DISTRIBUTORS INC.1148-6917 LES ENTREPRISES DE METAL DE L'ESTRIE INC.730819 FEDERATION DE BASKET-BALL DU QUEBEC.et sa version anglaise QUEBEC BASKETBALL FEDERATION 4104-69 FORMULES D'AFFAIRES POWTER LTEE.et sa version anglaise POWTER'S BUSINESS FORMS LTD.1118-8117 GAGEX INC.722765 GESTIONS J.BUCKER INC_____ et sa version anglaise ./.BUCKER HOLDINGS INC.8751-41 GUILAM INC.3309-69 LES HABITATIONS PROVENÇALES LTEE 722725 HOTEL-MOTEL LA VOIE DU LAC LTEE.1369-8329 LIBRAIRIE MONTREALAISE LIMITEE .et sa version anglaise MONTREAL BOOK ROOM LIMITED 1107-8912 GUILDO.MORNEAU ET ASSOCIES, INC.715630 ATLIFIC PROPERTIES LTD.11 02 74 LES PROPRIETES ATLIFIC LTEE S.RIOUX INC.03 10 72 MAIN-DRAIN INC.06 08 69 CERCLE DE LA PLACE D'AR- 24 03 64 MES INC.CLUB DE MOTO-NEIGE MONA- 07 12 72 CO INC.G.REA PLASTERING LTD.28 01 64 NAPIERVILLE GROWERS INC.13 02 68 GENTILLY RENDERING INC.22 07 57 QUEBEC VEGETABLE DISTRIB- 18 05 67 UTORS INC.THIBEAULT.RONDEAU INC.22 02 73 FEDERATION DE BALLON- 03 09 70 PANIER DU QUEBEC POWTER'S PRINTING LIMITED 05 05 37 L'IMPRIMERIE POWTER LIMITEE MERCERIE VAL D'OR INC.19 05 72 LEE PARKER INC.12 12 41 ODIN HOLDINGS COMPANY 12 08 69 LIMITED LES HABITATIONS B.C.P.LTEE 18 05 72 LEJAC LTEE.07 09 74 22 04 15 MONTREAL BOOK ROOM, LIMITED PIECES ET ACCESSOIRES D'AUTOMOBILES YORK INC.1109-3457 GUIL-MOR INC.22 10 71 YORK AUTO SUPPLY, INC.24 07 56 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.!> février 1975.107' année, n\" S 1659 Nouveau nom / iV'eui nome Ancien nom Former name Incorporation Date QUINCAILLERIE A.ET D.INC.2870-1969 RESIDENCE DU BON PASTEUR INCORPOREE.et sa version anglaise GOOD SHEPHERD RESIDENCE INCORPORATED 6126-69 J.SLAWNER LTEE.et sa version anglaise J.SLAWNER LTD.2505-63 LA SOCIETE DE MINERAIS D'AMIANTE D'ABITIBI LIMITEE et sa version anglaise ABITIBI ASBESTOS MINING COMPANY LIMITED 5386-65 VENTES E.HADLEV INC.et sa version anglaise E.HADLEY SALES INC.4124-1970 VILLA DUBE INC.469-1969 SUPER MARCHE ALPHONSE 27 06 69 GAGNON INC.CATHOLIC MEN'S HOSTEL INC.19 01 70 J.SLAWNER ORTHOPEDIC AP- 07 06 63 PLIANCES LTD.ABITIBI ASBESTOS MINING 29 12 65 COMPANY LIMITED LACHUTE COMMISSION SALES 23 10 70 INC.FOYER DE ST-JEAN-DE-DIEU 22 04 69 INC.60016-o Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins.60016-o Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.Siège social (Article 84) Head office (Section 84) Avis est donné que les compagnies et corporations dont les Notice is hereby given that the companies and corporations noms suivent ont changé leur siège social tel qu'indiqué ci- whose names follow have changed their head office as indicated après.hereinafter.Nom de la compagnie Name of the company Incorporation Date Siège social Head office Ancienne adresse Previous address Nouvelle adresse New address ANITA'S INC.- 19 10 61 Montréal.14341-61 APPARTEMENTS RESIDENCE DU PARC 06 02 68 125, avenue Fairfield, INC.Greenfield Park.40-68 AUBERGES DES NIDS D'HIBOU INC.24 08 73 1280, Saint-Marc, suite OWL'S NEST INNS INC.1507, Montréal.737959 AUTOMATION MACHINES INC.20 09 65 1, Place Bellerive, app.1111-7090 509, Laval.BELCAMPO CORPORATION.19 08 64 631, avenue Victoria, 3717-64 Westmount.BERRA AUTOMOBILE INC.28 04 70 3475, avenue du Parc, 1196-1497 Montréal.J.W.BOOKER & ASSOCIATES INC.27 05 71 Saint-Laurent.2781-71 8644.Place Chaumont, Anjou.1820, des Érables, Saint-Bruno-de-Montarville.Potton.80, chemin Lakeshore, suite 903, Pointe-Claire.2055, rue Peel, suite 1050, Montréal.47, rue Forest.L'Assomption.2602, route Cedar, Val-David. IfiGO QCÉIIEC OFFICIAL GAZETTE.February 22.797.7.Vol.107.No.S Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address BOUTIQUE EGO INC.10 01 72 Les Galeries Laehine, 190, Richelieu, Saint-Jean.720125 Laehine.CEDO INC.02 04 62 Laval-des-Rapides.11821, Place Frigon, 11378-62 Montréal.CERTIFIED PROPERTY MANAGEMENT INC.11 07 68 1367.avenue Greene.2075, rue Université, GESTION D'IMMEUBLES ACCREDITEE INC.Westmount.Montréal.2931-68 CLUB AERONAUTIQUE DE BEAUCE INC.13 04 61 Saint-Georges-de-Beauce.Rang Saint-Guillaume, 11086-61 Saint-George-de-Beauce.LA CORPORATION DES ARPENTS BOLTON.24 08 73 1280.rue Saint-Mare, Potton.BOLTON ACRES CORPORATION suite 1507, Montréal.73795S J.A.COUSINEAU LTEE.29 12 55 Montréal.4752, avenue Verdun, 13611-55 Verdun.DEBOSSELAGE SPRINGLAND INC.27 12 73 2732-A, rue Springland.2060.rue Lapierre, SPRINGLAND AUTO BODY INC.Montréal.LaSalle.739138 DOMAINE LAC TAPANI INC.13 04 67 Sainte-Adèle.Route rurale numéro 2, 890-67 Sainte-Anne-du-Lac.DONLIN INVESTMENT CORP.12 09 63 Montréal.12.020, boulevard Albert- 3886-63 Hudon, Montréal-Nord.MARCEL DROUIN (MTL) LTEE.30 06 71 3675, boulevard Saint- 260.Deslauriers.Saint- MARCEL DROUIN (MTL) LTD.Martin, Laval.Laurent.1217-0957 DUNCAN RANGE IRON MINES QUEBEC 04 01 57 Québec.800, carré Victoria, bureau LIMITED (No Personal Liability).720, Montréal.10056-57 LES ETABLISSEMENTS ANCORO INC.14 12 72 1100, McGregor, app.221.106.rue Saint-Gérard 729588 Montréal.Saint-Alexandre.LES ETABLISSEMENTS ANCORO INC.14 12 72 Joliette.1100, McGregor app 221 729588 Montréal.EXPLORATION MINIERE DYNAMIQUE 25 06 69 800.chemin Sainte-Foy, 4111, Stock Exchange LTEE (Libre de responsabilité personnelle) Québec.Tower.Place Victoria DYNAMIC MINING EXPLORATION LTD.Montréal.(A^o personal liability) 3051-69 THE FLOWER POT LTD.01 08 66 1, Place Bonavcnture, 2275, chemin Saint- AU POT DE FLEURS LTEE Montréal.François, Dorval.3030-61» » ANDRE FRADET INC.01 08 74 360, boulevard Chnrest est, 8505, Place du Gouverneur 1358-2499 Québec.Charlesbourg.S£X,0N INC12 10 \" Saint-David.de- 18.rue Chateaubriand.«25662 L Aubenvière.Levis.GESTION PORTAGE LTEE.18 05 71 Hull.37.rue St-Raphaël, 1808-71 Gatineau.USBa?™-0 TOBUC,TE INC24 12 71 Qu(be'-.381.rue Saint-Laurent, ' ¦Mo»-195!» Levis.J^ENOINC.26 03 71 210, boulevard Charest Saint-Dunstan-du-Lac- 1526-71 est, Quebec.Beauport.V-s, J' C0' INC25 08 65 S\", avenue Dobie.371, Bleignier.3-81-60 Mont-Royal.Saint-Laurent. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.22 février J9T5.107' année.n° 8 1661 Siège social Incorporation Head office Nom de la compagnie -¦- Name of the company Date Ancienne adresse Nouvelle adresse Previous address New address L'ALLIANCE LAUREN TIENNE DES METIS ET INDIENS (HORS RESERVE) INC.THE LA CRENTIAN ALLIANCE OF METIS AND NON-STATUTS INDIANS INC.721662\t27\t03\t72\t\t1410.rue Stanley, suite 618, Montréal.NORMAND LAPOINTE INC.\t16\t12\t69\t\t3272, rue Amicale, Mascouche.6024-69\t\t\t\t\t LAUZON & LAPOINTE CONST.INC.\t27\t04\t71\t\t3272.rue Amicale, Mascouche.1212-7817\t\t\t\t\t G.W.LINE LTEE.1175-1179\t15\t08\t68\t777.4e Rue.Shawinigan.\t1755, rue Grenet, Saint-Laurent.MAJOR CHEMICAL I'RODCCTS LTD.LES PRODUITS CHIMIQUES MAJEURS LTEE.732103\tOS\t05\t73\t4613, 9e Rue, Chomedey.Laval.\t1.avenue Van-Horne ouest, Montréal.MATERIAL HANDLING SOCIETY OF MONTREAL LA SOCIETE DE MANUTENTION DE MONTREAL 2799-51\t07\t03\t51\tMontréal.\t282, Houle, Saint-Eustache.MONTREAL WEST OPERATIC SOCIETY INC.8655-49\t28\t11\t49\t620, rue Cathcart, suite 614.Montréal.\t50, avenue Westminster sud, Montréal-Ouest.ODIN HOLDINGS COMPANY LIMITED.3309-69\t12\tIIS\t69\tSaint-Sauveur-des-Monts.\t1069, boulevard Sainte-Adèle, Sainte-Adèle.PRETS FONCIERS (ST-JEAN) INC.391.8-1970\t04\t09\t70\t\t6.Place du Marché, No 11.Saint-Jean.\t16\t08\t63\t\t6665.Bombardier, Saint-Léonard.2980-63\t\t\t\t\t QUEBEC COUNCIL OF PARENT PARTICIPATION PRESCHOOLS 4211-66\t20\t10\t66\t800, Carré Victoria.chambre 2104, Montréal.\t20551.route Lakeshore.Baie-d'Urfé.QUEBEC METAL PRESSING INC.\t06\t04\t46\tQuébec.\t835, avenue Godin, Vanier.1156-1792\t\t\t\t\t REGENT TOBACCO & CONFECTIONERY COMPANY LIMITED 1100-1138\t05\t04\t52\t\t2080, rue Chartier.Dorval.RESTAURANT LE VIEUX QUAI INC.724187\t26\t07\t72\t7157, rue Pontoise.Sant-Léonard.\t50, Duflerin, \\ alleyfield.ERNEST ST-ARNAUD INC.1125-6062\tm\t08\t56\t5405, Royalmount.Mont-Royal.\t2185.avenue Francis-Hughes, Chomedey, Laval.LA SOCIETE MALBEC INC.1001-70\t15\t05\t70\t2030, boulevard Père-Lelièvre, Vanier.\t1422, Saint-Alphonse, Ancienne-Lorette.STANDARD WELDING SUPPLIES LTD.1110-9733\t12\t04\t50\t5339, rue Crowley, Montréal.\t6S70, Andover, Mont-Royal.THERIAULT.AHIER & ASSOCIES INC.1359-7687\t18\t10\t74\t78, Place Bilodeau.Val-Saint-Michel.\t99, carré Richard, Neufchâtel.WESHLER SALES PROMOTIONS LTD.\t01\t05\t56\t\t755, boulevard Lebeau, Saint-Laurent.11424-56\t\t\t\t\t Le directeur du service des compagnies, Pierre Desjardins, 6001G-o Pierre Desjardins.6OOI6-0 Director of the Companies Service. QUÉBEC OFFICIAI, GAZETTE, February :>.', J97Ô.Vol.107, So.S Demandes d'abandon de charte Applications for Surrender of Charter BRAULT & VIENS INC.Prenez avis que la compagnie « BRAULT & VIENS INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa ebarte.Cowansville, ce 3e jour de février 1975.Le procureur de la compagnie.60024-o Mb André Bachand.BRAULT & VIENS INC.Notice is given that the company \"BRAULT & VIENS INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Cowansville.this 3rd day of February, 1975.Me André Bachand, 60024-o Attorney for the company.COUTINHO, CARO & CO.(CANADA) LTD.Avis est donné que la société « COUTINHO.CARO & CO.(CANADA) LTD.» se propose de demander au au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, le 20e jour de septembre 1974.60025-o Le directeur.H.Sternberg.COUTINHO, CARO & CO.(CANADA) LTD.Notice is hereby given that \"COUTINHO, CARO & CO.(CANADA) LTD.\" intends to apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 20th day of September, 1974.H.Sternberg.60025-o Director.MYER HERSHORN CONSULTANTS INC.Prenez avis que la compagnie « MYER HERSHORN CONSULTANTS INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie.Orenstein, Ruby.Michelin, Orenstein.Montréal.Que.60026-o MYER HERSHORN CONSULTANTS INC.Take notice that \"MYER HERSHORN CONSULTANTS INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Orenstein, Rcbv, Michelin, Orenstein, Attorneys for company.Montreal, Que.60026-o HOPITAL STE-ANNE DE VICTORIAVILLE (1969) INCORPOREE Prenez avis que la corporalion « HOPITAL STE-ANNE DE VICTORIAVILLE (1969) INCORPOREE ¦>.dont le siège social est situé à Victoriaville, dans le district d'Arthabaska, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Le procureur de la corporation.Yves Béchahd, notaire.Victoriaville.Que.60027-o HOPITAL STE-ANNE DE VICTORIAVILLE (1969) INCORPOREE Notice is given that \"HOPITAL STE-ANNE DE VICTORIAVILLE (1969) INCORPOREE\", whose head office is located in Victoriaville.in the District of Arthabaska.will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Yves Béchard, notary.Attorney for the corporation.Victoriaville.Que.60027-o G.A.MANZATO LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie « G.A.MANZATO LTD.».constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 24e jour de janvier 1975.Le procureur de la compagnie, 60028 Daniel I.Trevick, avocat.G.A.MANZATO LTD.Notice is hereby given that \"G.A.MANZATO LTD.\" a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial' Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 24th of January, 1975.Daniel I.Thevick, lawyer.Attorney for the company.60028-o GAZETTE OFFICIELLE DC Ql'flllEC.22 février 1975.107' année.h° S 1663 NORTH MONTREAL WAREHOUSE LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie « NORTH MONTREAL WAREHOUSE LTD.».constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social dans la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte.Daté à Montréal, le 27e jour de janvier 1975.Les procureurs de la compagnie, Stikeman, Elliott, Tamaki.60029-u Mercier & Robb.RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.Avis est par les présentes donné que la compagnie « RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.» demandera au minisire des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Les procureurs de la compagnie.Bhéher, Behn'ier, Lolbier, Côté & Ass., avocats.Québec.Que.60030-o SUMMERHII.I.PARK DEVELOPMENT INC.Prenez avis que « SUMMERHILL PARK DEVELOPMENT INC.».une corporation légalement constituée en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social à Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec pour obtenir la permission d'abandonner sa charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Le secrétaire, 60031-o David Zunenshink.AUDIO ATLAS ASSOCIATES LTD.Avis est donné que la compagnie « AUDIO ATLAS ASSOCIATES LTD.demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 11 février 1975.Le procureur de la compagnie, 60059-o David Litner, ch.LA COLONIE DE VACANCES NOTRE-DAME DE MONTMORENCY LAVAL Prenez avis que « LA COLONIE DE VACANCES NOTRE-DAME DE MONTMORENCY LAVAL», constituée par lettres patentes en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies le 4 mai 1966, enregistrées au registre île la province le 27 septembre 1966, Libro 1337, Folio 69.demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, Jos.-A.Tremblay.Québec.Que.60060-o NORTH MONTREAL WAREHOUSE LTD.Notice is hereby given that \"NORTH MONTREAL WAREHOUSE LTD.\".a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Dated at Montreal, this 27th day of January, 1975.Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb.60029-o Attorneys for the company.RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.Notice is hereby given that \"RESTAURANT L'AMBASSADEUR DE STE-FOY INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Bherek, Bernier, Lolbieu, Côté & Ass., lawyers.Attorneys for the company.Québec, Que.60030 SUMMERHILL PARK DEVELOPMENT INC.Notice is hereby given that \"SUMMERHILL PARK DEVELOPMENT INC.\", a corporation incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.David Zunenshink, 60031-o Secretary.AUDIO ATLAS ASSOCIATES LTD.Notice is given that \"AUDIO ATLAS ASSOCIATES LTD.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Montreal.February 11th 1975.David Litneh.u.c., 60059-o Attorney for the company.LA COLONIE DE VACANCES NOTRE-DAME DE MONTMORENCY LAVAL Notice is herebv given that \"LA COLONIE DE VACANCES NOTRE-DAME DE MONTMORENCY LAVAL\", a corporation incor|x>rated under Part III of the Companies Act.on the 4th day of May 1966, registered on the 27th day of September 1966, Libro 1337, Folio 69, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec, for leave to surrender its charter.Jos.-A.Tremblay, Attorney for the company.Québec.Que.60060-o 1064 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, February 12, 1975, Vol.j07, iVp.8 KIPPI'S FINE FOODS LTD.Avis est par les présentes donné que la compagnie « KIPPI'S FINE FOODS LTD.», constituée en date du 13 juillet 1059 sous l'empire de la première partie de la l.oi des compagnies, et ayant son siège social à Montréal, présentera incessamment auprès du ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, une requête jx,ur abandon de charte suivant les dispositions de la Loi des compagnies.Montréal, ce 2S novembre 1974.(Sceau) Le secrétaire.i)0()(12-o Joseph Matjasko.KIPPI'S FINE FOODS LTD.Notice is hereby given that \"KIPPI'S FINE FOODS LTD.\", incorporated on July 13, 1959 under Part I of the Companies Act, and having its head office in Montreal, will forthwith apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quebec for leave to surrender its charter pursuant to the provisions of the Companies Act.Montreal, November 28, 1974.(Seal) Joseph Matjasec, 60062 Secretary.JEAN LA VERDURE & ASSOCIES LIMITEE Prenez avis que la compagnie « JEAN LAVER DURE & ASSOCIES LIMITEE demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Montréal, le 28 novembre 1974.Le procureur tie la compagnie.60063-o Mr Jean-Yves Fortin.JEAN LAYERDl'RE & ASSOCIES LIMITEE Notice is given that \"JEAN LAYERDl'RE & ASSOCIES LIMITEE\" will apply lo the Minister of Financial Institutions.Companies and Coopératives for leave to surrender its charter.Montreal, November 2S, 1974.Me Jean-Yves Fortin, 60063 Attorney for the company.INTERSAT COMMUNICATIONS CORPORATION INTERSAT COMMUNICATIONS CORPORATION Avis est donné par les présentes que la compagnie « INTERSAT COMMUNICATIONS CORPORATION (autrefois PIZZA PAN INTERNATIONAL CORPORATION, et autrefois UNIVERSAL FACTORS CORPORATION) », constituée en corporation en vertu de la première partie de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec, la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 6e jour de février 1975.Les procureurs de la compagnies, 60038 Lazarus, Lehher & Baer.LES MINES LAVAL LIMITEE Prenez avis que la compagnie « LES MINES LAVAL LIMITEE demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la requérante.Me André Carter.Québec.Que.60039-o CALAGAMO INC.Avis est donné conformément à la Loi des compagnies que « CALAGAMO INC.» demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Stc-Justinc.le 30 janvier 1975.Le procureur de la compagnie.00040-o G.-O.LangloIs, notaire.Notice is hereby given that \"INTERSAT COMMUNICATIONS CORPORATION (formerly PIZZA PAN INTERNATIONAL CORPORATION, and formerly UNIVERSAL FACTORS CORPORATION)\", a corporation incorporated under Part I of the Companies Act.and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quebec, for leave to surrender its charter, under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 6th day of February, 1975.Lazarus.Lehreh & Baer, 60038-o Attorneys for the company.LES MINES LAVAL LIMITEE Notice is hereby given that \"LES MINES LAVAL LIMITEE\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Me André Carter.Attorney for petitioner.60039 CALAGAMO INC.i ^J^.Kfeî^ïï given' under the Companies Act that \"CALAGAMO INC.\" will ask the Minister of financial Institutions, Companies and Cooperatives permission to surrender its charier.Sto-.Iustine.this 30th day of January, 1975.G.-O.Langlois.notary.o0040-o Attorney for the company.Québec, Que. GAZETTE 01-7-KlELLE DC QUÉBEC, -'.'février 19?:,.tOT année, ir H 1665 CORMIER & FRERES LTEE Prenez avis que la compagnie « CORMIER & FRERES LTEE », ayant son siège social au 28.rue Marseille.Tourainc.province île Québec, demandera au minisire des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte, Le procureur de la compagnie.00041-o Gaétan Coisineau, notaire.LES ENTREPRISES L.VFFAGE INC.Prenez avis que la compagnie « LES ENTREPRISES LAFTAGF.INC.\" demandera au ministre îles institutions financières, compagnies et coopératives, la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Jacques McNulty.notaire.St-Jcan.Que.60042-o l'IKRREFONDS REALTY « DEVELOPMENT CORP.Avis est par les présentes donné que la compagnie « PIERREFONDS REALTY & DEVELOPMENT CORP.constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies et ayant son siège social et son principal établissement en les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Fait à Montréal, ce 7e jour de février.1975.Les procureurs de la compagnie.Chait.Salomon, Gelbek, 60064 Reis.Bkonstein & Litvack.PROJET D'HABITATION PLANIFIEE DE GRAND-MERE INC.Prenez avis que la compagnie « PROJET D'HABITATION PLANIFIEE DE GRAND-MERE INC.~ demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Gilles-Guy G arceau, notaire.Trois-Rivières, Que.60065-o UNITED MORTGAGE CORPOR \\TION CORPORATION UNIE D'HYPOTHEQUE Avis est par les présentes donné que « UNITED MORTGAGE CORPORATION \u2014 CORPORATION UNIE D'HYPOTHEQUE «, constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, et ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté à Montréal, le lie jour de février, 1975.Les procureurs de la compagnie.60066-o Phillips & Vixeberg.CORMIER & FRERES LTEE Notice is given thai.\" CORMIER & FRERES LTEE\".having ils head office at number 28 Marseille Street Touraine.Province of Québec, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.Gaétan Coisinkau.notary.00041 Attorney for the company.LES ENTREPRISES LVFFAGE INC.Notice is given that \"LES ENTREPRISES LAFFA-GK INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charier.Jacques McNt ltv.notary.Attorney for the company.St-Jean, Que.60042 PIERREFONDS REALTY & DEVELOPMENT COUP.Notice is herebv given that \"PIERREFONDS REALTY & DEVELOPMENT CORP.\", a corporation constituted under the Companies Act and having its head office and principal place of business in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 7th day of February, 1975.Chait.Salomon.Gelbeb.Reus, Bhonstein & Litvack.60064-o .Ittornegs for the com pang.PROJET D'HABIT VTION PLANIFIEE DE GRAND-MERE INC.Notice is herebv given that the company \"PROJET D'HABITATION PLANIFIEE DE GRAND-MERE INC.\" will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter.GlLLES-GlY (ïARCEAU, Sotary.Attorney for the company.Trois-Rivières, Que.60065-o UNITED MORTGAGE CORPORATION CORPORATION UNIE D'HYPOTHEQUE Notice is herebv given that \"UNITED MORTGAGE CORPORATION \u2014 CORPORATION UNIE D'HYPOTHEQUE\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated at Montreal, this 11th day of February, 1975.Phillips & Vinkberg, 60066-o Attorneys for the company. 1666 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February :!2, 1975, Vol.107, A'o.8 CUSTOM BUILT HOMES CORPORATION Avis est par les présentes donné que « CUSTOM BUILT HOMES CORPORATION » se propose de présenter une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal.Que., le 16 décembre 1974.(Sceau) Le secrétaire, 60091-o F.C.Cope.CUSTOM BUILT HOMES CORPORATION Notice is hereby given that \"CUSTOM BUILT HOMES CORPORATION\" intends to make application to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Montreal, P.Q.December 16, 1974.(Seal) F.C.Cope, 60091 -o Secretary.HOME OWNERS CORI'OR VTION Avis est par les présentes donné que « HOME 0\\\\ N-ERS CORPORATION \u2022 se promise de présenter une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province île Québec en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Monlréal.Que., le 16 décembre 1974.(Sceau) Le secrétaire.60093-o F.C.Cope.HOME OWNERS CORPORATION Notice is hereby given that \"HOME OWNERS CORPORATION\" intends to make application to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Montréal, P.Q.December 16.1974.(Seal) F.C.Cope, 60093-o Secretary.MORO INVESTMENTS LTD.Avis est par les présentes donné que « MORO INVESTMENTS LTD.» se propose de présenter une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec en vue d'obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal, Que., le 16 décembre 1974.(Sceau) Le secrétaire.60094-o F.C.Cope.MORO INVESTMENTS LTD.Notice is hereby given that \"MORO INVESTMENTS LTD.\" intends to make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Montreal, P.Q.December 16.1974.(Seal) F.C.Cope, 60094-o Secretary.NORMAN A.BRADY, R.RIOPELI.E & ASSOCIES INC.Avis est par la présentes donné que « NORMAN A.BRADY.R.RIOPELI.E & ASSOCIES INC.», une corporation constituée en vertu de la première partie de la Loi des compagnies et ayant son siège social en les ville et district de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, pour obtenir la permission d'abandonner sa charte en vertu des dispositions de la Loi des compagnies.Signé à Montréal, P.Q.ce 6e jour de décembre 1972.60096-o H.Riopkli.e.NORMAN A.BRADY.R.RIOPELI.E & ASSOCIES INC.Notice is hereby given that \"NORMAN A.BRADY, R.RIOPELLE & ASSOCIES INC.\", a corporation constituted under Part I of the Companies Act and having its head office in the City and District of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions.Companies and Cooperatives for leave to surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Signed al Montreal.I'.Q.this 6th dav of December 1972.60096-o R.Riopixi.e.CEDAR TOWERS CORP.Avis est par les présentes donné que « CEDAR TOWERS CORP.constituée en corporation en vertu de la Loi des compagnies, cl ayant son siège social en la ville de Montréal, s'adressera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec afin d'obtenir la permission d'abandonner sa charte, conformément aux dispositions de la Loi des compagnies.Daté a Montréal, le 10c jour de février, 1975.Les procureurs rte la compagnie.60097-o Phillips it ViVEnum.CEDAR TOWERS CORP.Notice is hereby given that \"CEDAR TOWERS CORP.\", incorporated under the Companies Act and having its head office in the City of Montreal, will apply to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Quebec for leave to .surrender its charter under the provisions of the Companies Act.Dated al Montreal, this 10th day of February, 1975.Phillips & Vinebrko, 60097-o .I ttorneys for the compauy. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février J97Ô, 107' année, n' 8 1667 MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION Avis est par les présentes donné que « MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION » se propose de présenter une demande au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives de la province de Québec en vue d\"obtenir la permission d'abandonner sa charte.Montréal.Que., le 16 décembre 1974.(Sceau) Le secrétaire, 60095-o F.G.Cope.MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION Notice is herebv given that \"MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION\" intends to make application to the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives of the Province of Québec for leave to surrender its charter.Montreal, P.Q., December 16.1974.(Seal) 60095-o F.C.Cope.Secretary.LES HOTELLERIES FAUCHER INCORPOREE LES HOTELLERIES FAUCHER INCORPORATED Prenez avis que la compagnie « LES HOTELLERIES FAUCHER INCORPOREE demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie.Me Lucien Grenier.New-Carlisle.Que.6009S-o Take notice that the companv \"HOTELLERIES FAUCHER INCORPORATED\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the permission to surrender its charter.Me.Lucien Grenier, Attorney for Hie company.New-Carlisle.Que.0009S-o CO.MITE DES LOISIRS SAINT-SEVERIN Prenez avis que « COMITE DES LOISIRS SAINT-SEVERIN » demandera au ministre des institutions financières, compagnies et coopératives la permission d'abandonner sa charte.Le procureur de la compagnie, 60061-o Jacques Martel, notaire.COMITE DES LOISIRS SAINT-SEVERIN Notice is hereby given that the company \"COMITE DES LOISIRS DE SAINT-SEVERIN\" will ask the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, the authorization to surrender its charter.Jacques Martel, notary, 60061-o Attorney for the petitioner.Ministère des Terres et Forêts Cadastre Department of Lands and Forests Cadastre Canton d'Ascot Cadastre officiel du canton d'Ascot.municipalité de la cité de Sherbrooke, division d'enregistrement de Sherbrooke.Avis est par la présente donné que les lots 22.1-7 à 22J-29 du rang VII sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 27 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard, a.-g.Township of Ascot Official cadastre of township of Ascot, municipality of the city of Sherbrooke, registration division of Sherbrooke.Notice is hereby given that lots 22.1-7 to 22J-29 of range VII are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 27, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Paroisse de L'Assomption Cadastre officiel de la paroisse de L'Assomption, municipalité de la paroisse de L'Assomption, division d'enregistrement de L'Assomption.Avis est par la présente donné que les lots 10-20 à 10-22 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 17 janvier 1975.Parish of L'Assomption Official cadastre of the parish of L'Assomption, municipality of the parish of L'Assomption, registration division of L'Assomption.Notice is hereby given that lots 10-20 to 10-22 arc cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 17.1975.Benoît Grimard.a.-g.60036-o l'or the Deputy Minister.Pour le sous-ministre, 60036-o Benoît Grimard, a.-g. 1668 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February 7.97.5, Vol.107.No.8 Canton dc Granby Cadastre officiel du canton dc Granby, municipalité de la ville de Granby.division d'enregistrement de ShefTord.Avis est par la présente donné que les lots 606-62, 710-1 à 710-28 sont annulés en vertu dc l'article 2174a du Code civil.Québec, le 30 janvier 1975.Pour le sous-ministre, 60036-o Benoît Grimard, a.-g.Canton dc Hatley Cadastre officiel du canton de Hatley.municipalité dc Sainte-Catherine-de-Hatley *.division d'enregistrement de Stanstead.Avis est par la présente donné qu'une parlie du lot 1360-80 est annulée en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 6 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimaru, a.-g.Canton de Laflèche Cadastre officiel du canton de Laflèche.municipalité de la ville de Hauterive, division d'enregistrement dc Saguenay.Avis est par la présente donné que les lots 1-3-18, 1-3-18-1, 1-3-18-2, 1-3-19 et 2-7-18 du rang II sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 29 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Ghimard, a.-g.Paroisse de Laprairie de la Madeleine Cadastre officiel de la paroisse de Laprairie-de-la-Madeleinc.municipalité de la ville de La Prairie, division d'enregistrement de Laprairie.Avis est par la présente donné que les lots 719, 720 sont ajoutés et qu'une partie des lots 299 à 306, 304-229, 305-204 sont annulées en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 20 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Longue-Pointe Cadastre officiel dc la paroisse de Longue-Pointe, municipalité de la ville d'Anjou, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 482-15 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 23 janvier 1975.Township of Granby Official cadastre of township of Granby.municipality of the town of Granbv, registration division of Shefford.Notice is hereby given that lots 606-62.710-1 to 710-2S are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 30, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Township of Hatley Official cadastre of township of Hatley.municipality of Sainte-Catherine-de-Hatley *.registration division of Stanstead.Notice is hereby given that a part of lot 1360-80 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 6, 1975.Benoît Grimard.a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Township of Laflèche Official cadastre of township of Laflèche.municipality of the town of Hauterive.registration division of Saguenay.Notice is hereby given that lots 1-3-18, 1-3-18-1, 1-3-18-2, 1-3-19 and 2-7-18 of range II are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 29, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Parish of Laprairie de la Madeleine Official cadastre of the parish of Laprairie-dc-la-Ma-deleine, municipality of the town of La Prairie, registration division of Laprairie.Notice is hereby given that lots 719, 720 arc added and that a part of lots 299 to 306.304-229.305-204 arc cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 20, 1975.Benoît Grimard, a.-g.60036-o For the Deputy Minister.Parish of Longue-Pointe Official cadastre of the parish of Longue-Pointe, municipality of the town of Anjou, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 482-15 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 23, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o for the Deputy Minister.Pour le sous-ministre, 60036-o Benoît Grimard, a.-g. (i.lZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.férrier 1970.I07' mince, »« S 1669 Canton de Letellier Cadastre officiel du canton de Letellier.municipalité de la cité des Sept-Iles.division d'enregistrement de Sept-îles.Avis est par la présente donné que les lots 2S-1.28-3 à 28-5.28-8.28-9.28-11.28-13 à 28-15.28-17 à 28-81.28-94 à 28-100.28-114 à 28-142, 28-148 à 28-155, 28-163 à 28-167 sont annulés en vertu dc l'article 2174a du Code civil.Québec, le 15 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard.a.-'.Canton de Lussier Cadastre officiel du canton de Lussier.municipalité de Saint-Donat*.division d'enregistrement de Montcalm.Avis est par la présente donné que le lot 30-19 et que la partie restante îles lots 30-14, 30-18 du rang IV sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 24 janvier 1975.Pour le sous-ministre, 60036-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Pointe-aux-Trembles Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles.municipalité de la cité de La Pointe-aux-Trembles, division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 271 à 280 sont ajoutés et qu'une partie des lots 203.204 sont annulées en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec.le 21 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Pointe-aux-Trembles Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, municipalité de la cité de La Pointe-aux-Trembles.division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 282 est ajouté et que les lots 132-1 à 132-4 136 et qu'une partie îles lots 132 à 135 et 137 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 21 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Saint-Césaire Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Césaire, municipalité de la paroisse de Saint-Césaire.division d'enregistrement de Rouville.Avis est par la présente donné que le lot 394-110 est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 23 janvier 1975.Township of Letellier Official cadastre of township of Letellier, municipality of the city of Sept-Iles.registration division of Sept-îles.Notice is herebv given that lots 28-1.28-3 to 28-5.28-8.28-9, 28-11.28-13 to 28-15.28-17 to 28-81, 28-94 to 28-100, 28-114 to 28-142, 28-148 to 28-155, 28-163 to 28-167 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 15, 1975.Benoît Grimard.a.-g.60036-o For the Deputy Minister.Township of Lussier Official cadastre of township of Lussier.municipality of Saint-Donat*.registration division of Montcalm.Notice is hereby given that lot 30-19 and that Ihe remaining part of lots 30-14, 30-18 of range IV are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 24, 1975.Benoît Grimard, a.-g.60036-o For the Deputy Minister.Parish of Pointe-aux-Trembles Official cadastre of the parish of Pointe-aux-Trembles, municipality of the city of La Pointe-aux-Trembles, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 271 to 280 are added and that a part of lots 203.204 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 21, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Ministei Parish of Pointe-aux-Trembles Official cadastre of the parish of Pointe-aux-Trembles, municipality of the city of La Pointe-aux-Trembles, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 282 is added and that lots 132-1 to 132-4, 136 and that a part of lots 132 to 135 and 137 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 21, 1975.Benoît Grimard.a.-g.60036-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Césaire Official cadastre of the parish of Saint-Césaire, municipality of the parish of Saint-Césaire.registration division of Rouville.Notice is hereby given that lot 394-110 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 23.1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Pour le sous-ministre.1)0036-0 Benoît Grimard.a.-g. 1(170 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February ¦>-'.1975, Vol.107.Xo.s Paroisse de Pointe-aux-Trembles Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, municipalité dc la cité de La Pointe-aux-Trembles.division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 281 est ajouté et qu'une partie îles lots 203.204 sont annulées en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 21 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard.a.-g.Paroisse de Pointe-aux-Treiiibles Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, municipalité de la cité de La Pointe-aux-Trembles.division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que les lots 283, 284 sont ajoutés et qu'une partie des lots 200.201 et 200-12.des lots 200-14.201-13 à 201-1(1 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 21 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard, a.-g.Paroisse de Pointe-aux-Trembles Cadastre officiel de la paroisse de Pointe-aux-Trembles, municipalité de la ville de Montréal-Est.division d'enregistrement de Montréal.Avis est par la présente donné que le lot 270 est ajouté et que les lots 82-44 à 82-74.82-79.S3-1 à 83-28.85-6.255 et qu'une partie des lots 82.82-430, 83.S5 et la partie restante du lot 82-1 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 21 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard.a.-g.Paroisse de Saint-Ilippoly te Cadastre officiel de la paroisse de Saiiit-Hipi>olylc.municipalité de Shawbridge *, division d'enregistrement dc Terrebonne.Avis est par la présente donné que le lot 18B-15 du rang V canton d'Àbercrombie est annulé en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 30 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard, a.-c.Paroisse île Saint-Jérôme Cadastre officiel de lu paroisse de Saint-Jérôme, municipalité de Shawbridge *.division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que le lot 309-18 est annulé en vertu de l'article 217-la du Code civil.Québec, le 27 janvier 1975.Parish of Pointe-aux-Trembles Official cadastre of the parish of Pointe-aux-Trembles, municipality of the city of La Pointe-aux-Trembles, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 281 is added and that a part of lots 203.204 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 21, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Parish of Pointe-aux-Trembles Official cadastre of the parish of Pointe-aux-Trembles, municipality of I he city of La Pointe-aux-Trembles, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lots 283, 284 are added and that a part, of lots 200.201 and 200-12, that lots 200-14, 201-13 to 201-16 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 21.1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Parish of Pointe-aux-Trembles Official cadastre of the parish of Pointe-aux-Trembles, municipality of the town of Montreal-East, registration division of Montreal.Notice is hereby given that lot 270 is added and that lots 82-44 to 82-74, 82-79.83-1 to 83-28.85-6.255 and that a part of lots 82.82-430.S3, 85 and that remaining part of lot 82-1 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 21.1975.Benoît Grimard, a.-g\u201e 60036-o For the Deputy Minister.Parish of Sahil-Ilippolyte Official cadastre of the parish of Saint-Hippolyle.municipality of Shawbridge *.registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lot 18B-15 of range V township of Abercrombie is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 30, 1975.Benoît Grimard, a.-g.60036-o For the Deputy Minister.Parish of Saint-Jérôme Official cadastre of the parish of Saint-Jérôme, municipality of Shawbridge *.registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lot 309-18 is cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 27.1975.Benoît Grimard, a.-c;., 80036-0 For the Deputy Mi nister.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard.a.-g. GAZETTE OIT-ICI ELLE DU QUÊIIEC.j> férrier 7975, 707' amife, 11° 8 1671 Paroisse de Saint-Aiitoine-de-Longueiiil Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Antoinc-dc-Longueuil.municipalité de la ville de Saint-Lambert, division d'enregistrement de Cbambly.Avis est par la présente donné que les lots 266-19 à 266-29.266-52 à 266-61.266-62 à 266-67.206-95 à 266-103.260-132 à 266-140.266-179 à 266-187.260-221 à 266-236.266-238 a 266-261.273-1 à 273-43.273-52 à 273-232, 273-225A.273-234 à 273-45S et la partie restante des lots 266-18, 266-30.206-50.266-51.266-68.266-93, 266-94.260-131.266-147, 266-178, 266-219, 266-220, 266-237 sont annulés en vertu de l'article 2174o du Code civil.Québec, le 27 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard.a.-g.Parish of Saiiit-Antoine-de-Longiieuil Official cadastre of the parish of Saint-Antoine-de-Longueuil.municipality of the town of Saint-Lambert, registration division of Cliambly.Notice is hereby given that lots 266-19 to 260-29, 260-52 to 206-61.260-62 to 206-67.266-95 to 266-103, 260-132 to 260-140.206-179 to 266-187.266-221 to 266-236.260-238 to 260-261.273-1 to 273-43.273-52 to 273-232, 273-225A.273-234 to 273-458 and that the remaining part of lots 266-18.266-30, 266-50, 266-51, 266-68.266-93, 266-94, 266-131.266-147.266-178, 200-219.266-220.266-237 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 27.1975.Benoît Grimard.a.-g., 00036-o For the Deputy Minister.Paroisse de Saiiit-Louis-de-Terrehoiine Cadastre officiel de la parooisse de Saint-Louis-de-Terrebonne.municipalité dc la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne, division d'enregistrement de Terrebonne.Avis est par la présente donné que les lots 570-3 à 570-68 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 30 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-e- Benoît Grimard.a.-g.Parish of Sainl-Louis-dc-Terreboniic Official cadastre of the parish of Saint-Louis-de-Terre-bonne.municipality of the parish of Saint-Louis-de-Terrcbonne.registration division of Terrebonne.Notice is hereby given that lots 570-3 to 570-68 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 30, 1975.Benoît Grimard.a.-g.60036-o For the Deputy Minister.Paroisse de Sainte-Marie (revisé) Cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Marie (revisé), municipalité de la ville de Sainte-Marie, division d'enregistrement de Beauce.Avis est par la présente donné que les lots 1127 et 1128 sont ajoutés et que les lots 508-1-1.508-3.508-8.517-1-1.518.519 et qu'une partie des lots 517-2.50S-1, 517-1, 508.517 sont annulés en vertu de l'article 2174a du Code civil.Québec, le 9 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard.a.-g.Parish of Sainte-Marie (revised) Official cadastre of I he parish of Sainte-Marie (revised), municipality of the town of Sainte-Marie, registration division of Beauce.Notice is herebv given that lots 1127 and 1128 are added and that lots 508-1-1.508-3.508-8.517-1-1, 518, 519 and that a part of lots 517-2, 508-1.517-1.50S.517 arc cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 9.1975.Benoît Grimard, a.-g., 00036-o For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Maurice Cadastre officiel dc la paroisse de Saint-Maurice, municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-France, division d'enregistrement de Champlain.Avis est par la présente donné que les lots 287-2 à 287-4 sont annulés en vertu dc l'article 2174a du ('ode civil.Québec, le 30 janvier 1975.Parish of Saint-Maurice Official cadastre of the parish of Saint-Maurice, municipality of the parish of Saint-Louis-de-Franee, registration division of Champlain.Notice is hereby given that lots 287-2 to 287-4 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec, January 30, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard, a.-g. 1672 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February t«.7975, Vol.107, No.8 Paroisse de Saint-Philippe Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Philippe, municipalité de la paroisse de Saint-Philippe, division d'enregistrement île Laprairie.Avis est par la présente donné qu'une partie du lot 171 est annulée et intégrée au lot 391 en vertu des articles 2174 et 2174a du Code civil.Québec, le 28 janvier 1975.Pour le sous-ministre.60036-o Benoît Grimard.a.-g.Parish of Saint-Philippe Official cadastre of the parish of Saint-Philippe, municipality of the parish of Saint-Philippe, registration division of Laprairie.Notice is hereby given that a part of lot 171 is cancelled and integrated in lot 391 in virtue of articles 2174 and 2174a of the Civil Code.Québec, January 28, 1975.Benoît Ghimard, a.-g.60036-o For the Deputy Minister.Paroisse de Saint-Sauveur Cadastre officiel de la paroisse de Saint-Sauveur, municipalité de la ville de Québec, division d'enregistrement de Québec.Avis est par la présente donné qu'une partie des lots 2368-A-32-1.2368-37-1 sont annulées en vertu de l'article 2174a du ('ode civil.Québec, le 24 janvier 1975.Pour le sous-ministre, 60036-o Benoît Grimard, a.-g.Parish of Saint-Sauveur Official cadastre of the parish of Saint-Sauveur, municipality of the town of Québec, registration division of Québec.Notice is hereby given that a part of lots 2368-A-32-1, 2368-37-1 are cancelled in virtue of article 2174a of the Civil Code.Québec.January 24, 1975.Benoît Grimard, a.-g., 60036-o For the Deputy Minister.Changement de nom \u2014 Loi du Accordés Change of name \u2014 Act Granted Charles Adams Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 466 du 5 février 1975 d'effectuer le changement de nom de Charles Adamowiez en celui de Charles Adams.Québec, le 11 février 1975.Le sous-ministre de la justice.Robert Normand, c.r.60044-o Laurie Earl Colborne II a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 471 du 5 février 1975.d'effectuer le changement de nom de Laurie Earl Ferris en celui de Laurie Earl Colborne.Québec, le 11 février 1975.60044-n Le sous-ministre de la justice.Robert Normand, ch.Paul Côte Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 474 du 5 février 1975 d'effectuer le changement dc nom dc Paul Kotkiw (Kokiw) en celui de Paul Côté.Québec, le 11 février 1975.60014-o Le sous-ministre de la justice, Robert Normand, c.r.Charles Adams It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Charles Adamowicz to that of Charles Adams, by order number 466.dated Februarv 5, 1975.Québec.February 11, 1975.Robert Normand, q.c, 60044 Deputy Minister of Justice.Laurie Earl Colborne It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Laurie Earl Ferris to that of Laurie Earl Colborne.by order number 471, dated February 5.1975.Québec.February 11, 1975.60044 Robert Normand, q.c.Deputy Minister of Justice.Paul Côté It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Paul Kotkiw (Kokiw) to that of Paul Côté, by order number 474, dated Februarv 5, 1975.Québec, l'ebrucry 11, 1975.Robert Normand, q.c, 60044 Deputy Minister of Justice. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975.107' année, n° S 1673 .Michael Alexander Florian Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil par le décret numéro 472 du 5 février 1975 d'effectuer le changement de nom de Michael Alexander Iosipovici en celui de Michael Alexander Florian.Québec, le 11 février 1975.Fa; sous-ministre de la justice.60044-O Robert Normand, c.r.Michael Alexander Florian It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Michael Alexander Iosipovici to that of Michael Alexander Florian.by order number 472.dated February 5.1975.Québec.February 11.1975.robert Normand, q.c, 60044 Deputy Minister of Justice.Patrick Maurice Forde Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 465 du 5 février 1975.d'effectuer le changement de nom dc Patrick Morris Fordc en celui de Patrick Maurice Forde.Québec, le 11 février 1975.Le mus-ministre de la justice.60044-o Robert Normand, c.r.Patrick Maurice Forde It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Patrick Morris Forde to that of Patrick Maurice Forde.by order number 465, dated February 5.1975.Québec February II.1975.Robert Normand, q.c, 60044 Deputy Minister of Justice.Barbara Gagne Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 468 du 5 février 1975, d'effectuer le changement de nom de Marie Ginette Jeanne Aimée Gagné en celui de Barbara Gagné.Québec, le 11 février 1975.Le sous-ministre de la justice.60044-o Robert Normand, c.r.Barbara Gagné It bas pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Ginette Jeanne Aimée Gagné to that of Barbara Gagné, by order number 468, dated February 5, 1975.Québec.February 11, 1975.Robert Normand.q .c, 60044 Deputy Minister of Justice.Selvin Cleophas Jordan Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 470 du 5 février 1975, d'effectuer le changement de nom de Selvin Cleophan Chandler en celui de Selvin Cleophas Jordan.Québec, le 11 février 1975.Le sous-ministre de la justice.60044-o Robert Normand, c.r.Selvin Cleophas Jordan It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Selvin Cleophan Chandler to that of Selvin Cleophas Jordan, by order number 470, dated February 5.1975.Québec.February 11.1975.Robert Normand, q.c, 60044 Deputy M inister of Justice.Joseph René Real Lecompte Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 467 du 5 février 1975 d'effectuer le changement de nom de Joseph-René-Réal Leroux en celui dc Joseph René Réal Lecompte.Québec, le 11 février 1975.Le sous-ministre dc la justice.60044-o Robert Normand, c.r.Joseph René Réal Lecompte It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-René-Réal Leroux to that of Joseph René Réal Lecompte.by order number 467.dated February 5.1975.Québec.Februray 11.1975.Robert Normand, q.c.60044 Deputy Minister of Justice.Joseph Michel Serge Lefebvre Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 469 du 5 février 1975.d'effectuer le changement dc nom de Joseph Michel Serge Dozois en celui de Joseph Michel Serge Lefebvre.Québec, le 11 février 1975.Joseph Michel Serge Lefebvre It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph Michel Serge Dozois to that of Joseph Michel Serge Lefebvre.by order number 469, dated February 5, 1975.Quebec.February 11.1975.60044-u Le sous-ministre de la justice.Robert Normand, en.60044 Robert Normand, q.c.Deputy Minister of Justice. 1674 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.February 1975.Vol.107.Xo.S Carmen Paquctle Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 473 du 5 février 1975.d'effectuer le changement de nom de Marie Pamméla Paquet en celui de Carmen Paquctte.Québec, le 11 février 1975.Le sous-ministre de la justice.60044-o Robert Normand, ch.Jean Richard Il a plu au lieutenant-gouverneur en conseil, par le décret numéro 464 du 5 février 1975 d'effectuer le changement dc nom de Joseph-Jean-Richard Krancoeur en celui de Jean Richard.Québec, le 11 février 1975.Le sous-ministre de la justice.60044-o Robert Normand, c.r.Changement de nom \u2014 Loi du Demandes Dragan Svarc Avis est donné que Dragan Svarc, médecin, domicilié et demeurant au numéro 5775, du boulevard Côte des Neiges, dans les ville et district de Montréal, province de Québec, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Emile Dragan Svarc.Montréal, le 22 janvier 1975.Le procureur du requérant, 59957-7-2-0 A.H.J.Zaiti.in, ch.Jean Paul Gauvin Avis vous est donné que Jean Paul Gauvin, administrateur, domicilié au 4202.rue Monsabré, à Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom en celui dc Gill Lortie, ledit changement de nom devant bénéficier à sa femme Carmen Monique [.edoux île la même adresse.Les procureurs du requérant.Morand.Plante & Charlebois.59979-7-2-0 notaires.Cécile Morin Brunelle Avis est donné que Dame Cécile Morin Hrunelle.ménagère, domiciliée et résidant au 1580 est.de la rue Sauvé, dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret lui permettant de changer le nom de sa fille mineure.Line Morin en celui de Line Brunelle de la même adresse, conformément à la Loi du changement dc nom.Montréal, le 14 janvier 1975.Les procureurs dc la requérante.59981-7-2-0 Rousseau & Charbonneav.Carmen Paquette It has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Marie Pamméla Paquet to that of Carmen Paquette, bv order number 473, dated February 5.1975.Quebec.February 11.1975.Robert Normand, q.c.60044 Deputy Minister of Justice.Jean Richard Is has pleased the Lieutenant-Governor in Council to change the name of Joseph-Jean-Richard Francoeur to that of Jean Richard, by order number 464, dated February 5.1975.Québec.February 11.1975.Robert Normand, q.c, 60044 Deputy Minister of Justice.Change of name \u2014 Act Applications Dragan Svarc Notice is hereby given that Dragan Svarc, physician, domiciled and residing at 5775 Côte des Neiges Road in the City and District of Montreal, Province of Québec, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec to obtain permission to change his name to Emile Dragan Svarc.Montreal.January 22nd.1975.A.H.J.Zaitlin, q.c, 59957-7-2-u Attorney for petitioner.Jean Paul Gauvin Notice is hereby given that Jean Paul Gauvin, administrator, residing at 4202 Monsabré Street, at Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to that of Gill Lortie.the said change of name to benefit his wife Carmen Monique Lcdoux of the same address.Morand, Plante & Charlebois, Notaries, 59979-7-2-0 Attorneys for the applicant.Cécile Morin Brunelle Notice is hereby given that Cécile Morin Brunelle, housekeeper, domiciled and residing at 1580 East, Sauvé Street, of the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for the passage of a decree changing the name of her minor girl Line Morin to Line Brunelle.from the same address, the whole pursuant to the Change of Name Act.Montreal, January 14.1975.Rousseau & Charbonneau, 59981 -7-2-o Attorneys for the petitioner. OMETTE OFFICIELLE DV QUÉBEC.>.! férrier 1075.107' année, h' S 1675 Marie-Claire Marie-Claire, ménagère, résidant et domiciliée au 434, boulevard Dorchester est.app.92.dans la ville et le district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec, afin d\"obtenir un décret lui permettant de changer son nom en celui de Marie-Claire May.Montréal, ce .\"> novembre 1974.Les procureurs de la requérante.59980-7-2-o Laforest & Bibeau.Paolo Arturi Vulcanis Avis est par les présentes donné que Paolo Arturi Vulcanis, résidant et domicilié au 2S13, YVilbrod.GifTard.district dc Québec, s'adressera au ministre de la justice pour obtenir un décret changeant son nom en celui de Paul Arturi.Ce changement n'affectera aucune autre personne que le requérant lui-même.Le procureur du requérant.60012-7-2-o Jean Dionne.notaire.Peter Iscovitch Avis est par les présentes donné que Peter Iscovitch.résidant au 5350, avenue MacDonald.app.1401.dans la cité de Côte-Saint-I.uc, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom en celui de Peter Covit, ledit changement de nom devant bénéficier à sa femme, Mme Tillie Braunstein Iscovitch et des enfants, Burt et Linda, résidant à l'adresse ci-haut mentionnée, et Dena Covit Gloubcrman, résidant au 241.rue Melville, dans la cité de Westmount.lesdits noms devant servir à toutes fins légales.Montréal, le 28 janvier, 1975.Les atocals du reqéurant.Orenstein, Ruby.59964-7-2-d Michelin.Okenstein.Hayik Dadiroglu Avis est donné que Hayik Dadiroglu.tailleur, demeurant au numéro 370, bout.Thomson, ville St-Laurent, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour le changement de son nom en celui dc Haïg Dadourian.Montréal, le 6 février.1975.Les procureurs du requérant, 60020-8-2-o Awada & Sumbulian.Ara Dadiroglu Avis est donné que Ara Dadiroglu, étudiant, demeurant au numéro 370, boul.Thomson, ville St-Laurent, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour le changement dc son nom en celui de Alan Dadourian.Montréal, le 6 février, 1975.Les procureurs du requérant, 60021-8-2-o Awada & Sumbulian.Marie-Claire Marie-Claire, housekeeper, residing and domiciled at 434 Dorchester Boulevard east.Apt.92.in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec, for an order changing her name to that of Marie-Claire May.Montreal.November 5th, 1974.Laforest & Bibeau.59980-7-2-0 Attorney for petitioner.Paolo Vrturi Vulcanis Notice is hereby given that Paolo Arturi Vulcanis, residing and domiciled at 2813 YVilbrod.Giffard.District of Québec, will apply to the Minister of Justice for an order changing his name to Paul Arturi.This change will not affect any person other than the applicant.Jean Dionne, notary.60012-7-2-o Attorney for the applicant.Peter Iscovitch Notice is hereby given that Peter Iscovitch.residing at 5350 MacDonald Avenue.Apt.1401.in the City of Côte-Saint-Luc, district of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for an order changing his name to that of Peter Covit, said change of name to also benefit his wife.Mrs.Tillie Braunstein Iscovitch and their children, Burt and Linda residing at the above address, and Dena Covit Glouberman, residing at 241 Melville Avenue, Westmount, said names to be used for all legal purposes.Montreal, January 28th, 1975.Orenstein, Ruby, Michelin, Orenstein, 59964-7-2-c Attorneys for petitioner.11,1% ik Dadiroglu Notice is given that Hayik Dadiroglu, tailor, residing at number 370 Thomson Blvd.City of St.Laurent, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to change his name to Haïg Dadourian.Montreal.February 6, 1975.Aw a da & Sumbulian.60020-8-2-o Attorneys for applicant.Ara Dadiroglu Notice is given that Ara Dadiroglu, student, residing at number 370 Thomson Blvd., City of St.Laurent, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to change his name to Alan Dadourian.Montreal.February 6.1975.Awada & Sumbulian.60021 -S-2-o .Utorueys for applicant. 1676 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February S3, 1975, Vol, 107, Ko.S Joseph, Théophile, Wenceslas Savard Avis est donné que Joseph, Théophile, Wenceslas Savard.journalier, époux de Marie-Anna Poirier, domicilié au numéro 170.Rochefort.Cap-de-la-Madeleine, district de Trois-Rivières, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'obtention d'un décret changeant son nom en celui de Joseph, Théophile, Wenceslas Paul Savard.Trois-Rivières.ce 7e jour de février 1975.Les procureurs du requérant.Langevin.Vigeant.60022-8-2-o Ayotte & Crête.Claire Bonhomme Avis est par les présentes donné que Claire Bonhomme, résidant au 10520.rue Berri, à Montréal, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil, pour l'adoption d'un décret changeant son nom en celui de Claire Bernard et le nom dc famille des enfants mineurs: Lucie, Paul-David et Joanne, tous résidant au 10520.rue Berri, à Montréal, district dc Montréal, en celui de Bernard, lesdits nems pour servir à toutes fins légales.Montréal, le 6 février 1975.Les procureurs de la requérante, 60052-S-2-o Rouleau & McLaughlin, avocats.Marie, Ginette, Louise Branchaud Avis est donné que Marie, Ginette, I,ouise Branchaud, secrétaire, domiciliée au 3422.Pontoise, Trois-Rivières-Ouest, district de Trois-Rivières, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'obtention d'un décret changeant son nom en celui de Marie, Ginette, Lise Branchaud.Trois-Rivières.ce 12 février 1975.Les procureurs de la requérante.Langevin, Vigeant, 60053-8-2-o Ayotte & Crête.Dorina Brassard Avis est par les présentes donné que Dorina Brassard, résidant au 68, St-.Ioseph ouest, Chicoutimi, district de Chicoutimi, demandera au lieutenant-gouverneur en conseil l'adoption d'un décret pour changer son nom en celui de Lise Brassard.Ce changement n'affectera aucune autre personne que la requérante elle-même.Les procureurs de la requérante.Roy, Vaili.ancourt, Diciiesne & Pérk.ny.60054-8-2-o John P.Diamantopoulos Prenez avis que John P.Diamantopoulos.résidant et domicilié au 12020.rue Désy, à Montréal-Nord, district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil afin d'obtenir un décret changeant son nom patronymique en celui de Diamond.Les procureurs du requérant, 60055-8-2-o Kozina, Lefebvre & Savard.Joseph, Théophile, Wenceslas Savard Notice is hereby given that Joseph.Théophile, Wenceslas Savard.labourer, husband of Marie-Anna Poirier, residing at number 170 Rochefort, Cap-de-la-Madeleine, District of Trois-Rivières, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing his name to Joseph, Théophile, Wenceslas Paul Savard.Trois-Rivières, this 7th day of February, 1975.Langevin, Vigeant.Ayotte & Crête, 60022-8-2-o Attorneys for petitioner.Claire Bonhomme Notice is hereby given that Claire Bonhomme, residing at 10520 Berri Street, in Montreal, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council of the Province of Québec for adoption of an order changing her name to that of Claire Bernard and the surname of her minor children: Lucie, Paul-David and Joanne, all residing at 10520 Berri Street, in Montreal, District of Montreal, to that of Bernard the name to avail for all legal purposes.Montreal, February 6, 1975.Rouleau & McLaughlin, lawyers, 60052-S-2-o Attorneys for the applicant.Marie, Ginette, Louise Branchaud Notice is hereby given that Marie, Ginette, Louise Branchaud, secretary, residing at 3422 Pontoise, Trois-Rivières-West.District of Trois-Rivières, will apply to the Lieutenant-Governor in Council, for an order changing her name to Mane.Ginette, Lise Branchaud.Trois-Rivières.February 12th.1975.Langevin, Vigeant.Ayotte & Crête, 60053-8-2-o Attorneys for petitioner.Dorina Brassard Notice is hereby given that Dorina Brassard, residing at 68 West, Saint-Joseph Street, Chicoutimi, District of Chicoutimi, will apply to the Lieutenant-Governor in Council for permission to change his name to Lise Brassard.This change will not affect any person other than the applicant.Roy, Yaillancourt, Duchesne & Pébigny, Attorneys for applicant.60054-S-2-o \u2022 John P.Diamantopoulos Notice is hereby given that John P.Diamantopoulos, residing and domiciled at 12020 Désy Street, Montreal-North, District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain a decree changing his patronymic name to that of Diamond.Kozina, Lefebvre & Savard, 60055-8-2-o Attorneys for the applicant. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 flirter 1975.107' année, n S 1677 Michelle Christiane Journois Avis est donné par les présentes que Michelle Christiane .Tournois, femme de chambre, domiciliée au 3250.Forest Hill, dans la ville de Montréal, district de Montréal, a l'intention de présenter une demande au ministre de la justice en vue d'obtenir un décret changeant son nom de Michelle Christiane Journois en celui de Michèle Sara Frcnkel.Le procureur du requérant, 60056-8-2-o Marc Ian Leiteh.Joseph, François Millette Avis est donné que Joseph, François Millette.journalier, domicilié au 1997, Royale, des cité et district de Trois-Rivières, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour l'obtention d'un décret changeant son nom en celui de René Noël.Trois-Rivières, ce lie jour de février 1975.Les procureurs du requérant, Langevix.Vigeant, Ayotte 60057-8-2-o & Crête.Michelle Christiane Journois Notice is hereby given that Michelle Christiane Journois, stewardess, of the City and District of Montreal and therein domiciled and residing at 3250 Forest Hill, will present a petition to the Minister of Justice, for an order changing her name from Michelle Christiane Journois.to that of Michèle Sara Frenkel.60056-8-2-o Marc Ian Leiteh.Attorney for petitioner.Joseph.François Millette Notice is hereby given that Joseph, François Millette, journeyman, residing at 1997 Royale, in the City and District of Trois-Rivières.will apply to the Lieutenant-Governor in Council for an order changing his name to René Noël.Trois-Rivières.this 11th day of February, 1975.Langevin, Vigeant.Ayotte & Crête, 60057-8-2-o Attorneys for petitioner.Jean-Pierre Molina Nous donnons avis que Jean-Pierre Molina, représentant de commerce, domicilié et résidant au 1855.du Havre, appartement 1218.dans les ville et district de Montréal, s'adressera au lieutenant-gouverneur en conseil pour obtenir un décret changeant son nom pour celui de Jean-Pierre de Préjentil.Le procureur du requérant, 60058-8-2-o Jeanne-Michelle Toulet.Jean-Pierre .Molina Notice is hereby given that Jean-Pierre Molina, sales representative, domiciled at 1855 du Havre, apartment 1218, in the City and District of Montreal, will apply to the Lieutenant-Governor in Council to obtain an order changing his name to Jean-Pierre de Préjentil.Jeanne-Michelle Toulet.60058-8-2-o Attorney for the applicant.Demandes à la Législature Applications to Legislature Ville de Trois-Rivières Ouest Avis est par les présentes donné que la Ville de Trois-Rivières Ouest s'adressera lors de la prochaine session législative à l'Assemblée Nationale pour qu'une loi soit adoptée dans le but de lui permettre de verser une pension annuelle de $2,000 à l'ancien directeur de son Service des Incendies.M.1.Ëmilien Launier, sa vie durant.Les procureurs de la requérante, Chartier, Ménard, 59859-5-4-0 Gourdeau & Godin.Town of Trois-Rivières West Notice is hereby given that the Town of Trois-Rivières West, will apply to the National Assembly, at its next session, for the adoption of an act granting it the power to pay an annual pension of $2.000 to Mr.J.Emilien Launier, the former director of its Fire Department, during his lifetime.Chartier, Ménard, Gourdeau & Godin.59859-5-4-0 Attorneys for the petitioner.Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthe Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthe fait savoir qu'elle s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, au cours dc la prochaine session, pour demander sa dissolution.Janvier 1975.Les procureurs de la pétitionnaire.Geoffrion, Prud'homme, Chevrier.Cardinal, Mahchessault, 59801-5-4-o Mercier & Greenstëin.Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthe Notice is hereby given that Hôpital Saint-Charles de St-Hyacinthe will apply to the National Assembly of Québec, to ask for its dissolution.January 1975.Geoffrion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marciikssault, Mercier & Greenstëin, 59801-5-4-o Attorneys for the petitioner. 167S Ql'ÊIIEt OFFICIAL GAZETTE.February j>.197».Vol.107.Xo.8 Hôpital Général Saint-Vincent de Paid de Sherbrooke Hôpital General Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke fait savoir qu'elle s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, au cours de la prochaine session, pour demander sa dissolution.Janvier 1975.Les procureurs de la pétitionnaire.Geoffrion, Prud'homme.Chevrier, Cardinal, Marchessault.59802-5-4-o Mercier & Greenstëin.Séminaire de Sainte-Thérèse Le Séminaire de Sainte-Thérèse concernant la fondation des bourses d'étude Curé Louis-Aldéric Desjardins.Le Séminaire dc Sainte-Thérèse s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec au cours de la prochaine session pour faire adopter une loi modifiant les clauses de la fondation des bourses d'études constituée par le curé Louis-Aldéric Desjardins aux termes d'actes dc donation et transport, testament et codicille, entre autres en augmentant le montant des bourses et en permettant le versement des bourses aux bénéficiaires désignés recevant leur instruction dans toute institution catholique privée d'enseignement secondaire ou collégial de la Province.Le 3 février 1975.1m procureurs de la pétitionnaire, Geofrion, Prud'homme.Chevrier, Cardinal, Marchessault.Mercier 59975-7-4-0 & Greenstëin.Hôpital Saint-Joseph de Granit} Hôpital Saint-Joseph dc Granby fait savoir qu'elle s'adressera à l'Assemblée Nationale du Québec, au cours de la prochaine session, pour demander sa dissolution.Janvier 1975.Les procureurs de la pétitionnaire.Geoffrion.Prud'homme.Chevrier, Cardinal, Marchessault.59803-5-4-o Mercier & Greenstëin.Office Municipal d'Habitation dc St-Nicéphore Avis est donné que l'Office Municipal d'Habitation de St-Nicéphore dépose au Secrétariat des Commissions de l'Assemblée nationale un projet de loi pour annuler la condition d'utilisation de l'immeuble qui a fait l'objet de l'acte de donation du 4 août 1914 intervenu entre Pierre et Tréfilé Raymond et la Corporation Episcopate Catholique Romaine dc Nicolct.acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Drummond sous le numéro 47935-11-01.cette condition étant, spécialement annulée quant au lot 224-31 du cadastre du canton de Wickham.Les procureurs de l'Office Municipal d'Habitation de St-Nicéphore.00083-8-4-o BinoN et Bibok.Hôpital Général Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke Notice is hereby given that Hôpital Général Saint-Vincent de Paul «le Sherbrooke will apply to the National Assembly of Quebec, to ask for its dissolution.January 1975.Geoffhion, Prud'homme.Chevrier, Cardinal.Marchessault, Mercier & Greenstëin, 59802-5-4-u Attorneys for the petitioner.Seminary of St.Thérèse The Seminary of St.Thérèse in relation to the Curé Louis-Aldéric Desjardins Scholarships foundation.Notice is given that Seminary of St.Thérèse will apply to the National Assembly of Québec at the next session for the adoption of an act to modify the terms of the Scholarships Foundation of Curé Louis-Aldéric Desjardins as established in deeds of gifts, transfer, will and codicil, by providing amongst other tilings, for an increase in the amount of scholarships and by allowing said scholarships to be paid to the designated beneficiaries attending any private catholic schools in the Province at the secondary or college level.The 3rd of February 1975.Geoffhion, Prud'homme, Chevrier, Cardinal, Marchessault, Mehcier & Greenstëin, 59975-7-4-0 Attorneys for the petitioner.Hôpital Saint-Joseph de Granby Notice is hereby given that Hôpital Saint-Joseph de Granby will apply to the National Assembly of Québec, to ask for its dissolution.January 1975.Geoffhion, Prud'homme.Chevrier.Cardinal, Marchessault.Mercier & Greenstëin.59803-5-4-o Attorneys for the petitioner.Municipal Housing Corporation of St-Nicéphore Notice is given that the Municipal Housing Cor-ixiration of St-Nicéphore is filing with the Secretariat of Committees of the National Assembly a petition in order to obtain a bill to annul the restriction pertaining to the use of an immoveable which was the object of a deed of gift inter vivos dated August.4th.1914.entered into by the Corporation Episcopate Catholique Romaine de Nicolet and Pierre and Trcfflé Raymond, and rc-gistered at the Office of the Registration Division of Drummond under number 47935-15-01.The restriction to be annulled by said bill is to affect lot number 224-31 of Hie cadastre of the Township of Wickham.H iron et 151 ron, Attorneys for the Municipal Housing 00083-8-4-o Corporation of St-Nicéphore. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.£> février 1975.107' année, 11° S 1679 LA SOCIETE D'ASSURANCE DES CAISSES POPULAIRES Avis est, par les présentes, donné que « LA SOCIETE D'ASSURANCE DES CAISSES POPULAIRES », ayant son siège social en la ville de Lévis, s'adressera à l'Assemblée nationale du Québec, afin de demander l'adoption d'une loi modifiant sa charte, la Loi relative à La Société d'Assurance des Caisses Populaires (1960-61, chapitre 157).à l'effet de (i) lui permettre de recevoir de nouvelles contributions des caisses populaires Desjardins pour augmenter son fonds de réserve, (ii) modifier le taux d'intérêt qu'elle peut payer sur les contributions des caisses populaires Desjardins et (iii) la soustraire de l'application des articles 183 et 185 de la Loi des Assurances en plus de ceux déjà prévus à sa charte.Donné à Lévis, le 10 février 1975.Les procureurs de la requérante.desjardins, Dl charme, desjardins.60019-8-4-o Tellier.Zigby & MlCHAUD.LA SOCIETE D'ASSURANCE DES CAISSES POPULAIRES Notice is hereby given that \"LA SOCIETE D'ASSURANCE DES CAISSES POPULAIRES\", having its head office in the City of Levis, will apply to the Québec National Assembly, for the passing of a bill amending its charter, the Act respecting La Société d'Assurance des Caisses Populaires (1960-61, chapter 157), for the purpose of (i) authorizing the said corporation to receive additional contributions from credit unions (Caisses populaires Desjardins) to increase its reserve fund, (ii) amending the rate of interest that may be paid on the contributions of credit unions and (iii) preventing the application of sections 183 and 185 of the Insurance Act to the said corporation in addition to the sections already provided in its charter.(îiven at Levis, on February 10, 1975.Desjahdins, Ducharme.Desjardins, Tellier, Zioby & Miciiauo, 60019-8-4-o Attorneys for the petitioner.Liquidation \u2014 Loi de la LA COOPERATIVE DE TRANSPORT D'ECOLIERS ABENAKIS (Loi des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de l'association coopérative « LA COOPERATIVE DE TRANSPORT D'ECOLIERS ABENAKIS », tenue à St-Prosper, dans le district électoral de Beauce-Sud.le 3 février 1975.il a été résolu dc liquider lu coopérative et qu'elle soit dissoute, ce conformément aux dispositions de la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.Laurent Larivière soit nommé liquidateur.Le sous-ministre des institutions financières.compagnies et coopératives, 60045-o Albert Jessop.CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE BUCKINGHAM (Loi des associations coopératives) Avis est donné que lors d'une assemblée générale spéciale des membres de l'association coopérative « CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE BUCKINGHAM », tenue à Buckingham, dans le district électoral de Papineau, le 14 octobre 1974.il a été résolu de liquider la coopérative et qu'elle soit dissoute, ce conformément aux dispositions dc la Loi des associations coopératives et de la Loi de la liquidation des compagnies, et que M.lean-Pierre Trudel soit nommé liquidateur.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.60046-o Albert Jessop.Wïnding-Up Act LA COOPERATIVE DE TRANSPORT D'ECOLIERS ABENAKIS (Cooperative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the members of \"LA COOPERATIVE DE TRANS.PORT D'ECOLIERS ABENAKIS\".held in Saint-Prosper, in the Electoral District of Beauce-South, on February 3, 1975.it was resolved that his cooperative association be wound-up and that it l>e dissolved, the foregoing in conformity with the provisions of the Cooperative Associations Act and of the Win ding-Up Act.and that Mr.Laurent Larivière be appointed liquidator.Albert Jessop.Deputy Minister of Financial Institutions.60045 Companies and Cooperatives.CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE BUCKINGHAM (Cooperative Associations Act) Notice is given that at a special general meeting of the meml>ers of \"CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE BUCKINGHAM\", held in Buckingham, in the Electoral District of Papineau, on October 14, 1974, it was resolved that this cooperative association be wound-up and that it be dissolved, the foregoing in conformity with the provisions of the Cooperative Associations Act and of the Winding-Up Act, and that Mr.Jean-Pierre Trudel be appointed liquidator.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60046 Companies and Cooperatives. 1680 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22.1975, Vol.107, No.8 Curatelle publique Public Curatorship Succession Jules L'Heureux Succession de L'Heureux.Jules, en son vivant de S6, rue Cabana, Magog, décédé le 24 octobre 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, cliap.81).qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve dc toute réclamation contre elle.Le Curateur public nu Québec.9310, boul.St-Laurcnt, Montréal 354, H2N 1X6 60070-o Succession Jeannette Goosscns Succession de Goossens, Jeannette, en son vivant de Montréal, décédée le 31 janvier 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurent, Montréal 354, H2N 1N8 60078-o Succession Alexis Hunchar Succession de Hunchar, Alexis, en son vivant de Berthierville, décédé le 10 février 1974.Le soussigné donne avis, conformément à la I.oi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.SI), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la sjecession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal 354, H2X IN6 60079-o Succession Fernand Pigeon Succession de Pigeon, Fernand, en son vivant de 32, rue Briggs est.Longueuil, décédé le 7 novembre 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81).qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Lk Curateur public du Québec 9310, boni.St-Laurcnt.Montreal 354, H2N 1X6 60081 -o Estate of Jules L'Heureux Estate of the late L'Heureux, Jules, in his lifetime of 86, Cabana Street, Magog, P.Q.deceased October 24, 1974.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-offieio curator to such estate, and he will receive, at the address given below payment of any debt owed this estaic and proof of anv claim against it.The Public Curator of Québec 9310 St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2X 1X6 60070-o Estate of Jeannette Goossens Estate of the late Goossens, Jeannette, in her lifetime of Montreal, deceased on January 31st, 1973.The undersigned hereby gives notice, in conformity with the Public Curatorship Act (S.Q.1971.ch.SI), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd.Montreal 354, H2X 1X6 60078-u Estate of Alexis Hunchar Estate of the late Hunchar, Alexis, in bis lifetime of Berthierville, deceased on February 10, 1974.The undersigned hereby gives notice, in conformity, with the Public Curatorship Act (S.Q.1971.ch.81), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Cuhatoh of Québec 9310.St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2X 1X6 60079 Estate of Fernand Pigeon Estate of the late Pigeon, Fernand, in bis lifetime of 32 Briggs Street East, Longueuil, P.Q., deceased November 7th, 1973.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, ami he will receive, at (headdress given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec 9310 St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2N 1N6 60081-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S3 février 1975.107' année, n° 8 1681 Succession John MacMahon Succession de MacMahon, John, en son vivant de 12183, rue Parent, Pointe-aux-Trembles, décédé le 1er juin 1970.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent, Montréal 354 (Que.), H2N 1N6 60023-o Estate of John MacMahon Estate of John MacMahon, during his lifetime of 12183 Parent Street, Pointe-aux-Trembles, who died on June 1, 1970.Under the authority of the Public Curatorship Act, (Statutes of Québec, 1971, Chapter 81).the undersigned gives notice that he is curator ex officio to this estate and that he will receive payment of any debt owing to this estate and will evidence any claim against said estate at the address given below.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd., Montreal 354 (Que.), H2N 1N6 60023 Succession Marie-Laure Mayer Succession de Mayer, Marie-Laure, en son vivant «le Montréal, décédéc le 3 mai 1973.Sous l'empire «le la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre clic.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal 354, H2X 1X6 60080-o Estate of Marie-Laure Mayer Estate of the late Mayer, Marie-Laure, in her lifetime of Montreal, deceased on May 3rd, 1973.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter SI of the Québec Statutes 1971).the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2X 1X6 6OO8O-0 Succession Violette-Maud Porter Succession dc Porter, Violette-Maud, en son vivant de Montréal, décédée, le 7 avril 1973.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve dc toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal 354, H2X 1X6 600S2-o Estate of Violette-Maud Porter Estate of the late Porter, Violette-Maud, in her lifetime of Montreal, deceased on April 7, 1973.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310, St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2X 1X6 60082-o Succession Georges Baker Succession de Baker, Georges, en son vivant de Montréal, décédé le 9 juillet 1974.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310, boul.St-Laurent.Montréal 354, H2N 1N6 60072-o Estate of Georges Baker Estate of the late Baker, Georges, in his lifetime of Montreal, deceased on July 9, 1974.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, al the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd.Montreal 354, H2N 1X6 60072-o 1682 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February 1975.Vol.107, Xo.8 Succession Edouard Claing Succession dc Claing.Edouard, en son vivant de Montréal, décédé le 3 septembre 1973.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971.chap.81), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous.\\ç paiement dc toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le curateur public 111' Ql'kbec.9310.boul.St-Laurent.Montréal 354.H2N 1N6 00073-o Estate of Edouard Claing Estate of the late Claing.Edouard, in his lifetime of Montreal, tleceased on September 3rd.1973.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter SI of the Quebec Statutes 1971).the undersigned hereby gives notice that he is éx-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.Tue Public Curator of Québec, 9310 St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2N\" 1N6 60073-o Succession Joseph Denis Succession dc Denis.Joseph, en son vivant de Montréal, décédé le 27 avril 1973.Sous l'empire de la Loi île la curatelle publique (L.Q.1971.chap.SI), le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec.9310.boul.St-Laurent.Montréal 354, H2X 1X6 60074-o Estate of Joseph Denis Estate of the late Denis.Joseph, in bis lifetime of Montreal, deceased on April 27, 1973.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).the undersigned hereby gives notice that he is ex-officw curator to such estate, and he will receive, at the address given below, payment cf any debt owed this estate anil prcof of any claim against it.The Public Curator of Québec 9310 St.Laurent Blvd.Montreal 354, H2X 1X6 60074-o Succession Marie-Rose Duplessis Succession de Duplessis.Marie-Rose, en son vivant de Montréal, décédée le 2 septembre 1974.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971.chap.81).le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve dc toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec 9310, boul.St-Laurent.Montréal 354.H2X 1X6 60075-o Estate of Marie-Rose Duplessis Estate of the late Duplessis, Marie-Rose, in her lifetime of Montreal, deceased on September 2nd, 1974.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971).the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec.9310 St.Laurent Blvd.Montreal 354.H2X 1X6 60075-o Succession Paul Eiglar Succession de Figlar, Paul, en son vivant du comté dc Terrebonne, décédé le 24 avril 1974.Sous l'empire de la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971.ehap.81).le soussigné donne avis qu'il est curateur d'office à cette succession, et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement île toute dette envers la succession et la.preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec 9310.boul.St-Laurcnt.Montréal 354.H2X 1X6 60076-o Estate of Paul Figlar Estate of the late Figlar.Paul, in his lifetime of County of Terrebonne, deceased on April 24.1974.Under the authority of the Public Curatorship Act (Chapter 81 of the Québec Statutes 1971), the undersigned hereby gives notice that he is ex-officio curator to such estate, and he will receive, at the address given below, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec 9310 St.Laurent Blvd.Montreal 354.H2X 1X6 60076-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février mo, 107¦ année, n° 8 1683 Succession Leslie Gergely Succession de Gergely, Leslie, en son vivant de Montréal, décédée le 12 avril 1973.Le soussigné donne avis, conformément à la Loi de la curatelle publique (L.Q.1971, chap.81), qu'il est curateur d'office à cette succession et qu'il recevra, à l'adresse ci-dessous, le paiement de toute dette envers la succession et la preuve de toute réclamation contre elle.Le Curateur public du Québec 9310, boul.St-Laurent, Montréal 354, H2N 1N6 60077-o Estate of Leslie Gergely Estate of the late Gergely, Leslie, in her lifetime of Montreal, deceased on April 12, 1973.The undersigned hereby gives notice, in conformity with the Public Curatorship Act (S.Q.1971, ch.81), that he is ex-officio curator to such estate and that he will receive, at the following address, payment of any debt owed this estate and proof of any claim against it.The Public Curator of Québec 9310 St.Laurent Blvd., Montreal 354, H2N 1N6 60077-o Divers Compagnies Miscellaneous Companies CUSTOM BUILT HOMES CORPORATION Conformément à l'article 90 de la Loi des compagnies, un sommaire du Règlement treizième de « CUSTOM BUILT HOMES CORPORATION » fait suite; essentiellement, le règlement autorise la dissolution de la compagnie, l'abandon de sa charte, la cessation des affaires au 30 novembre 1974 et, après paiement de ses dettes, la distribution proportionnelle du reste de ses actifs entre ses actionnaires.Montréal, Que., le 16 décembre 1974.(Sceau ) Le secrétaire, 60092-o F.C.Cope.CUSTOM BUILT HOMES CORPORATION Pursuant to Section 90 of the Companies Act the following is a summary of By-law Thirteen of \"CUSTOM BUn.T HOMES CORPORATION\" which by-law may be summarized as authorizing the dissolution of the company, the surrender of its charter, the cessation of business as of November 30, 1974, and, after payment of its liabilities, the distribution of its remaining assets rateably amongst its shareholders.Montreal, P.Q., December 16, 1974.(Seal) F.C.Cope, 60092-o Secretary.HOME OWNERS CORPORATION Conformément à l'article 90 de la Loi des compagnies, un sommaire du Règlement dix-septième de « HOME OWNERS CORPORATION » fait suite; essentiellement, le règlement autorise la dissolution de la comp-pagnie, l'abandon de sa charte, la cessation des affaires au 30 novembre 1974 et, après paiement de ses dettes, la distribution proportionnelle du reste de ses actifs entre ses actionnaires.Montréal, Que., le 16 décembre 1974.(Sceau) Le secrétaire.60093-o F.C.Cope.HOME OWNERS CORPORATION Pursuant to Section 90 of the Companies Act the following is a summary of By-law Seventeen of \"HOME OWNERS CORPORATION\" which by-law may be summarized as authorizing the dissolution of the company, the surrender of its charter, the cessation of business as of November 30, 1974, and, after payment of its liabilities, the distribution of its remaining assets rateablv amongst its shareholders.Montreal, P.Q., December 16, 1974.(Seal) F.C.Cope, 60093-o Secretary.MORO INVESTMENTS LTD.Conformément à l'article 90 de la Ix>i des compagnies, un sommaire du Règlement dixième de « MORO INVESTMENTS LTD.» fait suite; essentiellement, le règlement autorise la dissolution de la compagnie, l'abandon de sa charte, la cessation des affaires au 30 novembre 1974 et, après paiement de ses dettes, la distribution proportionnelle du reste de ses actifs entre ses actionnaires.Montréal, Que., le 16 décembre 1974.(Sceau) Le secrétaire.60094-o F.C.Cope.MORO INVESTMENTS LTD.Pursuant to Section 90 of the Companies Act the following is a summary of By-law Ten of \"MORO INVESTMENTS LTD.\" which by-law may be summarized as authorizing the dissolution of the company, the surrender of its charter, the cessation of business as of November 30, 1974, and, after payment of its liabilities, the distribution of its remaining assets rateably amongst its shareholders.Montreal, P.Q., December 16, 1974.(Seal) F.C.Cope, 60094-o Secretary. 1684 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, A'o.8 MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION Conformément à l'article 90 de la Loi des compagnies, un sommaire du Règlement quatorzième de « MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION » fait suite; essentiellement, le règlement autorise la dissolution de la compagnie, l'abandon de sa charte, 1».cessation des affaires au 30 novembre 1974 et, après paiement de ses dettes, la distribution proportionnelle du reste de ses actifs entre ses actionnaires.Montréal, Que., le 16 décembre 1974.(Sceau) Le secrétaire, 60095-o F.C.Cope.Pursuant to Section 90 of the Companies Act the following is a summary of By-law Fourteen of \"MOUNT ROYAL PROPERTY CORPORATION\" which by-law may be summarized as authorizing the dissolution of the company, the surrender of its charier, the cessation of business as of November 30, 1974, and, after pa.yment of its liabilities, the distribution of its remaining assets rateablv amongst its shareholders.Montreal, P.Q., December 16, 1974.(Seal) F.C.Cope, 60095-o Secretary.Services de santé et services sociaux \u2014 Loi sur Health Services and Social Services \u2014 Act on CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA VALLEE DE LA GATINEAU Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA VALLEE DE LA GATINEAU ».La catégorie à laq\"elle appartient cet établissement public est: « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ».I-e siège social de rétablissement est à Gracefield, district judiciaire de Hull.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopêratires, William Tf.tlev.60016-o 1360-4764 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA VALLEE DE LA GATINEAU The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting Health Services and Social Services, Statutes of 1971, chapter 4S, he has granted letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DE LA VALLEE DE LA GATINEAU\".This public establishment shall be classified as a \"LOCAL COMMUNITY SERVICE CENTRE\".The head office of said establishment is located in Gracefield, Judicial District of Hull.William Tetlev.Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60016 1360-4764 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DES PRES-BLEUS Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 39 et 47 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois 1971, il a accordé des lettres patentes instituant un établissement sous le nom de \u2022CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DES PRES-BLEUS ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES ».Le siège social de l'établissement est à Saint-Félicien, district judiciaire de Roberval.Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetlev.6OOI6-0 1360-4772 CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DES PRES-BLEUS The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to sections 39 and 47 of the Act respecting Health Services and Social Services, Statutes of 1971, chapter 48, he has granted letters patent incorporating an establishment under the name of \"CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DES PRES-BLEUS\".This public establishment shall be classified as a \"LOCAL COMMUNITY SERVICE CENTRE\"._ The head office of said establishment is located in Saint-Félicien, Judicial District of Roberval.William Tetlev, .1/inister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60016 1360-4772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1685 CENTRE HOSPITALIER DE CHANDLER Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu des articles 47, 82 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre 48 des lois de 1971, il a accordé des lettres patentes, en date du 22e jour de janvier 1975, fusionnant et convertissant « HOPITAL DE LA PROVIDENCE DE CHANDLER », constituée le 28 juin 1960 en vertu de la Loi modifiant la charte de la Communauté des Soeurs de Charité de la Providence, chapitre 176 des lois de 1958-1959 et « CORPORATION DE L'HOPITAL GENERAL DE CHANDLER *, constituée le 12 août 1964 en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, en un établissement public sous le nom dc « CENTRE HOSPITALIER_DE: CHANDLER ».La catégorie à laquelle appartient cet établissement public est: « CENTRE HOSPITALIER .Le siège social de l'établissement est à Chandler, district judiciaire de Gaspé.Le minisire des institutions financières, compagnies et coopératives, William Tetlev.60016-o 1360-7981 Avis divers LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DOMINIQUE-SAVIO Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés par l'article 16 de la Loi des fabriques, chapitre 76, des Statuts de 1965, déclare dissoute « LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DOMI-NIQUE-SAVIO », dans l'archidiocèse de Sherbrooke, cette dissolution devant prendre effet à compter du soixantième jour de la publication du présent avis dans la Gazette officielle du Québec.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60099-o LF: 1359-9600 Conseil No 6356-38 des Chevaliers de Colomb de St-Victor Avis est donné que le « Conseil No 6356-38 des Chevaliers de Colomb de St-Victor », rue des Écoliers, St-Victor, possède son siège social à l'adresse sus-mentionée et qu'il se prévaut des dispositions de la Loi concernant les Chevaliers de Colomb de la province de Québec (1-2 Elizabeth II, chap.134) à partir du 1er novembre 1974.St-Victor, le 1er novembre 1974.Le Grand Chevalier, André Roy.Le secrétaire-archiviste, Gérald Pouliot.60035-o 1358-8967 CENTRE HOSPITALIER DE CHANDLER The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that pursuant to sections 47, 82 and 83 of the Act respecting Health Services and Social Services, Statutes of 1971, chapter 48, he has granted letters patent, bearing date the 22nd day of January, 1975, amalgamating and converting \"HOPITAL DE LA PROVIDENCE DE CHANDLER\", incorporated on June 28, 1960, under the Act to amend the charter of the Communauté des Soeurs de Charité de la Providence, chapter 176 of the Statutes of 1958-1959 and \"CORPORATION DE L'HOPITAL GENERAL DE CHANDLER\", incorporated on August 12, 1964 under Part III of the Companies Act, into a public establishment under the name of \"CENTRE HOSPITALIER DE CHANDLER\".This public establishment shall be classified as \"HOSPITAL CENTRE\".The head office of said establishment is located in Chandler, Judicial District of Gaspé.William Tetley, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60016 1360-7981 Miscellaneous Notices LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DOMINIQUE-SAVIO The Minister of Financial Institutions, Ccmpanies and Cooperatives, according to the powers conferred upon him under section 16 of the Fabrique Act, Statutes of 1965, Chapter 76, declares \"LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DOMIN1QUE-SAVIO\" in the Archdiocese of Sherbrooke dissolved, said dissolution to take effect from the sixtieth day following the publication of this notice in the Québec Official Gazette.Albert Jessop, Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60099 LF: 1359-9600 Council No.6356-38 of the Knights of Columbus of St-Victor Notice is given that \"Council No.6356-38 of the Knights of Columbus of St-Victor\", des Écoliers Street, St-Victor, has its head office at the aforesaid address and that it avails itself of the provisions of the Act respecting the Knights of Columbus of the Province of Québec (1-2 Elizabeth II, Chapter 134) from November 1st, 1974.St-Victor, November 1st, 1974.André Roy, Grand Knight.Gerald Pooliot, Registrar.60035-o 1358-8967 1686 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 7.975, Vol.107, No.8 BURRGOLD MINES LIMITED Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis que le 28 janvier 1975, il a accordé à la compagnie « BURRGOLD MINES LIMITED », l'autorisation à vendre ou autrement aliéner, directement ou indirectement, dans la province de Québec, ses actions, son capital, ses certificats d'actions, obligations ou autres valeurs, conformément aux dispositions de la Loi de compagnies minières, Statuts refondus, 1964, chapiter 283.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.Peter Tymocko, 8825, boulevard Marie-Vic-torin, Tracy.Le bureau principal de la compagnie dans la province est établi au numéro 570, rue Townshend, Saint-Lambert, district judiciaire de Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et.coopératives, Albert Jessop.60016-o 1357-7960 BURRGOLD MINES LIMITED The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that on January 28, 1975, he granted to \"BURRGOLD MINES LIMITED\", authorisation to sell or otherwise alienate, directly in the Province of Québec, its shares, stock, stock'certificates, debentures and other se-cu-rities, in conformity with the Mining Companies Act, Revised Statutes, 1964, chapter 283.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said company is Mr Peter Tymocko, 8825 Marie-Victorin Boulevard, Tracy.The principal office of the company in the Province is located at 570 Townshend Street, Saint-Lambert, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60016 1357-7960 CENTRE DE PLEIN AIR ST-EDGAR Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 5e jour de février 1975, constituant en corporation sans capital-actions, les membres actuels de « CENTRE DE PLEIN AIR ST-EDGAR » déjà constituée en corporation le ou vers le 13 février 1974, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $500.000.Le siège sicial de la nouvelle corporation est à New-Richmond, district judiciaire de Bonaventure.Le directeur du sevice des compagnies, Pierre Desjardins.60016-o 1361-1165 CENTRE DE PLEIN AIR ST-EDGAR The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that under Part III of the Companies Act he has granted letters patent, bearing date the 5th day of February, 1975, incorporating as a corporation without share capital, the present members of \"CENTRE DE PLEIN AIR ST-EDGAR\", previously incorporated on or about February 13, 1974, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964.chapter 289).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $500,000.The head office of the new corporation is located in New-Richmond, Judicial District of Bonaventure.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.60016 1361-1165 CLUB D'AUTOS-NEIGE VAL-DAVIJ> Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis qu'en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, il a accordé des lettres patentes, en date du 14e jour de novembre 1974, constituant en corporation sans capital-actions, les membre actuels de « CLUB D'AUTOS-NEIGE VAL-DAVID », déjà constituée en corporation le 17 novembre 1967, en vertu de la Loi des clubs de récréation (Statuts refondus, 1964, chapitre 298).Le montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que la corporation peut acquérir et posséder est de $5,000.Le siège social dc la nouvelle corporation est à Val-David, district judiciaire de Terrebonne.L,e directeur du service des compagnies, PiERRe Desjardins.60016-o 740698 CLUB D'AUTOS-NEIGE VAL-DAVID The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives, gives notice that under Part III of the Companies Act he has granted letters patent, bearing date the 14th day of November, 1974, incorporating as a corporation without share capital, the present members of \"CLUB D'AUTOS-NEIGE VAL-DAVLD\", previously incorporated on November 17, 1967, under the Amusement Clubs Act (Revised Statutes, 1964, chapter 298).The amount to which the value of the immoveable property which the corporation may acquire and hold is to be limited, is $5,000.The head office of the new corporation is located in Val-David, Judicial District of Terrebonne.Pierre Desjardins, Director of the Companies Service.60016 740698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.S& février 1975, 10?' année, n\" S 1687 Municipalité du village de Saint-Jérôme et municipalité de la paroisse de Saint-Jérôme Avis est par les présentes donné que le conseil de la municipalité du village de Saint-Jérôme et le conseil de la municipalité de la paroisse de Saint-Jérôme ont adopté, à la majorité de leurs membres, des règlements, soit le règlement No 154 de la municipalité du village de Saint-Jérôme, et le règlement No 138 de la municipalité de la paroisse de Saint-Jérôme, autorisant ces municipalités à présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil pour fusionner les municipalités du village de St-Jérôme et de la paroisse de St-Jérôme.et créer la nouvelle municipalité de Ville de Métabet-chouan, aux conditions suivantes: a) Le nom de la nouvelle municipalité est « Ville de Métabetchouan » ; b) Le territoire de la nouvelle municipalité est celui déterminé par la description technique, en date du 21 janvier 1975, préparée par monsieur André Gendron, arpenteur-géomètre, et annexée à la présente pour en faire partie comme si elle était ici au long produite; c) La nouvelle municipalité est régie par la Loi des cités et villes; d) Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment de la fusion.Le quorum sera de huit (8) membres.Les deux maires actuels alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux (2) périodes égales qui couvriront le temps séparant la première assemblée et la date des premières élections.Le premier maire à exercer ce rôle sera déterminé lors de la première assemblée du conseil provisoire; e) La première assemblée du conseil provisoire sera tenue la deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes.Elle aura lieu à 20.00 heures, dans la salle du conseil de St-Jérôme; /) La première élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1975; g) La durée du mandat des membres du conseil est de quatre (4) ans.Les sièges de chacun des conseillers seront numérotés de un (1) à six (6), à compter de la première élection générale; h) Le territoire de la nouvelle ville sera divisé, pour la première élection générale, en six (6) quartiers portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6.La description technique de chacun des quartiers correspond à celle préparée par M.André Gendron, arpenteur-géomètre, en date du 21 janvier 1975 et présentée en annexe de la présente pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite; i) Il y aura une assemblée régulière du conseil permanent deux (2) fois par mois, soit les 1er et 3e lundi juridique de chaque mois; j) Le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité sera monsieur Jacques Gagné; k) Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités mentionnées dans la Municipality of the Village of Saint-Jérôme and Municipality of the Parish of Saint-Jérôme Notice is hereby given that the Municipal Council of the Village of Saint-Jérôme and the Municipal Council of the Parish of Saint-Jérôme have adopted, by the majority of their members, bylaws, namely bylaw No.154 of the Municipality of the Village of Saint-Jérôme, and bylaw No.138 of the Municipality of the Parish of Saint-Jérôme, authorizing these municipalities to present a petition to the Lieutenant-Governor in Council for the amalgamation of the Municipality of the Village of Saint-Jérôme and the Municipality of the Parish of Saint-Jérôme and for the creation of the new Municipality of the Town of Métabetchouan, under the following conditions: (a) The name of the new Municipality shall be \"Town of Métabetchouan\"; (6) The territory of the new Municipality shall be the one determined in the technical description, dated January 21, 1975, prepared by Mr.André Gendron, land-surveyor, and appended to these presents to form a part thereof, as if it was reproduced in full; (c) The new Municipality shall be governed by the Cities and Towns Act; (d) A provisional council shall be in office until the first general election.It shall be composed of all the members of the two councils existing at the time of the amalgamation.Eight (8) members shall constitute a quorum.The two mayors presently in office shall alternate as mayor of the Provisional Council for two (2) equal periods covering the period that will elapse between the date of the first meeting and that of the first election.The first mayor to hold office shall be appointed at the first meeting of the Provisional Council; (e) The first meeting of the Provisional Council will be held on the second juridical Monday following the coming into force of the letters patent.It will be held at 8:00 o'clock p.m., in the Council Room of Saint-Jérôme; (/) The first general election will be held on the first Sunday of November.1975; (g) The term of office of the members of the Council shall be of four (4) years.The seats shall be numbered from one (1) to six (6), as from the first general election; (A) For the first general election, the territory of the new Town shall be divided into six (6) wards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6.The technical description of each one of these wards shall be similar to the one prepared by Mr.André Gendron, land-surveyor, dated January 2i, 1975, and annexed to these presents to form a part thereof as if it were reproduced in full; (i) A regular meeting of the permanent Council shall be held twice (2) a month, namely on the 1st and 3rd juridical Mondays of each month; (j) The Secretary-Treasurer of the new Municipality shall be Mr.Jacques Gagné; (k) All the moveable and immoveable properties owned by each of the municipalities mentioned in the 1688 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 présente requête, deviendront propriété de la nouvelle municipalité; 1) L'actif et le passif des deux municipalités requérantes feront partie de l'actif et du passif de la nouvelle municipalité, y compris les surplus ou déficits accumulés qui seront à charge de la nouvelle municipalité; m) Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeureront en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés par la nouvelle municipalité; n) « Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les anciennes municipalités fusionnées sous la direction du greffier ou du secrétaire-trésorier dans les six (6) mois qui suivront la publication des lettres patentes.Toutes les pièces vieilles de moins de cinq (5) ans nécessaires à la bonne marche de la nouvelle municipalité y seront conservées.Quant aux autres pièces, seront confiées à la garde du Conservateur des Archives nationales du Québec celles qu'il aura jugées d'intérêt historique, et ce en vertu de la législation relative aux Archives nationales du Québec (lois du Québec, 1969, chap.26) »; o) Les taxes spéciales décrétées aux règlements No 148 du village de St-Jérôme et No 137 de la paroisse de St-Jérôme sont, pour l'avenir, imposées et seront prélevées sur tous les biens-fonds imposables desservis par le réseau d'aqueduc et d'égouts de la nouvelle municipalité selon leur valeur, tel qu'il appert du rôle d'évaluation en vigueur chaque année; cependant ces taxes spéciales ne seront prélevées qu'en cas d'insuffisance du tarif de compensation alors en vigueur dans la nouvelle municipalité; p) Les tarifs de compensation des services d'aqueduc et d'égouts devront être uniformisés à la grandeur de la nouvelle municipalité à partir du 1er janvier 1976.Les coûts relatifs à ces services devront être défrayés par les seuls usagers de ces services; g) Les taxes spéciales décrétées aux règlements Nos 149 et 153 du village de St-Jérôme sont, pour l'avenir, imposées et seront prélevées sur tous les biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité selon leur valeur, tel qu'il appert du rôle d'évaluation en vigueur chaque année; r) Les règlements No 147 du village de St-Jérôme et No 136 de la paroisse de St-Jérôme sont abrogés; s) Le service des vidanges sera payé à même la taxe foncière générale; t) Le taux de la taxe foncière générale, applicable au territore de chacune des municipalités au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, restera le même jusqu'au premier janvier 1976; present petition shall become the property of the new Municipality; (I) The assets and liabilities of the two petitioning municipalities shall form part of the assets and liabilities of the new Municipality, including the accumulated surpluses and deficits which shall become the responsibility of the new Municipality, (m) The bylaws, resolutions, minutes, valuation rolls, collection rolls and other instruments of each of the petitioning municipalities shall remain in force in the territory for which they were made until they are amended, cancelled or repealed by the new Municipality; (re) \"Inventory shall be taken of all documents (bylaws, proceedings, valuation rolls, photographs, building permits, maps, plans, reports and others) produced or executed by the former municipalities to be amalgamated, under the direction of the Clerk of the Secretary-Treasurer within the six (6) months following the publication of the letters patent.All documents which date back less than five(5) years, and which are required for the proper administration of the new Municipality, shall be preserved.The other documents shall be entrusted to the Keeper of the National Archives of Québec, who shall retain those he considers to be of historical importance, the foregoing under the legislation relating to the National Archives of Québec (Statutes of Québec, 1969, Chapter 26)\"; (o) The special taxes imposed under bylaws No.148 of the Village of Saint-Jérôme and No.137 of the Parish of Saint-Jérôme, shall, in the future, be imposed and levied on all taxable properties serviced by the water and sewer systems of the new Municipality according to their valuation as it appears on the valuation roll in force each year; however, said special taxes shall be levied only in the case of insufficiency of the compensation tariff then in force in the new Municipality; (p) The compensation tariffs for the water and sewer systems services shall be standardized throughout the territory of the new Municipality, starting from January 1, 1976.The costs pertaining to such services shall be borne only by the users of said services; (o) The special taxes imposed under bylaws Nos.149 and 153 of the Village of Saint-Jérôme shall, in the future, be imposed and levied on all taxable properties of the new Municipality, according to valuation, as it appears on the valuation roll in force each year; (r) Bylaws No.147 of the Village of Saint-Jérôme and No.136 of the Parish of Saint-Jérôme shall be repealed; («) The garbage removal service shall be paid out of the general land tax; (() The general land tax rate, applicable to the territory of each of the municipalities at the time of coming into force of the letters patent, shall remain unchanged until the first of January 1976; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1689 u) La nouvelle municipalité deviendra effective conformément à la loi; Signé à St-Jérôme, Comté du Lac St-Jean-Est, ce lie jour du mois de février 1975.Charles-Émile Brassard, maire, Village de St-Jérôme.Laurent Plourde, sec.-trés.Village de St-Jérôme.Ulysse Duchesne, maire.Paroisse de St-Jérôme.Laurent Plourde, sec.-trés.Paroisse de St-Jérôme.Tout propriétaire ou tout locataire des municipalités concernées peut s'opposer au principe de la fusion ou aux modalités de la requête conjointe dans les trente jours qui suivent la date de la dernière parution dans un journal du présent avis et peut faire connaître les motifs de son opposition en s'adressant par écrit à la Commission municipale du Québec.On peut prendre connaissance et obtenir copie du texte de la requête conjointe au secrétariat des municipalités du Village et de la Paroisse de Saint-Jérôme.Donné à St-Jérôme, ce lie jour de février 1975.Le secrétaire-trésorier de la municiplaitê du village de Saint-Jérôme, 60086-o Laurent Plourde.(u) The new Municipality shall take effect according to law.Signed in Saint-Jérôme, County of Lac Saint-Jean-Est, this eleventh day of the month of February, 1975.Charles-Émile Brassard, Mayor, Village of Saint-Jérôme.Laurent plourde.See.-TVeas., Village of Saint-Jérôme.Ulysse Duchesne, Mayor, Parish of Saint-Jérôme.Laurent Plourde, Sec.-Treas., Parish of Saint-Jérôme.Any property-owner or tenant in the municipalities concerned may oppose the principle of amalgamation or the terms and conditions of the joint petition within a period of thirty days following upon the date of the final publication of the present notice in a newspaper.He may make known the reasons of his opposition, in writing, to the Québec Municipal Commission.The content of the joint petition may be examined and a copy thereof may be obtained at the Secretariats of the Municipalities of the Village and Parish of Saint-Jérôme.Given in Saint-Jérôme, this 11th day of February, 1975.Laurent Plourde, Secretary-Treasurer of the Municipality of the 60086 Village of Saint-Jérôme.FAMILLE BETHLEEM Avis est donné qu'en vertu de la Loi des évèques catholiques romains.Statuts refondus, 1964, chapitre 304, il a été accordé par le lieutenent-gouverneur des lettres patentes en date du 27 mai 1974, constituant en corporation « FAMILLE BETHLEEM ».Le siège social de la corporation est situé à Saint-Liboire, district judiciaire de Saint-Hyacinthe.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.60016-o 1356-8274 FAMILLE BETHLEEM Notice is given that under the Roman Catholic Bishops Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 304, the Lieutenant-Governor has granted letters patent daded May 27, 1974, constituting a corporation under the name of \"FAMILLE BETHLEEM\".The head office of the corporation is located in Saint-Liboire, Judicial District of Saint-Hyacinthe.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60016 1356-8274 BOMONT MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION COMPAGNIE DE PLACEMENTS HYPOTHECAIRES BOMONT Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la Loi des sociétés de prêts et de placements du Québec, un permis autorisant la compagnie à faire affaires au Québec a été émis par le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives le 13 janvier 1975.Daté à Montréal, Québec, le 3e jour dc février 1975.Le secrétaire de la compagnie, 60000-7-4-o R.Muir.BOMONT MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION COMPAGNIE DE PLACEMENTS HYPOTHECAIRES BOMONT Pursuant to the requirements of section 3 of the Loan and Investments Societies Act of Québec notice is hereby given by the company, that a licence authorizing the company to carry on business in Québec was issued by the Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives on January 13th, 1975.Dated at Montreal, Québec, this 3rd day of February, 1975.R.Muir, 60000-7-4-o Secretary of the company. 1690 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 BOMONT MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION COMPAGNIE DE PLACEMENTS HYPOTHECAIRES BOMONT Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis que le 13e jour de janvier 1975, il a accordé un permis à la corporation « BOMONT MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION \u2014 COMPAGNIE DE PLACEMENTS HY-POTHECALRES BOMONT », l'autorisant à faire affaires dans la province de Québec, sous l'autorité de la Loi des sociétés de prêts et de placements.Statuts refondus, 1964, chapitre 289.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite corporation, est M.James T.Beckerleg, 313, Brock nord, Montréal-Ouest.Le bureau principal de la corporation dans la province est établi à 129, rue St-Jacques, Montréal, district judiciaire dc Montréal.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, Albert Jessop.6OOI0-0 1360-3782 BOMONT MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION COMPAGNIE DE PLACEMENTS HYPOTHECAIRES BOMONT The Minister of Financial Institutions, Companies anJ Cooperatives, gives notice that, on the 13th day of January, 1975.he has granted a license to \"BOMONT MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION \u2014 COMPAGNIE DE PLACEMENTS HYPOTHECAIRES BOMONT\", authorizing said corporation to carry on business in the Province of Québec, under the Loan and Investment Societies Act, Revised Statutes, 1964, Chapter 289.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said corporation is Mr.James T.Beckcrleg, 313 Brock North, Montreal-West.The principal office of the corporation in the Province is located at 129 St.James Street, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60016 1360-3782 Succession Louis-Marie Gauthier Prenez avis que Dame Diane Gauthier et que Dame Lise Gauthier ont accepté sous bénéfice d'inventaire la succession de leur père, feu M.Louis-Marie Gauthier, décédé le 5 janvier 1974, par acte exécuté à Matane, P.Q., devant Me Jacques-A.Deschênes, notaire, le 6 février 1975 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement dc Matane le 7 février 1975 sous le numéro 88,698.Donné à Matane, le 10 février 1975.Le notaire, 60049-O Jacques-A.Deschênes.Estate of Louis-Marie Gauthier Notice is given that Mrs.Diane Gauthier and Mrs.Lise Gauthier have accepted under benefit of inventory the estate of their father, the late Louis-Marie Gauthier, who died on January 5, 1974, under the terms of a deed executed in Matane, P.Q., before Me Jacques-A.Deschênes, notary, on February 6, 1975 and registered at the Matane Registration Division Office on February 7, 1975, under number 88,698.Given in Matane, on the 10th of February 1975.Jacques-A.Deschênes, 60049 Notary.LE BUREAU METROPOLITAIN DES ECOLES PROTESTANTES DE MONTREAL Avis de rachat Le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, Obligations du Fonds d'amortissement à 6 5/8% du 1er avril 1967, échéant le 1er avril 1992.Avis est par les présentes donné aux détenteurs d'obligations de fonds d'amortissement à 6 5/8% du Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, datées du 1er avril 1967 échéant le 1er avril 1992, que, conformément aux dispositions apparaissant sur les obligations et en vertu d'une résolution passée par ladite commission scolaire le 28 février 1967 et du chapitre 171 des Statuts revisés du Québec, 1964, les obligations suivantes totalisant en capital soixante-trois mille dollars ($63,000) et portant les numéros suivants, à savoir: Obligation à dénomination de $25,000 portant le numéro YXXV 01 THE PROTESTANT SCHOOL BOARD OF GREATER MONTREAL Notice of Redemption The Protestant School Board of Greater Montreal 6 5/8% Sinking Fund Bonds dated April 1st, 1967 maturing April 1st, 1992.Notice is hereby given to the holders of the 6 5/8% sinking fund bonds of The Protestant School Board of Greater Montreal dated April 1st, 1967 maturing April 1st, 1992 pursuant to the provisions set forth in said bonds and under authority of the resolution of the said School Board passed on February 28th 1967 and of Chapter 171 of the Revised Statutes of Québec, 1964, the following bonds aggregating in principal amount sixty-three thousand dollars ($63,000) and numbered as follows, namely: Bond of the denomination of $25,000 numbered YXXV 01 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1691 Obligations à dénomination de $5,000 portant les numéros YVM 055 YVM 056 YVM 057 YVM 058 YVM 059 YVM 060 Obligations à dénomination de $1,000 portant les numéros YM 080 YM 081 YM 082 YM 083 YM 084 YM 085 YM 086 YM 087 sont par les présentes rappelées pour rachat le 1er avril 1975 pour fins d'amortissement à 100% de leur montant en principal, plus l'intérêt couru et non payé à la date de rachat.Les obligations ainsi rappelées pour rachat deviendront dues et payables et seront payées en devises légales des États-Unis d'Amérique à The Royal Bank of Canada Trust Company ou The Bank of Montreal Trust Company, dans la cité de New York, État de New York, États-Unis d'Amérique, au choix du détenteur, sur présentation et remise desdites obligations avec tous les coupons d'intérêt échéant après le 1er avril 1975 y attachés.Les obligations enregistrées quant au principal devront être accompagnées des documents requis pour le transfert.Avis est de plus donné que l'intérêt sur lesdites obligations cessera à compter de la date de rachat et que les coupons d'intérêt couru après ladite date de rachat deviendront et demeureront nuls.Donné à Montréal, ce douzième jour de février 1975.Le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal.La secrétaire générale, 60050-o Mme Olga Kowcz.Bonds of the denomination of $5,000 numbered YVM 055 YVM 056 YVM 057 YVM 058 YVM 059 YVM 060 Bonds of the denomination of $1,000 numbered YM 080 YM 081 YM 082 YM 083 YM 084 YM 085 YM 086 YM 087 are hereby called for redemption on April 1st, 1975 for sinking fund purposes at 100% of the principal amount together with accrued and unpaid interest thereon to such redemption date.The bonds so called for redemption will become due and payable and will be paid in lawful money of the United States of America at The Royal Bank of Canada Trust Company or the Bank of Montreal Trust Company in the City of New York, New York, United States of America, at the option of the holder, upon presentation and surrender of the said bonds with all interest coupons maturing after April 1st, 1975 attached.Bonds registered as to principal must be accompanied by all instruments requisite to transfer.Notice is further given that interest upon said bonds shall cease as and from the redemption date and coupons for interest to accrue after said date shall become and be void.Dated at Montreal, this twelfth day of February, 1975.The Protestant School Board of Greater Montreal.60050-o Mrs.Olga Kowcz, Secretary General.Renseignements sur les compagnies Companies Information Act Révocation de dissolution Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives donne avis, en vertu du paragraphe a de l'article 5/ de la Loi des renseignements sur les compagnies, qu'il a jugé à propos de faire droit à la demande d'intéressés faite dans les délais légaux à l'effet de révoquer la dissolution de Revocation of dissolution The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice, that pursuant to paragraph a of section 5/ of the Companies Information Act, he deemed it advisable to grant the petition of the interested parties made within the legal time limit, praying to revoke the dissolution of Nom des compagnies\tDissolution\t\tGazette officielle No Name of the companies\t\tDate\tOfficial Gazette No.EXCEL HOMES INC.\t.19\t01 1974\t3 OSMIN CONSTRUCTION CORPORATION.\t.19\t10 1974\t42 en vertu de ladite loi et qu'il révoque la dissolution desdites compagnies.En conséquence, lesdites compagnies sont censées n'avoir jamais été dissoutes en vertu de ladite loi, sans préjudice aux droits acquis par toute personne entre la dissolution et la révocation., Le directeur du service des compagnies, 60016-0 Pierre Desjardins.pursuant to the said Act and that he revokes the dissolution of the said companies.Consequently, the said companies, are considered as having never been dissolved under the said Act, without prejudice to the rights acquired by any person between the dissolution and the revocation.Pierre Desjardins, 60016-0 Director of the Companies Service. 1692 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Soumissions \u2014 Demandes de Ville de Longueuil Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Claude Gauthier, greffier.Hôtel de ville, 100 ouest, rue St-Charles, Longueuil, comté de Chambly, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 10 mars 1975, pour l'achat de $6,189,000 d'obligations delà ville de Longueuil, comté de Chambly, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8J-^%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er octobre et 1er avril de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $6,189,000 \u2014 20 ans \tDate\tCapital fil\t04 1976.\t.$272,000 01\t04 1977.\t.280,000 111\t04 1978.\t.291,000 (Il\t04 1979.\t.302,000 01\t04 1980.\t.315,000 01\t04 1981.\t.318,000 01\t04 1982.\t.332,000 01\t04 1983.\t.348,000 01\t04 1984.\t.365,000 01\t04 1985.\t.384,00\" En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $401,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et en devront être transmises que pour un seul des modes Tenders \u2014 Requests for City of Longueuil Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Claude Gauthier, City Clerk, at the City Hall, 100 Saint-Charles Street West, Longueuil, County of Chambly, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, March 10, 1975, for the purchase of a bond issue of $6,189,000 for the City of Longueuil, County of Chambly, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8J^%, nor more than 10%, payable semiannually on October 1st and April 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975.Redemption table \u2014 $6,189,000 \u2014 20 years Date Capital 01 04 1986.$218,000 01 04 1987 .232,000 01 04 1988.245,000 01 04 1989 .261,000 01 04 1990.281,000 01 04 1991.301,000 01 04 1992 .324,000 01 04 1993 .347,000 01 04 1994.372,000 01 04 1995.401,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $401,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 1, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipul- GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 32 février 1975, 107' année, n° 8 169.3 d'émission ci-haut et en devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $401,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Longueuil s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Les soumissions seront émises en vertu des règlements suivants: 610 \u2014 $51,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 85 \u2014 $65,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie et éclairage; 174 (559) \u2014 $131,000 \u2014 services récréatifs, bâtisses et terrains; 184 \u2014 $102,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 205 \u2014 $290,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 230 \u2014 (526) \u2014 $36,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 255 \u2014 $11,000 \u2014 éclairage; 279 \u2014 $151,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 315 \u2014 $30,000 \u2014 éclaiiagc; 318-72 \u2014 $45,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 337-72 \u2014 $270,000 \u2014 voirie, éclairage et autres; 344-72 \u2014 $200,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie et autres; 372-72 \u2014 $124,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 388-73 \u2014 $145,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 400-73 \u2014 $69,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 407-73 \u2014 $105,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 408-73 \u2014 $320,000 \u2014 aqueduc et égouts; 409-73 \u2014 $76,000 \u2014 voirie; 410-73 \u2014 $100,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 413-73 \u2014 $205,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 428-73 \u2014 $7,000 \u2014 éclairage; 432-73 \u2014 $96,000 \u2014 bâtisses et terrains; 455-73 \u2014 $85,000 \u2014 voirie, bâtisses et terrains; 462-73 \u2014 $113,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 487-74 \u2014 $203,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 490-74 \u2014 $51,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 503-74 \u2014 $232,000 \u2014 services récréatifs et communautaires; 510-74 \u2014 $1,552,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 514-74 \u2014 $24,000 \u2014 services récréatifs et communautaires; 519-74 \u2014 $138,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie; 520-74 \u2014 $116,000 \u2014 éclairage; 521-74 \u2014 $123,000 \u2014 bâtisses et terrains; 523-74 \u2014 $46,000 \u2014 bâtisses et terrains; 524-74 \u2014 $64,000 \u2014 expropriation ; 542-74 \u2014 $63,000 \u2014 autres; 557-74 \u2014 $750,000 \u2014 bâtisses et terrains, services récréatifs et communautaires.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités.ated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $401,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Longueuil agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 610 \u2014 $51,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 85 \u2014 $65,000 \u2014 waterworks, sewers, roads and lighting; 174 (559) \u2014 $131,000 \u2014 recreational services, buildings and land; 184 \u2014 $102,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 205 \u2014 $290,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 230 (526) \u2014 $36,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 255 \u2014 $11,000 \u2014 lighting; 279 \u2014 $151,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 315 \u2014 $30,000 \u2014 lighting; 318-72 \u2014 $45,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 337-72 \u2014 $270,000 \u2014 roads, lighting, etc.; 344-72 \u2014 $200,000 \u2014 waterworks, sewers, roads, etc.; 372-72 \u2014 $124,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 388-73 \u2014 $145,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 400-73 \u2014 $69,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 407-73 \u2014 $105,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 408-73 \u2014 $320,000 \u2014 waterworks and sewers; 409-73 \u2014 $76,000 \u2014 roads; 410-73 \u2014 $100,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 413-73 \u2014 $205,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 428-73 \u2014 $7,000 \u2014 lighting; 432-73 \u2014 $96,000 \u2014 buildings and land; 455-73 \u2014 $85,000 \u2014 roads, buildings and land; 462-73 \u2014 $113,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 487-74 \u2014 $203,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 490-74 \u2014 $51,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 503-74 \u2014 $232,000 \u2014 recreational and community services; 510-74 \u2014 $1,552,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 514-74 \u2014 $24,000 \u2014 recreational and community services; 519-74 \u2014 $138,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 520-74 \u2014 $116,000 \u2014 lighting; 521-74 \u2014 $123,000 \u2014 buildings and land; 523-74 \u2014 $46,000 \u2014 buildings and land; 524-74 \u2014 $64,000 \u2014 expropriation; 542-74 \u2014 $63,000 \u2014 miscellaneous; 557-74 \u2014 $750,000 \u2014 buildings and land, recreational and community services.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as 1694 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 selon le cas.qui sera tenue à 8.00 heures du soir, lundi, le 10 mars 1975, Hôtel de ville, 100 ouest, rue St-Charles, Longueuil, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Longueuil (Comté de Chambly), ce 12 février 1975.Le greffier, Claude Gauthier.Hôtel de ville, 100 ouest, rue St-Charles, Longueuil (Chambly), Québec.Téléphone: 670-2220.code 514.60033-o Ville d'Amos Comté d'Abitibi-Ouest Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Émery Bordcleau, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville.62 est, 3e Avenue, ville d'Amos, comté d'Abitibi-Ouest P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 10 mars 1975, pour l'achat de $1,676,000 d'obligations de la ville d'Amos.comté d'Abitibi-Ouest, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8}4%.n> supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er octobre et 1er avril de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $1,676,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 04 1976.$ 38,000 01 04 1977 .43,000 01 04 1978.45,000 01 04 1979 .50,000 01 04 1980 .54,000 01 04 1981.83,000 01 04 1982.92,000 01 04 1983.100,000 01 04 1984.108,000 01 04 1985.118,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Monday, March 10, 1975, at the City Hall, 100 Saint-Charles\" Street West Longueuil, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Longueuil (County of Chambly), February 12, 1975.Claude Gauthier, City Clerk.City Hall, 100 Saint-Charles Street West, Longueuil (Chambly), P.Q.Telephone: 670-2220, code 514.60033 Town of Amos County of Abitibi-Ouesl Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Émery Bordeleau, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 62 - 3rd Avenue Est, Town of Amos, County of Abitibi-West, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, March 10, 1975.for the purchase of a bond issue of $1,676.000 for the Town of Amos.County of Abitibi-West, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than nor more than 10%, payable semiannually on October 1st and April 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975.Redemption table \u2014 $1,676,000 \u2014 20 years Date Capital 01 04 1986.$ 61,000 01 04 1987 .67,000 01 04 1988.73,000 01 04 1989.80,000 01 04 1990.88,000 01 04 1991.95,000 01 04 1992.105,000 01 04 1993.115,000 01 04 1994.125,000 01 04 1995.136,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1695 Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $136,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $136,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins dc l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville d'Amos s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 332 \u2014 $140,000 ¦\u2014 renouvellement d'emprunt; A-9 (tel que modifié) \u2014 $56,000 \u2014 achat de terrains; A-12 \u2014 $193,000 \u2014 voirie; A-13 \u2014 $267,000 \u2014 voirie; A-14 \u2014 $120,000 \u2014 aqueduc et égouts; A-15 \u2014 $196,500 \u2014 services récréatifs et communautaires; 201 \u2014 $153,000 \u2014 aqueduc et égouts; 203 \u2014 $338,000 \u2014 aqueduc, égouts et voirie \u2014; 381 (381-A) \u2014 $174,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie et éclairage; 389 \u2014 $38,500 \u2014 services récréatifs et communautaires.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.00 heures du soir, lundi le 10 mars 1975, Hôtel de ville, 62 est, 3e Avenue, ville d'Amos, comté d'Abitibi-Ouest, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Amos (Comté d'Abitibi-Ouest), ce 12 février 1975.Le secrétaire-trésorier, Émery Bordeleau.Hôtel de ville, 62 est, 3e Avenue, Amos (Abitibi-Ouest), Québec.Téléphone: 732-5218, code 819.60032-o However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $136,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 1, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $136,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Amos agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1,1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 332 \u2014 8140,000 \u2014 loan renewal; A-9 (as amended) \u2014 $56,000 \u2014 purchase of land; A-12 \u2014 $193,000 \u2014 roads; A-13 \u2014 $267,000 \u2014 roads; A-14 \u2014 $120,000 \u2014 waterworks and sewers; A-15 \u2014 $196,500 \u2014 recreational and community services; 201 \u2014 $153,000 \u2014 waterworks and sewers; 203 \u2014 $338,000 \u2014 waterworks, sewers and roads; 381 (381-A) \u2014 $174,000 \u2014 waterworks, sewers, roads and lighting; 389 \u2014 $38,500 \u2014 recreational and community services.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held al 8:00 o'clock p.m., on Monday, March 10, 1975, at the Town Hall, 62, 3rd Avenue East, Town of Amos, County of Abitibi-West, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Amos, (County of Abitibi-West), February 12, 1975.Émery Bordeleau, Secretary-Treasurer.Town Hall, 62 - 3rd Avenue East, Amos (Abitibi-West), Québec.Telephone: 732-5218, code 819.60032 1696 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Ville de Saint-Jean-Chrysostome Comté de Beauce-Nord Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Cajétan Alain, secrétaire-trésorier, salle du conseil, 960, rue de l'Eglise, ville Saint-Jean-Chrysostome, comté de Beauce-Nord, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, lundi, le 10 mars 1975, pour l'achat de $433.000 d'obligations de la ville de Saint-Jean-Chrysostome, comté de Beauce-Nord, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1995 inclusivement avec intérêt à un taux non inférieur à 8J/£%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre dechaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $433,000 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapital (Il\t04\t1976.\t.$ 5,000 01\t04\t1977.\t.5,500 01\t04\t1978.\t.6,000 01\t04\t1979.\t.6,500 01\t04\t1980.\t.7,000 01\t04\t1981.\t.7,500 01\t04\t1982.\t.8,000 01\t04\t1983.\t.9,000 01\t04\t1984.\t.9,500 01\t04\t1985.\t.10,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $20,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2015 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Town of Saint-Jean-Chrysostome County of Beauce-North Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Cajétan Alain, Secretary-Treasurer, at the Council Hall, 960 de l'Eglise Street, Town of Saint-Jean-Chrysostome, County of Beauce-North, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Monday, March 10, 1975.for the purchase of a bond issue of $433,000 for the Town of St-Jean-Chrysostome, County of Beauce-North, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8}A%- nor more tllan 10%-payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975.Redemption table \u2014 $483,000 \u2014 20 years Date Capital 01 04 1986.$ 11,000 01 04 1987.12,000 01 04 1988.13,000 01 04 1989.14,000 01 04 1990.15,500 01 04 1991.16,500 01 04 1992.18,500 01 04 1993.19,500 01 04 1994.21,500 01 04 1995.217,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered : 1.1 to 10-ycar serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $20,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of April 1, 2015 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n' 8 1697 L'échéance du 1er avril 1995 au montant de $217,500 comprend un solde de $194,500 renouvelable pour une période additionnelle de 20 ans.et échéant comme suit: Date Capital 01 04 1996.$ 3,500 01 04 1997 .4,000 01 04 1998.4,500 01 04 1999.5,000 01 04 2000.5,500 01 04 2001 .6,000 01 04 2002 .6,500 01 04 2003 .7,000 01 04 2004 .7,500 01 04 2005.8,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $217,500, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pairie 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de St-Jean-Chrysostome s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: V-70-192 \u2014 $31,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; V-70-195 \u2014 $17,500 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; V-72-213 \u2014 $158,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; V-72-216 \u2014 $13,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; V-72-219 \u2014 $33,700 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; V-72-220 \u2014 $18,000 \u2014 aqueduc, égouts; V-73-224 \u2014 $161,800 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités selon le cas, qui sera tenue, lundi, le 10 mars 1975, à 8.00 heures du soir, salle du conseil, 960, rue de l'Eglise, Ville de Saint-Jean-Chrysostome, comté de Beauce-Nord, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Jean-Chrysostome (Comté de Beauce-Nord), ce 12 février 1975.Le secrétaire-trésorier, Cajétan Alain.Salle du Conseil, 960, rue de l'Eglise, Ville de Saint-Jean-Chrysostome, Comté de Beauce-Nord, P.Q.Téléphone: 839-9417, code 418.60037-o The maturity of April 1, 1995 in the amount of $217.500 includes a balance of $194,500 renewable for an additional 20-year period, maturing as follows: Date Capital 01 04 2006.$ 9,000 01 04 2007.10,000 01 04 2008.10,500 01 04 2009.11,500 01 04 2010.12.500 01 04 2011.14.000 01 04 2012.15,000 01 04 2013.16,500 01 04 2014.18,000 01 04 2015.20,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $217,500, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par.on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Saint-Jean-Chrysostome agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: V-70-192 \u2014 $31,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; V-70-195 ¦\u2014 $17,500 \u2014 waterworks, sewers, roads; V-72-213 \u2014 $158,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; V-72-216 \u2014 $13,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; V-72-219 \u2014 $33,700 \u2014 waterworks, sewers, roads; V-72-220 \u2014 $18,000 \u2014 waterworks, sewers; V-73-224 \u2014 $161,800 \u2014 waterworks, sewers, roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Monday, March 10, 1975, at 8:00 o'clock p.m., at the Council Hall, 960 de l'Eglise Street, Town of Saint-Jean-Chrysostome,Coun-ty of Beauce-North, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Jean-Chrysostome (County of Beauce-North), February 12, 1975.Cajétan Alain, Secretary-Treasu rer.Council Hall, 960 de l'Eglise Street, Town of Saint-Jean-Chrysostome, County of Beauce-North, P.Q.Telephone: 839-9417, code 418.60037 1698 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Village de Saint-Georges Comté de Champlain Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Isidore Pelletier, secrétaire-trésorier.Centre municipal, 400, avenue 106, village de Saint-Georges, comté de Champlain, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, mercredi le 12 mars 1975, pour l'achat de 8235,500 d'obligations du village de Saint-Georges, comté de Champlain, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8^2%, m supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er octobre et 1er avril de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $235,500 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapital 111\t04\t1976.\t.$ 1,500 (Il\tII!\t1977.\t.1,500 (11\tII!\t1978.\t.1,500 (11\t(Il\t1979.\t.2,000 (Il\tII!\t1980.\t.2,000 (Il\tII!\t1981.\t.2,000 (Il\tII!\t1982.\t.2,500 (Il\t04\t1983.\t.2,500 (Il\tni\t1984.\t.3,000 (Il\tII!\t1985.\t.3,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $23,500, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2005 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.Village of Saint-Georges County of Champlain Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Isidore Pelletier, Secretary-Treasurer, at the Municipal Centre, 400, Avenue 106, Village of Saint-Georges, County of Champlain, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Wednesday, March 12, 1975, for the purchase of a bond issue of $235,500 for the Village of Saint-Georges, County of Champlain, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1.1995 inclusive, with interest at a rate of not less than %Vi%, nor more than 10%.payable semiannually on October 1st and April 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April I, 1975.Redemption table \u2014 $285,500 \u2014 20 years Date Capital 01 04 1986.$ 3,500 01 04 1987 .4,000 01 04 1988.4,500 01 04 1989.5.000 01 04 1990 .5,000 01 04 1991.6,000 01 04 1992.6,500 01 04 1993.7,000 01 04 1994 .8.000 01 04 1995.164,500 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $23,500, and if greater than the latter amount, the said surplus should only-comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of April 1, 2005 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, n février 1976, 107' année, n° 8 1699 L'échéance «lu 1er avril 1995 au montant de $164,500 comprend un solde de $156,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date CapiUl 01 04 1996.$ 9,500 01 04 1997.10,500 01 04 1998.11,500 01 04 1999.13,000 01 04 2000.14,500 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $164,500, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de Saint-Georges s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement numéro 136-74 \u2014 $235,500 \u2014 aqueduc, égouts, voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 12 mars 1975, à 8.00 heures du soir, Centre municipal, 400, avenue 106, village de Saint-Georges, comté de Champlain, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Georges (Comté de Champlain), ce 12 février 1975.Le secrétaire-trésorier, Isidore Pelletier.Centre municipal, 400, avenue 106, Saint-Georges (Champlain), Québec.Téléphone : 538-2435, code 819.60043-o Cité de Sillery Comté de Louis-Hébert Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Georges Gravel, greffier, Hôtel de ville, 1445, avenue Maguire, cité de Sillery, comté de Louis-Hébert, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 11 mars 1975, pour l'achat de $966,000 d'obligations de la cité de Sillery, comté de Louis-Hébert, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au The maturity of April 1, 1995 in the amount of $164,500 includes a balance of $156,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date Capital 01 04 2001.$15,500 01 04 2002.17,500 01 04 2003.19,000 01 04 2004.21,500 01 04 2005.23,500 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $164,500, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1 % of the amount of the loan.The Parish of Saint-Georges agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to bylaw number 136-74 \u2014 $235,500 \u2014 waterworks, sewers, roads.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council to be held on Wednesday, March 12, 1975, at 8:00 o'clock p.m.at the Municipal Centre, 400, Avenue 106, Village of Saint-Georges, County of Champlain, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Georges (County of Champlain), February 12, 1975.Isidore Pelletier, Secretary-Treasurer.Municipal Centre, 400, Avenue 106, Saint-Georges (Champlain), P.Q., Telephone: 538-2435, code 819.60043 City of Sillery County of Louis-Hébert Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Georges Gravel, City Clerk, at the City Hall, 1445 Maguire Avenue, City of Sillery, County of Louis-Hébert, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday March 11, 1975, for the purchase of a bond issue of $966,000 for the City of Sillery, County of Louis-Hébert, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1995 inclusive, with 1700 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 1er avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8H%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er octobre et 1er avril de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $966,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 04 1976.$ 23.000 01 04 1977 .26,000 01 04 1978 .29,000 01 04 1979 .31,000 01 04 1980.35,000 01 04 1981.38,000 01 04 1982 .41,000 01 04 1983.46,000 01 04 1984.50,000 01 04 1985.55,000 En plus les modalités suivantes seulement seront considérées: 1 ° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3\" Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $87,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises 3ue pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne evront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $87,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1 cr avril de chaque année pour le montant annuel interest at a rate of not less than 8^%, nor more than 10%, payable semiannually on October 1st and April 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975.Redemption table \u2014 $966.000 ¦\u2014 20 years Date Capital 01 04 1986.$38,000 01 04 1987 .42,000 01 04 1988.45,000 01 04 1989 .50,000 01 04 1990 .54,000 01 04 1991.59,000 01 04 1992 .66,000 01 04 1993.72,000 01 04 1994.79,000 01 04 1995.87,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $87,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 1, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in C»nada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $87,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1701 requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chéquevisé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Sillery s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 752 \u2014 $350,000 \u2014 voirie; 755 \u2014 $21,000 \u2014 voirie; 756 \u2014 $66,000 \u2014 égouts; 757 \u2014 $140,000 \u2014 travaux à l'usine de filtration; 761 \u2014 $51,500 \u2014 aqueduc et égouts; 763 \u2014 $17.500 \u2014 aqueduc et égouts; 764 \u2014 $130,000 \u2014 voirie; 765 \u2014 $190,000 voirie.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.00 heures du soir, mardi, le 11 mars 1975, Hôtel de ville, 1445, avenue Ma-guire, Sillery.comté de Louis-Hébert, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Sillery (Comté de Louis-Hébert), ce 13 février 1975.Le greffier, Georges Gravel.Hôtel de ville, 1445, avenue Maguire, Sillery (Louis-Hébert), Québec.Téléphone: 527-3404, code 418.60048-o Ville de Dollard-des-Ormeaux Comté de Robert-Baldwin Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par la soussignée Madame Hélène Plouffe, greffier.Hôtel de ville, 4139, boulevard des Sources, ville de Dollard-des-Ormeaux, comté de Robert-Baldwin, jusqu'à 4.30 heures de l'après-midi, et par après jusqu'à 8.00 heures du soir, Poste de Police, 10, Sunnydale Road, ville de Dollard-des-Ormeaux, comté de Robert-Baldwin, P.Q., jeudi, le 13 mars 1975 pour l'achat de $3,099,000 d'obligations de la ville de Dollard-des-Ormeaux, comté de Robert-Baldwin, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8J^%, ni supérieur à 10J/£%, payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Sillery agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 752 \u2014 $350,000 \u2014 roads; 755 \u2014 $21,000 \u2014 roads; 756 \u2014 $66.000 \u2014 seweu; 757 \u2014 $140,000 \u2014 works at the filtering plant; 761 \u2014 $51,500 \u2014 waterworks and sewers; 763 \u2014 $17,500 \u2014 waterworks and sewers; 764 \u2014 $130,000 \u2014 roads; 765 \u2014 $190,000 \u2014 roads.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council or of one of its committees, as the case may be, to be held on Tuesday, March 11, 1975, at 8:00 o'clock p.m., at the City Hall.1445 Maguire Avenue, Sillery, County of Louis-Hébert, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Sillery, (County of Louis-Hébert), February 13, 1975.Georges Gravel, City Clerk.City Hall, 1445 Maguire Avenue.Sillery, (Louis-Hébert), Québec.Telephone: 527-3404, code 418.60048 Town of Dollard-des-Ormeaux County of Robert-Baldwin Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Hélène Plouffe, Town Clerk, at the Town Hall, 4139 Des Sources Boulevard, Town of Dollard-des-Ormeaux, County of Robert-Baldwin, until 4.30 p.m., and thereafter until 8:00 o'clock p.m., at the Police Station, 10 Sunnydale Road, Town of Dollard-des-Ormeaux, County of Robert-Baldwin, P.Q., on Thursday, March 13, 1975 for the purchase of a bond issue of $3,099,000 for the Town of Dollard-des-Ormeaux, County of Robert-Baldwin, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8J-£%, nor more than 10%, payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975. 1702 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.S Tableau d'amortissement \u2014 83,099.000 \u2014 20 ans \tDate\t\tCapital 01\t04\t1976.\t.S 38.000 01\t(14\t1977.\t.41.000 01\t04\t1978.\t.45.000 01\t04\t1979.\t.49,000 (11\t(il\t1980.\t.53,000 01\t04\t1981.\t.77,000 01\t04\t1982.\t.86,000 111\till\t1983.\t.93,000 111\t04\t1984.\t.99,000 111\t04\t1985.\t.108,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $90,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 2005 de la partie renouvelable ci-après indiquée.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er février 1995 au montant de $1,001,000 comprend un solde de $780,000 renouvelable pour une période additionnelle de 10 ans, et échéant comme suit: Date CapiUl 01 04 1996.$85,000 01 04 1997 .91,000 01 04 1998.98,000 01 04 1999 .56,000 01 04 2000.61,000 L'adjudicaUire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas racheUbles par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un monUnt supérieur à $1,001,000, et seul cet excédent sera racheUble par anticipation au pair le 1er avril dc chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement dc l'émission Redemption table \u2014 $3,099,000 \u2014 20 years Date CapiUl 01 04 1986.$ 117,000 01 04 1987.L27.000 01 04 1988.137,000 01 04 1989.148,000 01 04 1990.161,000 01 04 1991.159,000 01 04 1992.172,000 01 04 1993.186,000 01 04 1994.202,000 01 04 1995.1,001,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered : 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than 890,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions.Uking into account the redemption Ubles appearing in this notice, and sUrting with the last years of redemption, excluding the maturity of April 1, 2005.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of February 1, 1995 in the amount of 81,001.000 includes a balance of $780,000 renewable for an additional 10-year period, maturing as follows: Date CapiUl 01 04 2001.$66,000 01 04 2002.71,000 01 04 2003.78,000 01 04 2004.84,000 01 04 2005.90,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capiUl and any interest, by certified cheque.CapiUl and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $1,001,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SU février 1975, 107' année, n° 8 1703 conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville de Dollard-des-Ormeaux s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixantes jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 241 \u2014 $17,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 255 \u2014 $3,100 \u2014 renouvellement d'emprunt; 272 \u2014 $3,300 \u2014 renouvellement d'emprunt; 289 \u2014 $72,300 \u2014 renouvellement d'emprunt; 291 \u2014 $265.800 \u2014 renouvellement d'emprunt: 293 \u2014 $222,300 \u2014 renouvellement d'emprunt; 296 \u2014 $9,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 297 \u2014 $5,700 \u2014 renouvellement d'emprunt; 432 \u2014 $121,000 \u2014 aqueduc, égouls, voirie; 460 \u2014 $250,300 \u2014 voirie éclairage; 472 \u2014 $71,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 474 \u2014 $50,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie: 483 \u2014 $27,200 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 487 \u2014 $53,700 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 500 \u2014 $600,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 502 \u2014 $310,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 507 \u2014 $400,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 510 \u2014 $301,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 517 \u2014 8190,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 524 \u2014 $125,800 \u2014 construction d'une piscine et élargissement de rues.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités selon le cis, qui sera tenue, jeudi, le 13 mars 1975 à 8.00 heures du soir.Poste de Police, 10 Sunnydale Road ville de Dollard-des-Ormeaux, comté de Robert-Baldwin, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Dollard-des-Ormeaux (Comté de Robert-Baldwin), ce 13 février 1975.Le greffier, Mme Hélène Plouffe.Hôtel de ville, 4139, boulevard des Sources, Ville de Dollard-des-Ormeaux, Comté de Robert-Baldwin, P.Q.Téléphone: 684-1010, code 514.60067-o Cité de Montréal-Nord Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations \" seront reçues par la soussignée Mademoiselle Aline Ouimet, greffier.Hôtel de ville, 4242, Place de l'Hôtel de ville, cité de Montréal-Nord, P.Q., jusqu'à 5.00 heures de l'après-midi et par après jusqu'à 8.00 heures du soir.Salle du Conseil, 11211, rue Hébert, cité de Montréal-Nord, P.Q., mardi, le 11 mars 1975 pour l'achat de $2,270,000 d'obligations de la cité dc Montréal-Nord, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8K%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Dollard-des-Ormeaux agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 241 \u2014 $17,500 \u2014 loan renewal; 255 \u2014 $3,100 \u2014 loan renewal; 272 \u2014 $3,300 \u2014 loan renewal; 289 \u2014 $72,300 \u2014 loan renewal; 291 \u2014 $265,800 \u2014 loan renewal; 293 \u2014 $222,300 \u2014 loan renewal; 296 \u2014 $9,000 \u2014 loan renewal; 297 \u2014 $5,700 \u2014 loan renewal; 432 \u2014 $121,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 460 \u2014 $250,300 \u2014 roads and lighting; 472 \u2014 $71,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 474 \u2014 $50,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 483 \u2014 $27,200 \u2014 waterworks, sewers, roads; 487 \u2014 $53,700 \u2014 waterworks, sewers, roads; 500 \u2014 $600,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 502 \u2014 $310,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 507 \u2014 $400,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 510 \u2014 $301,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 517 \u2014 $190,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 524 \u2014 $125,800 \u2014 construction of a swimming-pool and widening of streets.Tenders will be opened and considered at a meeting of the Council, or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Thursday, March 13, 1975, at the Police Station, 10 Sunnydale Road, Town of Dollard-des-Ormeaux, County of Robert-Baldwin, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Dollard-des-Ormeaux (County of Robert-Baldwin), February 13, 1975.Mrs.Hélène Plouffe, Town Clerk.Town Hall, 4139, Des Sources Boulevard, Town of Dollard-des-Ormeaux, County of Robert-Baldwin, P.Q.Telephone: 684-1010, code 514.60067 City of Montreal-North Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned.Miss Aline Ouimet, City Clerk, at the City Hall, 4242 Place de l'Hôtel de ville, City of Montreal-North, P.Q., until 5:00 o'clock p.m., and thereafter, until 8:00 o'clock p.m., at the Council Hall, 11211 Hébert Street, City of Montreal-North, P.Q., on Tuesday, March 11, 1975, for the purchase of a bond issue of $2,270,000 for the City of Montreal-North, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than 8^%, nor more than 10%, payable semiannually on April 1st and October 1st of each year. 1704 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1976, Vol.107, No.S les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré aux tableaux d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $2,270,000 \u2014 20 ans Date Capital 01 04 1976.$ 44,000 01 04 1977.47,000 01 04 1978 .52,000 01 04 1979 .56,000 01 04 1980.61,000 01 04 1981.113,000 01 04 1982.121,000 01 04 1983.131,000 01 04 1984.142,000 01 04 1985.154,000 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées: 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à $23,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte des tableaux d'échéances apparaissant dans le présent avis.et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéanc du 1er avril 2000 de la partie nnouv lab'.e ci-après ndiquée.Cependant, 1.s sou nis-ions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et n?devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1995 au montant de $208,000 comprend un solde dc $100,000 renouvelable pour une période additionnelle de 5 ans, et échéant comme suit: Date Capital 01 04 1996.$ 17,000 01 04 1997.18,000 01 04 1998.20,000 L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975.Redemption table \u2014 $2,270,000 \u2014 20 years \tDate\tCapital (11\t04 1986.\t.$134,000 01\t04 1987.\t.144,000 01\t04 1988.\t.157,000 01\t04 1989.\t.170,000 01\t04 1990.\t.182,000 01\t04 1991.\t.78,000 01\t04 1992.\t.85,000 01\t04 1993.\t.91,000 01\t04 1994.\t.100,000 01\t04 1995.\t.208,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $23,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual redemptions, taking into account the redemption tables appearing in this notice, and starting with the last years of redemption, excluding the maturity of April 1.2000 of the renewable part hereinafter indicated.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise only one of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The maturity of April 1, 1995 in the amount of $208,000 includes a balance of $100,000 renewable for an additional 5-year period, maturing as follows: Date Capital 01 04 1999.$ 22 000 01 04 2000 .23,000 The successful tenderer agrees to pay for the bonds, at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.CapiUl and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° S 1705 Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supérieur à $208,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le 1 avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La cité de Montréal-Nord s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 929 \u2014 $15,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 955 \u2014 $78,000 \u2014 renouvellement d'em-print; 956 \u2014 $244,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 962 \u2014 $40,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 963 \u2014 $35,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 966 \u2014 $34,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 972 \u2014 $118,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 974 \u2014 $25,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 975 \u2014 $94,700 \u2014 renouvellement d'emprunt; 976 \u2014 $47,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 977 \u2014 $164,400 \u2014 renouvellement d'emprunt; 983 \u2014 $121,900 \u2014 renouvellement d'emprunt; 986 \u2014 $30,500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 1035 \u2014 $10,000 \u2014 voirie; 1036 \u2014 $11,000 \u2014 voirie; 1126 \u2014 $8,700 \u2014 réparation à l'aréna; 1135 \u2014 $44,900 \u2014 voirie; 1136 \u2014 $35,000 \u2014 aqueduc, égouts; 1159 \u2014 $5,000 \u2014 aqueduc, égouts; 1162 \u2014 $65,000 \u2014 construction d'un chalet sportif; 1168 \u2014 $250,000 \u2014 voirie, éclairage; 1176 \u2014 $285,400 \u2014 aqueduc, égouts; 1182 \u2014 $82,000 \u2014 aqueduc, égouts, voirie; 1192 \u2014 $60,000 \u2014 voirie; 1195 \u2014 $264,000 \u2014 construction d'une piscine; 1198 \u2014 $100,000 \u2014 voirie, éclairage.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue, mardi le 11 mars 1975 à 8.00 heures du soir.Salle du Conseil, 11211, rue Hébert, cité de Montréal-Nord, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Montréal-Nord, ce 14 février 1975.Le greffier, Mlle Aline Ouimet.Hôtel de ville, 4242, Place de l'Hôtel de ville, Cité de Montréal-Nord, P.Q.Téléphone: 322-6271, code 514.60090-o Ville d'Iberville Comté d'Iberville Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné André-L.Frechette, secrétaire-trésorier, Hôtel de ville, 645,1ère Rue, Iberville, comté d'Iberville, P.Q-, jusqu'à 8.00 heures du soir, mardi, le 11 mars 1975, pour l'achat de $240,000 d'obligations de la ville d'Iberville, comté The said bonds will not be redeemable by anticipation unless they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $208,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par, on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The City of Montreal-North agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 929 \u2014 $15,000 \u2014 loan renewal; 955 \u2014 $78,000 \u2014 loan renewal; 956 \u2014 $244,500 \u2014 loan reneW-al; 962 \u2014 $40,500 \u2014 loan renewal; 963 \u2014 $35,000 \u2014 loan renewal; 966 \u2014 $34,000 \u2014 loan renewal; 972 \u2014 $118,000 \u2014 loan renewal; 974 \u2014 $25,000 \u2014 loan renewal; 975 \u2014 $94,700 \u2014 loan renewal; 976 \u2014 $47,500 \u2014 loan renewal; 977 \u2014 $164,400 \u2014 loan renewal; 983 \u2014 $121,900 \u2014 loan renewal; 986 \u2014 $30,500 \u2014 loan renewal; 1035 \u2014 $10,000 \u2014 roads; 1036 \u2014 $11,000 \u2014 roads; 1126 \u2014 $8,700 \u2014 repairs to the arena; 1135 \u2014 $44,900 \u2014 roads; 1136 \u2014 $35,000 \u2014 waterworks, sewers; 1159 \u2014 $5,000 \u2014 waterworks, dewers; 1162 \u2014 $65,000 \u2014 construction of a sports lodge; 1168 \u2014 $250,000 \u2014 roads, lighting; 1176 \u2014 $285,400 \u2014¦ waterworks, sewers; 1182 \u2014 $82,000 \u2014 waterworks, sewers, roads; 1192 \u2014 $60,000 \u2014 roads; 1195 \u2014 $264,000 \u2014 construction of a swimming pool; 1198 \u2014 $100,000 \u2014 roads, lighting.Tenders will be opened and considered at a public meeting of-the Council, or of one of its committees, as the case may be, to be held on Tuesday, March 11, 1975, at 8:00 o.clock p.m., at the Council Hall, 11211 Hébert Street, City of Montreal-North, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Montreal-North, February 14, 1975.Miss Aline Ouimet, City Clerk.City Hall, 4242 Place de l'Hôtel de ville, City of Montreal-North, P.Q.Telephone: 322-6271, code 514.60090 Town of Iberville County of Iberville Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for Bonds\" will be received by the undersigned, André-L.Frechette, Secretary-Treasurer, at the Town Hall, 645 - 1st Street, Iberville, County of Iberville, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, March 11, 1975, for the purchase of a bond issue of $240,000 for the Town of Iberville, County of Iberville, 1706 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 d'Iberville, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1995 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8J^%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er octobre et 1er avril de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent, doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 8240,000 \u2014 20 ans \tDat\te\tCapital 01\t04\t1976.\t.8 3,500 01\t01\t1977.\t.3,000 01\t04\t1978.\t.4,500 01\t04\t1979.\t.4,500 01\t01\t1980.\t.5,000 01\t04\t1981.\t.18,000 01\t04\t1982.\t.18,500 01\t04\t1983.\t.19,500 (H\t04\t1984.\t.20,500 01\t04\t1985.\t.22,500 En plus, les modalités suivantes seulement seront considérées : 1° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à la dixième année.2° Obligations échéant en série 1 à 15 ans avec le solde reporté à la quinzième année.3° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde à terme fixe 20 ans.4° Obligations échéant en série 1 à 10 ans avec le solde reporté à 10 ans pour une partie et l'autre partie à terme fixe 20 ans.Toutefois, pour cette dernière modalité, les obligations échéant à terme fixe 20 ans ne devront pas être pour un montant inférieur à 818,000, et si supérieur à ce dernier montant, cet excédent ne devra comprendre qu'un ou des amortissements annuels entiers, en tenant compte du tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis, et en commençant par les dernières années d'échéances excluant l'échéance du 1er avril 1995.Cependant, les soumissions ne devront être transmises que pour un seul des modes d'émission ci-haut et ne devront comporter qu'un seul des termes sauf dans les cas des exceptions notées.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation sauf si elles sont émises en partie à terme fixe 20 ans pour un montant supéreur à $18,000, et seul cet excédent sera rachetable par anticipation au pair le dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1995 inclusive, with interest at a rate of not less than i>Yi%, nor more than 10%, payable semiannually on October 1st and April 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975.Redemption table \u2014 821,0.000 \u2014 20 years Date Capital 01 04 1986.8,000 01 04 1987.8,500 01 04 1988 .9,500 01 04 1989.10,000 01 04 1990.11,000 01 04 1991.12,000 01 04 1992.13,000 01 04 1993.14,000 01 04 1994.16,500 01 04 1995.18,000 Moreover, the following terms and conditions only will be considered: 1.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to the tenth year.2.1 to 15-year serial bonds with the balance carried forward to the fifteenth year.3.1 to 10-year serial bonds with the balance as 20-year fixed-term bonds.4.1 to 10-year serial bonds with the balance carried forward to ten years for the one part and the other part as 20-year fixed-term bonds.However, in the case of the last method of payment, the 20-year fixed-term bonds should not be for an amount less than $18,000, and if greater than the latter amount, the said surplus should only comprise one or several complete annual reemptions, taking into account the table of redemption appearing in this notice, and starting with the last years of redemption excluding the maturity of April 1, 1995.However, tenders should be sent for one of the above methods of issue only, and should comprise one only of the terms, save in the cases of the exceptions stipulated herein.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation except if they are issued partly as 20-year fixed-term bonds for an amount greater than $18,000, and the said surplus only will be redeemable by anticipation, at par. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1707 1er avril de chaque année pour le montant annuel requis pour les fins de l'amortissement de l'émission conformément au tableau d'échéances apparaissant dans le présent avis.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La ville d'Iberville s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975 sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des règlements suivants: 347 \u2014 $500 \u2014 renouvellement d'emprunt; 407 \u2014 $13,700 \u2014 renouvellement d'emprunt; 414 \u2014 $8,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 418 \u2014 $24,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 420 \u2014 $1,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 423 \u2014 $10,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 430 \u2014 $9.000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 431 \u2014 $1,800 \u2014 renouvellement d'emprunt; 507 \u2014 855,000 \u2014 aqueduc et égouts; 520 (tel que modifié) \u2014 $47,000 \u2014 voirie; 522 \u2014 $29,500 \u2014 services récréatifs et communautaires; 531 \u2014 $18,000 \u2014 voirie; 550 \u2014 $22,500 \u2014 aqueduc et égouts.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance publique du conseil ou de l'un de ses comités, selon le cas, qui sera tenue à 8.00 heures du soir, mardi, le 11 mars 1975, Hôtel de ville, 645,1ère Rue, Iberville, comté d'Iberville, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Iberville (Comté d'Iberville).ce 17 février 1975.Le secrétaire-trésorier, André-L.Frechette.Hôtel de ville, 645, 1ère Rue, Iberville (Iberville), Québec.Téléphone: 658-2809, code 514.60089-o Commission scolaire Les Deux-Rives Siège social: 124, rue Cabot, Kénogami, (Jonquière-Kénogami), P.Q.Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par le soussigné Bernard Gagnon, directeur général.Bureau administratif, 124, rue Cabot, Kénogami, comté de Jonquière-Kénogami, P.Q., jusqu'à 8.15 heures du soir, mardi, le 11 mars 1975, pour l'achat de $357,500 d'obligations de la commission scolaire Les Deux-Rives, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1990 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8}^%, ni supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.on April 1st of each year for the annual amount required to amortize the issue, in accordance with the redemption table appearing in this notice.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Town of Iberville agrees not to bring out new-bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaws: 347 \u2014 $500 \u2014 loan renewal; 407 \u2014 $13,700 \u2014 loan renewal; 414 \u2014 $8,000 \u2014 loan renewal; 418 \u2014 $24,000 \u2014 loan renewal; 420 \u2014 $1,000 \u2014 loan renewal; 423 \u2014 $10,000 \u2014 loan renewal; 430 \u2014 $9,000 \u2014 loan renewal; 431 \u2014 $1,800 \u2014 loan renewal; 507 \u2014 $55,000 \u2014 waterworks and sewers; 520 (as amended) \u2014 $47,000 \u2014 roads; 522 \u2014 $29,500 \u2014 recreational and community services \u2014 531 \u2014 $18,000 \u2014 roads; 550 \u2014 $22,500 \u2014 waterworks and sewers.Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council, or of one of its committees, as the case may be, to be held at 8:00 o'clock p.m., on Tuesday, March 11, 1975, at the Town Hall, 645 \u2014 1st Street, Iberville, County of Iberville, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Iberville (County of Iberville), February 17, 1975.André-L.Frechette, Secretary-Treasurer.Town Hall, 645-1st Street, Iberville (Iberville), P.Q.Telephone: 658-2809, code 514.60089 Les Deux-Rives School Board Head office: 124 Cabot Street Kénogami, (Jonquière-Kénogami), P.Q.Public notice is herby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Bernard Gagnon, Director-General, at the Administration Office, 124 Cabot Street, Kénogami, County of Jonquière-Kénogami, P.Q., until 8:15 o'clock p.m., on Tuesday, March 11, 1975, for the purchase of a bond issue of $357,500 for the Les Deux-Rives School Board, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1990 inclusive, with interest at a rate of not less than 8M%, nor more than 10%, payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975. 1708 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Tableau d'amortissement \u2014 $357,500 \u2014 15 ans Date CapiUl 01 04 1976.$17,500 01 04 1977.19,000 01 04 1978 .21,000 01 04 1979.23,000 01 04 1980.26,000 01 04 1981.33,000 01 04 1982.36,000 01 04 1983 .39,000 La commission scolaire Les Deux-Rives, se prévalant de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi des subventions aux commissions scolaires (Chapitre 63 des Lois de 1968) (Bill 64), demandera au ministre de l'éducation d'effectuer à même les subventions à être versées par lui annuellement à ladite corporation scolaire, le dépôt en fidéicommis, entre les mains du ministre des finances, des sommes suffisantes pour acquitter en totalité le principal et les intérêts de la présente émission d'obligations et de tout renouvellement d'icelle si requis.De plus, des soumissions pourront être envoyées et elles seront prises en considération pour des obligations à courte échéance 10 ans.Cependant, les soumissions ne devront comporter qu'un seul des 2 termes.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'adjudicaUire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capiUl, plus les intérête courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capiUl et les intérête sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas racheUbles par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du monUnt de l'emprunt.La commission scolaire Les Deux-Rives s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975, sans une autorisation écrite de l'adjudi-caUire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu des résolutions suivantes: 14 octobre 1969 \u2014 $86,000 \u2014 renouvellement d'emprunt; 14 janvier 1975 \u2014 $3,500 \u2014 frais de refinancement; 26 novembre 1974 \u2014 $268,000 \u2014 dépenses d'immobilisations.Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance des commissaires d'écoles qui sera tenue mardi, le 11 mars 1975 à 8.15 heures du soir.Bureau administratif, 124, rue Cabot, Kénogami, (Jonquière-Kénogami), P.Q.Les commissaires d'écoles se réservent le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Les Deux-Rives (comté de Jonquière-Kénogami).Le directeur général, Bernard Gagnon.Bureau administratif, 124, rue Cabot, Kénogami (Jonquière-Kénogami), P.Q.Téléphone: 547-3693, code 418.60100-o Redemption table \u2014 $357,500 \u2014 16 years Date CapiUl 01 04 1984.43,000 01 04 1985.47,000 01 04 1986.9,000 01 04 1987.10,000 01 04 1988.11.000 01 04 1989.11.000 01 04 1990.12,000 The Les Deux-Rives School Board, in conformity with section 1 of the Act to amend the School Board Grants Act (Chapter 63 of the Sututes of 1968) (Bill 64), will request the Minister of Education to deposit in trust, with the Minister of Finance, from the grants to be awarded annually by him to the said school corporation, the sums sufficient to pay off in full the principal and interest of this issue and any renewal thereof, if required.Moreover, tenders may be sent and they will be considered for 10-year short-term bonds.However, tenders shall comprise one only of the two terms.Adjudication will be made according to law.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price mentioned in his tender, covering capiUl and any interest, by certified cheque.CapiUl and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Les Deux-Rives School Board agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1.1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following resolutions: October 14, 1969 \u2014 $86,000 \u2014 loan renewal; January 14, 1975 \u2014 $3,500 \u2014 refinancing costs; November 26, 1974 \u2014 $268,000 \u2014 capital expenditure.Tenders will be opened and considered at a meeting of the School Commissioners to be held on Tuesday, March 11, 1975, at 8:15 o'clock p.m., at the Administration Office, 124 Cabot Street, Kénogami (Jonquière-Kénogami), P.Q.The School Commissioners do not bind themselves to accept the highest or any of the tenders.Les Deux-Rives (County of Jonquière-Kénogami).Bernard Gagnon, Director-General.Administration Office, 124 Cabot Street, Kénogami (Jonquière-Kénogami), P.Q.Telephone: 547-3693, code 418.60100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1976, 107' année, n° 8 1709 Paroisse de Saint-An ion in Comté de Rivière-du-Loup Avis public est par les présentes donné que des soumissions cachetées et portant l'inscription « Soumissions pour obligations » seront reçues par la soussignée Mme Etienne Thibault, secrétaire-trésorière, Bureau municipal, paroisse de St-Antonin, comté de Rivière-du-Loup, P.Q., jusqu'à 8.00 heures du soir, mercredi, le 12 mars 1975, pour l'achat de $1,000,000 d'obligations de la paroisse de St-Antonin, comté de Rivière-du-Loup, datées du 1er avril 1975 et remboursables en série du 1er avril 1976 au 1er avril 1985 inclusivement, avec intérêt à un taux non inférieur à 8J4%, °i supérieur à 10%, payable semi-annuellement les 1er avril et 1er octobre de chaque année.Le taux d'intérêt peut être le même pour toute l'émission; cependant, si plus d'un taux est utilisé, le montant émis à chaque taux différent doit couvrir un ou des amortissements annuels entiers, tel que montré au tableau d'amortissement dans le présent avis.Pour fins d'adjudication seulement, l'intérêt sera calculé à compter du 1er avril 1975.Tableau d'amortissement \u2014 $1.000,000 \u2014 10 ans Date Capital 01 04 1976.$ 64,000 01 04 1977.70,000 01 04 1978.77,000 01 04 1979 .84,000 01 04 1980.93,000 On est prié de noter que les soumissions sont demandées pour des obligations remboursables suivant le tableau ci-dessus seulement, et que les offres qui seront faites pour des obligations à courte échéance ne seront pas prises en considération.L'adjudication sera faite conformément à la loi.L'échéance du 1er avril 1985 au montant de $146,000 comprend un solde renouvelable de $1,000 pour une période additionnelle de 10 ans.L'adjudicataire s'engage à payer les obligations au prix indiqué dans sa soumission, en capital, plus les intérêts courus s'il y a lieu, par chèque visé.Le capital et les intérêts sont payables à toutes les succursales au Canada de la banque dont le nom est mentionné dans la procédure d'emprunt.Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque visé égal à 1% du montant de l'emprunt.La paroisse de St-Antonin s'engage à ne pas émettre de nouvelles obligations sur le marché public canadien dans les soixante jours à compter du 1er avril 1975, sans une autorisation écrite de l'adjudicataire de la présente émission.Lesdites obligations seront émises en vertu du règlement suivant: 126 \u2014 $1,000.000 \u2014 réseau d'aqueduc et d'égouts.Parish of Saint-Antonin County of Rivière-du-Loup Public notice is hereby given that sealed tenders marked \"Tenders for bonds\" will be received by the undersigned, Mrs.Etienne Thibault, Secretary-Treasurer, at the Municipal Office, Parish of Sant-Antonin, County of Rivière-du-Loup, P.Q., until 8:00 o'clock p.m., on Wednesday, March 12, 1975, for the purchase of a bond issue of 81,000.000 for the Parish of Saint-Antonin, County of Rivière-du-Loup, dated April 1, 1975 and redeemable serially from April 1, 1976 to April 1, 1985 inclusive, with interest at.a rate of not less than 8V£%, nor more than 10%, payable semiannually on April 1st and October 1st of each year.The rate of interest may be the same for the whole issue; however, should more than one rate be used, the amount issued at each different rate must cover one or several complete annual redemptions, as shown in the redemption table in this notice.For adjudication purposes only, interest will be calculated as from April 1, 1975.Redemption table \u2014 tl,000,000 \u2014 10 years Date Capital 01 04 1981 .$101,000 01 04 1982.111,000 01 04 1983.121,000 01 04 1984.133,000 01 04 1985.146,000 It is to be noted that the tenders are called for bonds redeemable as per the above table only, and that offers which might be made for short-term bonds will not be considered.Adjudication will be made according to law.The maturity of April 1, 1985 in the amount of $146,000 includes a balance of $1,000 renewable for an additional 10-year period.The successful tenderer agrees to pay for the bonds at the price indicated in his tender, covering capital and any interest, by certified cheque.Capital and interest are payable at all branches in Canada of the bank mentioned in the loan procedure.The said bonds will not be redeemable by anticipation.Each tender must be accompanied by a certified cheque equal to 1% of the amount of the loan.The Parish of Saint-Antonin agrees not to bring out new bonds on the Canadian Public Market within the sixty days upon, from and after April 1, 1975, without written authorization from the successful tenderer of the present issue.The said bonds will be issued pursuant to the following bylaw: 126 \u2014 $1,000,000 \u2014 waterworks and sewer system. 1710 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Les soumissions seront ouvertes et considérées à une séance du conseil qui sera tenue mercredi, le 12 mars 1975, à 8.00 heures du soir, Bureau municipal, paroisse de St-Antonin, comté de Rivière-du-Loup, P.Q.Le conseil se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions.Saint-Antonin, (Comté de Rivière-du-Loup), ce 12 février 1975.La secrétaire-trêsorière, Mme Etienne Thibault.Bureau municipal, St-Antonin (Rivière-du-Loup), P.Q.Téléphone: 862-3099, 862-4489, code 418.60034-o Ventes pour taxes Cité de Saint-Hyacinthe Avis public est par les présentes donné que les immeubles ci-dessous décrits, situés dans la cité de Saint-Hyacinthe, seront vendus à l'enchère publique, à la salle du conseil municipal, à l'hôtel de ville, au 750, de l'avenue de l'Hôtel-de-ville, en les cité et district de Saint-Hyacinthe, MARDI, le DIX-HUITIÈME jour de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour satisfaire au paiement des taxes municipales, avec intérêts plus les frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente: 1.Comme appartenant à Régent (alias Réjean) Turcotte: un immeuble situé rue Saint-Antoine, désigné comme étant une partie du lot deux cent vingt-deux (Ptie 222) au cadastre officiel de la cité de Saint-Hyacinthe; borné en front, au nord-ouest, par la rue Saint-Antoine; en arrière, au sud-est, par le lot No 221; d'un côté, au nord-est, par le résidu du lot No 222, et de l'autre côté, au sud-ouest, par les lots Nos 223 et 224 ; avec une maison portant le numéro civique 1055 de la rue Saint-Antoine, circonstances et dépendances.Taxes: 8341.57 2.Comme appartenant à Régent (alias Réjean) Turcotte, comme grevé de la substitution créée par le testament de feu Jacques Turcotte: a) un immeuble situé avenue de la Concorde, désigné comme étant le lot No 366 au cadastre de la Cité de Saint-Hyacinthe; avec deux maisons y érigées, portant les numéros civiques 465 à 485 de l'avenue de la Concorde, circonstances et dépendances.Taxes: $861.82 6) un immeuble situé avenue de la Concorde, désigné comme étant une partie du lot trois cent soixante-douze (Ptie 372) au cadastre de la Cité de Saint-Hyacinthe, borné au nord-est par le lot No 377, au sud-est Tenders will be opened and considered at a public meeting of the Council to be held on Wednesday, March 12, 1975, at 8:00 o'clock, p.m., at the Municipal Office, Parish of Saint-Antonin, County of Rivière-du-Loup, P.Q.The Council does not bind itself to accept the highest or any of the tenders.Saint-Antonin, (County of Rivière-du-Loup), February 12, 1975.Mrs.Etienne Thibault, Secretary-Treasurer.Municipal Office, Saint-Antonin (Rivière-du-Loup), P.Q.Telephone: 862-3099, 862-4489, code 418.60034 Sales for taxes City of St.Hyacinthe Public notice is hereby given that the hereinafter described immoveable properties, located in the City of Saint-Hyacinthe, will be sold by public auction in the Council Room of City Hall, located at 750 Hôtel-de-ville Avenue, in the City and District of Saint-Hyacinthe, on TUESDAY, the EIGHTEENTH day of MARCH, 1975, at TEN o'clock in the forenoon, to satisfy to the payment of municipal taxes, with interest and costs incurred thereon, unless the said taxes, interest and costs be paid before the sale : 1.As belonging to Régent (alias Réjean) Turcotte: an immoveable located on Saint-Antoine Street, designated as being part of lot number two hundred and twenty-two (Pt.222) on the official book of reference for the City of Saint-Hyacinthe; bounded in front, to the northwest, by Saint-Antoine Street; in the rear, to the southeast, by lot No.221; on one side, to the northeast, by the residue of lot No.222, and on the other side, to the southwest, by lots Nos.223 and 224; with a building thereon erected bearing civic number 1055 of Saint-Antoine Street, circumstances and dependencies.Taxes: $341.57.2.As belonging to Régent (alias Réjean) Turcotte, as institute of the substitution created by the last will and testament of the late Jacques Turcotte: (a) an immoveable located on De la Concorde Avenue, designated as lot No.three hundred and sixty-six (366) on the official book of reference of the City of Saint-Hyacinthe; with 2 buildings thereon erected, bearing civic numbers 465 to 485 of De la Concorde Avenue, circumstances and dependencies.Taxes: $861.82.(6) an immoveable located on De la Concorde Avenue, designated as part of lot number three hundred and seventy-two (Pt.372) on the book of reference for the City of Saint-Hyacinthe; bounded to the northeast GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, SU février 1975, 107' année, n° 8 1711 par le lot No 371, au sud-ouest par l'avenue de la Concorde et au nord-ouest par le résidu du lot No 372 ; avec deux maisons y érigées, portant les numéros civiques 440, 450 et 460 de l'avenue de la Concorde, circonstances et dépendances.Taxes: 8565.33 c) un terrain situé à l'angle des rues Saint-Antoine et de Vaudreuil, désigné comme étant le lot numéro quatre cent deux (402) au cadastre de la Cité de Saint-Hyacinthe.Taxes: $513.18 d) un immeuble situé avenue de la Concorde, désigné comme étant le lot numéro six cent quarante-deux (642) au cadastre officiel de la Cité de Saint-Hyacinthe; avec une maison y érigée, portant les numéros civiques 666, 670 et 674 de l'avenue de la Concorde, circonstances et dépendances.Taxes: $350.29 e) un immeuble situé rue Bibeau, désigné comme étant une partie du lot numéro soixante-trois (Ptie 63) au cadastre de la Cité de Saint-Hyacinthe, borné au front par la rue Bibeau, à la profondeur paT le lot No 62, au nord-est par le résidu du lot No 63, et de l'autre côté par les lots Nos 64 et 65; à distraire cependant la partie prise pour l'élargissement de la rue Bibeau; avec une maison y érigée, portant les numéros civiques 950 à 954 de la rue Bibeau, circonstances et dépendances.Taxes: $254.76 f) un immeuble situé rue Bibeau, désigné comme étant le lot numéro 16 au cadastre de la Cité de Saint-Hyacinthe; moins, à en distraire, la partie cédée pour l'élargissement de l'avenue Sainte-Marie; avec une maison y érigée, portant les numéros civiques 74 et 76 de l'avenue Sainte-Marie, circonstances et dépendances.Taxes: $130.37 g) un immeuble situé à l'angle des rues Saint-Antoine et Brodeur, désigné comme étant le lot numéro trois cent quatre-vingt-douze (392) au cadastre officiel de la Cité de Saint-Hyacinthe; avec trois maisons y érigées, portant les numéros civiques 410 à 412, 430 à 432 de l'avenue Brodeur, et 888 à 890 de la rue Saint-Antoine, circonstances et dépendances.Taxes: $374.48 h) un terrain situé sur la rue Marguerite-Bourgeois, désigné comme étant une partie du lot numéro deux cent-neuf (Ptie 209) au cadastre officiel de la cité de Saint-Hyacinthe, mesurant trente-six pieds de largeur sur quatre-vingt-dix pieds de profondeur, plus ou moins; limité au front par la rue Marguerite-Bourgeois, à la profondeur par le terrain de Michel Langevin ou représentants, d'un côté par l'avenue Brodeur, et de l'autre côté par le terrain de Joseph Frenière ou représentants.Taxes: $268.40 Saint-Hyacinthe, le 3e jour du mois de février, 1975.Le greffier, 60003-7-2-o Richard Bousquet.by lot No.377, to the southeast by lot No.371, to the southwest by De la Concorde Avenue, and to the northwest by the residue of lot No.372; with 2 buildings thereon erected, bearing civic numbers 440, 450 and 460 of De la Concorde Avenue, circumstances and dependencies.Taxes: 8565.33.(c) a vacant lot located at the corner of Saint-Antoine and De Vaudreuil Streets, designated as lot number four hundred and two (402) on the official book of reference for the City of Saint-Hyacinthe.Taxes: $513.18.(d) an immoveable located on De la Concorde Avenue, designated as lot number six hundred and forty-two (642) on the official book of reference for the City of Saint-Hyacinthe; with a building thereon erected, bearing civic numbers 666, 670 and 674 of De la Concorde Avenue, circumstances and dependencies.Taxes: $350.29.(e) an immoveable located on Bibeau Street, designated as part of lot number sixty-three (Pt.63) on the official book of reference for the City of Saint-Hyacinthe, bounded to the front by Bibeau Street, to its depth by lot No.62, to the northeast by the residue of lot No.63, and on the other side by lots Nos.64 and 65; to be distracted from said part the lane used for the widening of Bibeau Street; with a building thereon erected, bearing civic numbers 950 to 954 of Bibeau Street, circumstances and dependencies.Taxes: $254.76 (/) an immoveable located on Bibeau Street, designated as lot number sixteen (16) on the official book of reference of the City of Saint-Hyacinthe, less, to be distracted, the lane used for the widening of Sainte-Marie Avenue; with a building thereon erected, bearing civic numbers 74 and 76 of Sainte-Marie Avenue, circumstances and dependencies.Taxes: $130.37 (g) an immoveable located at the corner of Saint-Antoine and Brodeur Streets, designated as lot number three hundred and ninety-two (392) on the official book of reference of the City of Saint-Hyacinthe; with three buildings thereon erected, bearing civic numbers 410 to 412, 430 to 432 of Brodeur Avenue, and 888 to 890 of Saint-Antoine Street, circumstances and dependencies.Taxes: $374.48 (h) a vacant lot located on Marguerite-Bourgeois Street, designated as part of lot number two hundred and nine (Pt.209) on the official book of reference for the City of Saint-Hyacinthe, measuring 36 feet in width by 90 feet in depth, more or less; bounded to its front by Marguerite-Bourgeois Street, to its depth by Michel Langevin or representatives, to one side by Brodeur Avenue, and to the other side by Joseph Frenière or representatives.Taxes: $268.40 Saint-Hyacinthe, this 3rd day of February, 1975.Richard Bousquet, 60003-7-2-o CiVy Clerk. 1712 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1976, Vol.107, No.8 Municipalité du comté de Saguenay Avis est par la présente donné par le soussigné, secrétaire-trésorier de la municipalité du comté de Saguenay, que les propriétés ci-après désignées seront vendues à l'enchère publique à l'Hôtel de ville de Tadoussac, chef lieu de la corporation du comté de Saguenay, JEUDI, le TREIZIÈME jour de MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, avec intérêts plus les frais encourus subséquemment à moins que ces taxes, intérêts et dépenses ne soient payés avant cette date.Municipality of the County of Saguenay Notice is hereby given by the undersigned, Secretary-Treasurer of the Municipality of the County of Saguenay, that the immoveable properties hereinafter described will be sold by public auction at the Town Hall of Tadoussac, County Seat for the Corporation of the County of Saguenay, on THURSDAY, the THIRTEENTH day of MARCH, 1975, at TEN o'clock in the forenoon, for the payment of municipal and school taxes with interest, plus the costs incurred subsequently, unless said taxes, interests and costs are paid prior to the date of sale.Tadoussac\t\t\t\t\t Propriétaire\tLots et Rang\tTaxes mun.\tTaxes scol.\tFrais\tTotal Owner\tLots and Range\tMun.taxes\tSchool taxes\tCosts\t \t563-597-598-599-600-601-561-560.\t% 10.00\t\t$ 20.00\t$ 30.00 Sacré-Coeur\t\t\t\t\t Roger Lavoie, Succession de / Estate of Ray-uond Savard de Rivière-Port neuf.\t12 Sud Chemin Albert 2 x 2H arpents.\tS 241.49\t$ 804.96\t$ 20.00\t$1,066.45 Bergeron nés\t\t\t\t\t Victorien Gagnon \u2014 Terrain faisant partie du lot 42 rang 2 mesurant environ 10O pieds de largeur au chemin public, sur environ 200 pieds de profondeur, compris dans les bornes suivantes: au sud-est par la route régionale numéro 15: au nord-ouest par la rivière Bergeronnes; au sud-ouest par une partie du lot 42 appartenant à la Compagnie d'essence Fina aux représentants et au nord-est par une partie du lot 42 appartenant à Adélard Gagnon ou représentants, avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances.Les lots ou parties de lots mentionnés ci-dessus font partie du cadastre officiel du Canton Bergeronnes.Cette vente a pour but d'apporter une correction de lot, dont vente avait été faite le 16 février 1971 par Hervé Simard, sécréta ire-trésorier de Bergeronnes.Victorien Gagnon \u2014 A piece of land forming part of lot 42 in Range 2, measuring approximately 100 feet in width along the public road, by approximately 200 feet in depth, comprised within the following boundaries: on the southeast by Regional Road number 15; on the northwest by the Bergeronnes River; on the southwest by a part of lot 42 belonging to Fina Gas Company or representatives and on the northeast by a part of lot 42 owned by Adélard Gagnon or representatives, with the buildings erected thereon, appurtenances and dependencies.The lots or parts of lots aforementioned form part of the official cadastre for the Township of Bergeronnes.This sale is made for the purpose of rectifying the sale of a lot which had been effected on February 16, 1971, by Hervé Simard, Secretary-Treasurer of Bergeronnes.Escoumins Adrien Gobeil.Lot 13-P-2-Rg, Bâtisse et dépendances / Building and depen-dencies.Georges Albert Létourneau.Lot A-2-4 Rg A, Bâtisse et dépendances/ Building and dependencies.Andreas Martel.Lot 16-B-4 Rg 1, Bâtisses et dépendances j Building and de~ pendencies.Georges Roussell.Lot ll-A-12 Rg 1, Bâtisse et dépendances / Building and dependencies.Joseph Théodore Tremblay.Lot 16-B-3 Rg 1, & 17 A-Pt.91.89\t$ 213.16 S\t6.00\t8 311.05 166.30\t166.93\t6.00\t328.23 44.72\t250.03\t6.00\t300.75 216.11\t220.62\t6.00\t442,63 217.76\t605.71\t6.00\t829.46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, £2 fêrrier 1975, 107' année, n° S 1713 Propriétaire Owner Lots et Rang Lota and Range Taxes mun.Mun.taxe» Taxes ¦col.School taxée Frais Costs Total Théodore Tremblay.Lot 17-A Un 1.Bâtisse et dêpen- f 161.12 dances / Building and dcpen~ S 182.00 $ 6.00 S 339.12 J.Alfred Therrien.Sauf et à distraire la partie de terrain appartenant au ministère de la Voirie reçu par M.Gaston Lacourcière, enregistré a la division d'enregistrement du Saguenay.sous le numéro d'enregistrement portant le numéro 67185 en date du 8 mai 1970 pour 280 pieds carrés.Cette vente a pour but d'apporter une correction de la vente faite le 9 mars 1972 par le conseil de comté de Saguenay.dencies.Lot 13-F-4 Rg-1, Bâtisse et dépendances / Building and de-pendencie8.Canton Escoumins Township.Less and to be withdrawn the piece of land belonging to the Department of Roads, according to a deed executed before Me Gaston Lacourcière.registered at the Saguenay Registration Division, under number 67185, dated May 8, 1970, and covering 280 square feet.This sale is made for the purpose of rectifying the sale effected on March 9, 1972, by the Council of the County of Saguenay.Fait ¦ i Grantles-Bergeronnes, ce Se jour de février 1975.Le secrétaire-trésorier, 60015-7-2-O Paul Bouchard.Given in Grandes-Bergeronncs, this 8th day of February, 1975.Paul Bouchard, 60015-7-2 Secretary-Treasurer.Municipalités et commissions scolaires du comté d'Abitibi Avis vous est par la présente donné par le soussigné, Guy Corriveau, secrétaire-trésorier de la corporation du comté d'Abitibi que les immeubles avec bâtisses, circonstances et dépendances ci-après détaillés seront vendus à l'enchère publique au Palais de Justice d'Amos, au lieu ordinaire des sessions de ce conseil, JEUDI, le DIXIÈME jour d'AVRIL 1975, à DIX heures de l'avant-midi, pour non-paiement de taxes municipales, scolaires et autres redevances, frais et charges dus sur chacun de ces immeubles, à moins que ces taxes, frais et charges ne soient plus tôt payés et acquittés avec les frais encourus avant la vente; savoir: Municipalities and School Boards of the County of Abitibi Notice is hereby given by the undersigned, Guy Corriveau, Secretary-Treasurer of the Corporation of the County of Abitibi that the immoveables, with buildings, appurtenances and dependencies hereinafter described will be sold by public auction at the Court House of Amos, where the Council usually holds its meetings, on THURSDAY, the THIRTEENTH day of APRIL, 1975, at TEN o'clock in the forenoon, for non payment of municipal and school taxes and other dues, costs and charges due on each of these immoveables, unless such taxes, costs and charges are paid, together with the costs incurred, before the date of the sale; to wit: Commission scolaire d'Amos / Amos School Board \t\tRangs\t\tTaies\tTaxes\t\t Cantons\tLots\tBlocs\tPropriétaires\tmunie.\tscol.\tAutres\tTotal Townships\t\tRanges\tProprietors\tMunie.\tSchool\tOthers\t \t\tBlock\t\ttaxes\ttaxes\t\t Berry.63.2.Wilfrid La verdure.$ 200.56 Î 200.66 Berry.33.6.Jean-Claude Tanguay.66.28 66.28 Berry.62.1.OctaveTessier.438.15 438.16 Dalquier.P.13.4.Georges Guillemette.132.07 132.07 Figuery.56.4.Y von Corriveau.378.96 378.95 Guyenne.42-43 .6.Caietan Corriveau.218.36 218.36 La Motte.Ji Est 42 .4.Roland Châteauneuf.20.74 20.74 La Motte.26.3.Germain Demers.172.88 172.88 La Motte.16.1.S.A.Fenn.95.32 96.32 La Motte.Emp.sur/on 6.Roger Rhéaume Suce.66.10 66.10 46 (SuperBcie 90' x 169' approximatif.) (Approximative area of 90' x 169'.) Landrienne.23.6.Yvon Lorenger.101.12 101.12 La Pause.71.A.Roger Poulin.71.31 71.31 1714 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Rangs .Taxes Taxes Cantons Blocs Propriétaires munie.scol.Autres Lots Total Township* Ranges Proprietors Munie.School Others Blocks taxes taxes 3.Fernand Bélanger.3.Almanzor Hervieux .9.Eugène Perrault Suce.5.Yves Cloutier.1.Emile Gignac.Launay.16.Launay.9.Preissac.D.Trécesson.10 A-B____ Trécesson.23.Trécesson.46.7.Robert Légaré.Trécesson.44.8.Robert Légaré.Villemontel.4.1.Jean Béchard Suce.Villemontel.16.8.Donat Dessurault Suce.Villemontel.F.10.Jean-Guy Duranceau.La Motte.Emp.sur/on 4.Charles-Eugène Langevin .8 72.18 94.73 22.61 289.74 113.19 25.67 59.91 28.04 54.80 56.84 102.66 72.18 94.73 22.61 289.74 113.19 25.67 59.91 28.04 54.80 56.84 102.66 Corporation municipale du canton Clermont / Municipal Corporation of the Township of Clermont Clermont.\t.16.\t____2.\t.Emilien Bourdeau Succ.\t.16.\t____3.\t.Emilien Bourdeau Succ.\t.18.\t.4.\t.Emilien Bourdeau Succ.\t.21.\t____6.\t \t.6.\t.4\t.Alexandre Gibeault.Clermont.\t.6.\t____4\t \t.8.\t____4\t Clermont.\t.9.\t.4.\t.Alexandre Gibeault.Clermont.\t.29.\t____3.\t Clermont.\t.23.\t____4.\t.Donald Labelle.3.21 S\t30.35 2.91\t51.43 6.30\t114.97 7.52\t68.06 3.45\t42.38 4.61\t56.88 8.06\t99.24 4.25\t62.06 6.22\t65.04 91.20\t391.81 33.66 54.34 121.27 75.58 45.83 61.49 107.30 56.30 71.26 483.01 Commission scolaire Barraute-Senneterre \u2014 The Barraule-Senneterre School Board Fiedmont.\tP.28____\t.6.\t.Mme Marie-Rose Matte \t.P.30 A\t.6.\tMme Simone Bergeron Fiedmont.\tP.30 B.\t.6.\t.Mme Simone Bergeron.\tP.30 C.\t.6.\t.Mme Simone Bergeron.\tP.30 D .\t.6.\t.Mme Simone Bergeron.Fiedmont.\t.P.38-2.\t.8\t 31.42 $\t2.19 $\t33.61 46.35\t1.41\t47.76 4.57\t\t4.67 13.20\t1.29\t14.49 9.14\t\t9.14 12.36\t\t12.36 Commission scolaire de Malartic \u2014 The Malartic School Board Malartic.Malartic.Dubuisson.P.3.7.P.J.6.P.18-19.B.Motel Albert Enr.Charles-René Lalande.Les Glaises Hitland Inc.8 819.26 S 6.82 1,464.63 25.41 8 844.67 0.80 7.62 82.05 1,546.58 Commission scolaire de Rouyn-Noranda \u2014 The Rouyn-Noranda School Board Dufresnoy.P.86.(Superficie 150' x 600'.) Dufresnoy.P.86.(Superficie 50' x 160'.) Est.Jean-Guy Jacques, (Superficie / (Area 150' x 500'.) Est.Normand Veilleux, (Superficie/ (Area 50' x 150'.) Dufresnoy.M Sud 48-A VI Cléricy.3.Dufresnoy.66.La Pause.2.Cléricy.27.Cléricy.6-14.Cléricy.6-17.Ephrem Perreault.IV.Albert Leclerc.VII .Gérard Robin.Lac Martial Davidson (Chalet \u2014 pas Bellot fond de terre).V.Réal Lachance.VI.Jack C.Fisher.VI.William Jeansen.8 386.03 S 45.70 8 430.73 463.96\t56.06\t620.01 68.65\t10.51\t69.06 64.61\t9.46\t74.07 94.82\t9.80\t104.62 61.90\t9.93\t71.83 149.71\t20.28\t169.99 29.44\t6.31\t36.76 29.44\t6.31\t35.76 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1075.107- année, n° 8 1715 Corporation municipale de St-Félix-de-Dalquier \u2014 Municipal Corporation of Saint-Fêlix-dc-Dalquicr \t\tRangs\t\tTaxes\tTaxes\t\t Cantons\tLots\tBlocs\tPropriétaires\tmunie.\tscol.\tAutres\tTotal Townships\t\tRangea Blocks\tProprietors\tMunie, taxes\tSchool taxes\tOthers\t Dalquier.39.VI.Léo Gauthier.8 9.15 8 23.10 S 32.25 Dalquier.4.& 6.X.Emile Lavigne.9.28 22.80 32.08 Dalquier.8.X.Gilles Cossette.9.50 10.20 19.70 Dalquier.Jean Bégin.16.20 78.00 94.20 Un emplacement situé sur le lot 22, rang VII, canton Dal- An emplacement located on lot 22, Range VII.Township quier borné comme suit: au nord par le chemin public, à l'est of Dalquier, bounded as follows: on the north by the public par la ligne des lots 22 et 23, au sud à 75 pieds du chemin road, on the east by the line of lots 22 and 23, on the south public, à l'ouest à 175 pieds de la ligne est du lot 22.at a distance of 75 feet from the public road, on the west at a distance of 175 feet from the east line of lot 22.Commission scolaire de Val-D'Or \u2014 The Val-D'Or School Board Senneville.P.36.Louvicourt.60 3.3.Luc Lavoie 6.Hervé Lalonde.125.62 S 571.47 37.71 8 138.25 163.33 709.72 Donné à Amos, au bureau de la corporation du comté d'Abitibi, ce 6e jour de février 1975.(Sceau) Le secrétaire-trésorier, 60014-7-2-o Guy Corriveau.Given in Amos, at the Office of the Corporation of the County of Abitibi, this 6th day of February, 1975.(Seal) Guy Corriveau, 60014-7-2-o Secretary-Treasurer.Associations cooperatives Cooperative Associations CONSEIL DES COOPERATIVES DE L'OUTAOUAIS (Loi des associations coopératives) Le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, donne avis qu'en vertu de la Loi des associations coopératives, il a approuvé la formation d'une association sous le nom de « CONSEIL DES COOPERATIVES DE L'OUTAOUAIS ».dont le siège social est situé à Hull.Québec, dans le district électoral de Hull.Le sous-ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, 60047-o Albert Jessop.CONSEIL DES COOPERATIVES DE L'OUTAOUAIS (Cooperative Associations Act) The Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives gives notice that pursuant to the Cooperative Associations Act, he has approved the formation of a cooperative association under the name of \"CONSEIL DES COOPERATIVES DE L'OUTAOUAIS\", with its head office located in Hull.Québec, in the Electoral District of Hull.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions.60047 Companies and Cooperatives.CLUB COOPER VTIF DE CONSOMM VTION DE L\\ RIVE-SUD (Loi des associations coopératives) Avis est donné que le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives, a approuvé le règle-ment spécial du « CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE LA RIVE-SUD », adopté le 19 novembre 1974, changeant le montant de la part sociale de 850 à $75.Le sous-ministre des institutions financières, compagn les et coopératives, 60051-o Albert Jessop.CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE LA RIVE-SUD (Cooperative Associations Act) Notice is given that the Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives has approved the special bylaw of \"CLUB COOPERATIF DE CONSOMMATION DE LA RIVE-SUD \", adopted on November 19, 1974, changing the amount of each corporate share from 850 to $75.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, 60051 Companies and Cooperatives. 1716 QUÉBEC OFFICIAT.GAZETTE, February 22.1975, Vol.107, No.8 Commission des transports du Québec Québec Transport Commission Aux fins de faciliter la recherche, la Commission a regroupé, sous différentes rubriques, les avis qu'elle doit donner conformément à la Loi des transports (L.Q.1972, ch.55 et ses amendements) et au Règlement 2 sur les règles de pratique et de régie interne (A.C.2619-73 et ses amendements).Ces rubriques sont identifiées de la façon suivante: I \u2014 Avis de la Commission « proprio motu » (Règlement 2, a.2.24) : 1 \u2014 Vérification de permis (a.2.59).2 \u2014 Autres affaires.[I \u2014 Avis d'introduction de requêtes (Règlement 2, a.2.3) : 1 \u2014 Demande dc permis ou de modification de permis.a) transport général de personnes.b) transport général de choses.c) transport de matières en vrac.d) transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).2 \u2014 Demandes de vérification de permis (a.2.59) 3 \u2014 Demandes de modification ou d'annulation de contrat de transport d'écoliers (a.2.60).4 \u2014 Autres affaires.III \u2014 Avis d'opposition à une modification de certains tarifs (a.2.64).rV \u2014 Avis dc désistement.V \u2014 Avis de décisions rendues : 1 \u2014 Dans les affaires introduites par la Commis- sion « proprio motu ».a) vérification de permis.b) autres affaires.2 \u2014 Dans les affaires introduites par requêtes.a) affaires contestées.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime OU aérien (personnes et choses).b) affaires non contestées.i.membre siégeant seul.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses).In order to facilitate reference, the Commission has regrouped, under separate headings, the notices that it is required to give in conformity with the Transport Act (S.Q.1972, ch.55 and its amendments) and Regulation 2 respecting the rules of practice and rules for internal management (O.C.2619-73 and its amendments).These headings are identified as follows: I \u2014 Notice \"proprio motu\" by the Commission (Regulation 2, s.2.24) : 1.\u2014 Verification of permit (s.2.59).2.\u2014 Other proceedings.II \u2014 Notice of submission of application (Regu- lation 2, s.2.3) : 1.\u2014 Application for permit or for modification of permit.(a) General transport of persons.(b) General transport of things.(c) Transport of bulk material.(d) Transport by rail, by sea or by air (persons and things).2.\u2014 Applications for verification of permits (s.2.59).3.\u2014 Applications for modification or cancellation of a contract for the transport of pupils (s.2.60).4.\u2014 Other proceedings.III \u2014 Notice of objection to a change of certain tariffs (s.2.64).IV \u2014 Notice of withdrawal.V \u2014 Notice of decisions rendered : 1.\u2014 In proceedings introduced \"proprio motu\" by the Commission.(a) Verification of permits.(b) Other proceedings.2.\u2014 In proceedings introduced by application.(a) Contested proceedings.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).(b) Non-contested proceedings, i.Member sitting alone.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things). GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, S3 février 1975, 107- année, n° 8 1717 ii.au moins trois membres.\u2014 transport général de personnes.\u2014 transport général de choses.\u2014 transport de matières en vrac.\u2014 transport ferroviaire, maritime ou aérien (personnes et choses.) vérification de permis annulation ou modification de contrat de transport d'écoliers.* permis spéciaux.Dans certains cas de demandes de permis spéciaux, les publications peuvent avoir été faites dans les journaux de la région.(c) (d) (e) ii.At least three members.\u2014 General transport of persons.\u2014 General transport of things.\u2014 Transport of bulk material.\u2014 Transport by rail, by sea or by air (persons and things).Verification of permits.Cancellation or modification of contract for the transport of pupils.* Special permits.In certain cases of application for special permits, publications may be made in local newspapers.Catégorie Class Sous-catégories Sub-classes Codes Montréal Québec Couleurs Numéros de dossiers Colours File numbers Transport public Public transport Transport général General trjicking Location Leasing Transport spécialisé Specialized transportation Voyageur MPV QPV Passenger Écolier MPE QPE Student Taxi MPT QPT Taxicab Camionnage régulier MCR QCR Regular trucking Camionnage spécialisé MCS QCS Specialized trucking Transport en vrac MCV QCV Bulk transportation Location ML QL Leasing Maritime MSM QSM Water Aérien MSA QSA Air Ferroviaire MSF QSF Rail Rose Pink Rouge foncé Dark red Jaune orange Orange Orange brûlé Burnt orange Vert pâle Light green Vert foncé Dark green Bleu pâle Light blue Bleu foncé Dark blue Mauve Mauve Brun Brown M 000001 à M 002000 Q 000001 à Q 001000 M 100001 à M 103000 Q 100001 à Q 102000 M 200001 à M 210000 Q 200001 à Q 205000 M 300001 à M 303000 Q 300001 à Q 302000 M 400001 à M 402000 Q 400001 à Q 401000 M 500001 à M 504000 Q 500001 à Q 503000 M 600001 à M 601000 Q 600001 à Q 600500 M 700001 à M 700500 Q 700001 à Q 700500 M 800001 à M 800500 Q 800001 à Q 800500 M 900001 à M 900500 Q 900001 à Q 900500 MPV \u2014 Montréal transport public \u2014 voyageurs / Montreal public transport \u2014 passengers QPV \u2014 Québec transport public \u2014 voyageurs / Québec public transport \u2014 passengers MPE \u2014 Montréal transport public \u2014 écoliers / Montreal public transport \u2014 students QPE \u2014 Québec transport public \u2014 écoliers / Québec public transport \u2014 students MPT \u2014 Montréal transport public \u2014 taxi / Montreal public transport \u2014 taxicab QPT \u2014 Québec transport public \u2014 taxi / Québec public transport \u2014 taxicab MCR \u2014 Montréal transport régulier \u2014 camionnage / Montreal regular transportation \u2014 trucking QCR \u2014 Québec transport régulier \u2014 camionnage / Québec regular transportation \u2014 trucking 1718 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 22.1975, Vol.107.No.S MCS \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 camionnage / Montreal specialized transportation \u2014 trucking QCS \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 camionnage / Québec specialized transportation \u2014 trucking MCV \u2014 Montréal transport en vrac \u2014 camionnage / Montreal btdk transportation \u2014 trucking QCV \u2014 Québec transport en vrac \u2014 camionnage / Québec bulk transportation \u2014 trucking ML \u2014 Montréal location / Montreal leasing QL \u2014 Québec location / Québec leasing MSM \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 maritime / Montreal specialized transportation \u2014 water QSM \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 maritime / Quebec specialized transportation \u2014 water MSA \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 aérien / Montreal specialized transportation \u2014 air QSA \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 aérien / Québec specialized transportation \u2014 air MSF \u2014 Montréal transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Montreal specialized transportation \u2014 rati QSF \u2014 Québec transport spécialisé \u2014 ferroviaire / Québec specialized transportation \u2014 rail II \u2014 Avis d'introduction de requêtes: La Commission donne avis de la nature des requêtes suivantes conformément aux dispositions de l'article 2.13 du Règlement 2.Quiconque désire s'opposer ou intervenir doit le faire, suivant les règles prévues à l'article 2.14 dudit règlement, dans les 21 jours francs de la date de la présente publication.D \u2014 Notice of submission of applications: The Commission gives notice of the nature of the following applications, in conformity with the provisions of section 2.13 of Regulation 2.Whoever wishes to object or to intervene must do so according to the rules laid down in section 2.14 of said Regulation, within a period of 21 clear days following the date of this publication.Rôle 0-2925 3095-A 3095-A-C-2 TRANSPORT PHILIPPE DESROSIERS INC.192, rue Morissette Mont-Joli (Oué.) Requérante / Applicant 2298-A VOTRE CHOIX TRANSPORT INC.270.rue Léonidas Rimousfci (Oué.) Intimée / Dependant Rôle 0-2926 I7669-V-D-2-TF AIR CARGO SERVICE (SEPT-ÎLES) INC.754.Bourgeois Sept-Iles (Que.) Rôle 0-2927 20536-V-D-3-TF ENTREPÔT ST-MALO WAREHOUSE INC.1245, des Artisans Québec (Oué.) GIN 1YI Convocation: Demande de vérification des services de transport fournis par la partie-intimée à la demande de la panic requérante.Summons: For verification of the transport services provided by the defendant, at the applicant's request.La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs d'environ 15% pour le transport de marchandises arrivant ou partant par avion à Sept-lles selon son permis No 17669-V.La requérante, qui détient un permis de courtier en transport, demande l'autorisation d'augmenter ses tarifs comme suit: a) 12% pour les services suivants: 1.Comté Charlevoix.2.Chicoutimi-Lac-St-Jcan.3.Comtés de Rimouski.Matane, Matapédia, Bonaventure, Gaspé-sud, Gaspé-nord et la partie nord du Nouveau-Brunswick.5.L'Islet.Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Nouveau-Brunswick.6.Bcauce.Frontenac.Dorchester.b) 17% pour le service suivant: 4.Comtés de Saguenay et Duplessis.The applicant requests authorization from the Transport Commission to increase by approximately 15% its tariffs for the transport of goods arriving at or leaving from Sepl-lles.by airplane, according to permit No.17669-V.The applicant, which holds a transport broker's permit, requests authorization to increase its tariffs as follows: (a) 12% for the following services: 1.County of Charlevoix.2.Chicoutimi-Lac-St-Jcan.3.Counties of Rimouski.Matane, Matapédia, Bonaventure, Gaspé-South, Gaspé-North and the north part of New Brunswick.5.L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, New Brunswick.6.Beauce.Frontenac.Dorchester.(6) 17% for the following service: 4.Counties of Saguenay and Duplessis. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107- année, n° H 1719 Rôle Q-2928 13605-V-D-l-TF LES DÉMÉNAGEMENTS CÔTÉ JUNIOR ENR.(Yves Côié Junior) 74.ave Jacques-Cartier Québec (Oué.) G IL 3S1 Rôle 0-2929 226I8-V-D-2-TF ROYER, GEORGES 185, rue Beaulier Causapscal (Que.) Rôle O-2930 18430-V-D-7 PORLIER EXPRESS INC.315, avenue Otis Sept-îles (Que.) Rôle Q-2931 21984-V-D-2 HÉNEAULT & GOSSELIN INC.St-Louis-du-Ha! Ha! (Témiscouata) (Oué.) Siège social: / Head office: St-Joseph-du-Lac (Deux-Montagnes) (Que.) Rôle Q-2933 24128-VM-D-l HENDERSON'S MOVING & STORAGE LTD.P.O.Box 1181 Fredericton Industrial Park Fredericton, New Brunswick Au Québec: / In Québec: 2400.boul.Hamel Québec (Que.) Le requérant demande à la Commission des The applicant requests the Transport Corn-transports la fixation des taux suivants pour mission to fix the following rates for local le déménagement local à Québec: moving in Québec City: Temps simple Temps et demi Temps double Straight-time Time-and-a-half Double time 1 homme I man $18.00 $22.00 $26.00 2 hommes I men 26.00 34.00 42.00 3 hommes I men 34.00 46.00 58.00 4 hommes I men 42.00 58.00 74.00 Aide addilionnel I Additional help 8.00 12.00 16.00 Le requérant demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs pour le transport inter-usine de lait et crème pour le compte de La Coopérative Agricole du Bas St-Laurcnt: Taux actuels: $0.30 le 100 livres.Taux proposés: $0.35 le 100 livres.Modification de permis: La partie requérante demande l'autorisation de donner le service de transport suivant: Transport général - longue distance - route restreinte - De la ville de Fermont et du Mont-Wright à la frontière Québec-Terre-Neuve, et retour.Droit additionnel: En donnant le service ci-dessus, la requérante aura le droit d'utiliser des fardiers.Modification de permis: La requérante, détentrice du permis numéro 21984-V, demande que la clause suivante soit ajoutée à son permis: Transport restreint - longue dislance - territoire - équipement spécialisé - De tout point à un autre dans la province dc Québec à l'exception des comtés électoraux provinciaux suivants: L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Rimouski, Matane, Matapédia, pour le déplacement de maisons par équipement spécialisé.Ce permis n'est valide que pour le transport de maisons et bâtisses nécessitant, vu leurs dimensions, l'obtention d'un permis spécial du ministère des Transports.Restriction: En vertu de la susdite clause, le détenteur n'est pas autorisé à faire le transport ou le remorquage dc roulottes, maisons mobiles, maisons préfabriquées, ou maisons sectionnclles.Demande de permis: La partie requérante demande le permis suivant: Transport de ménages et ameublements usagés tels qu'ils sont définis dans l'Ordonnance générale sur le camionnage, dans des fourgons de déménagement spécialement agencés et utilisés exclusivement pour le transport de ménages et ameublements usagés.1.De la frontière Nouveau-Brunswick-Québec (via toutes les routes et tous les points d'entrée) à toutes les localités situées dans la province de Québec, et retour; (Provenance ou destination: endroits autorisés dans les provinces maritimes).2.En transit d'une frontière de la province de Québec à une autre frontière dc la province dc The applicant requests authorization from the Transport Commission to increase his tariffs for the interplant transport of milk and cream on behalf of La Coopérative Agricole du Bas St-Laurent: Present rates: $0.30 per 100 lb.Proposed rates: $0.35 per 100 lb.Modification of permit: The applicant requests authorization to provide the following transport service: General trucking - long distance - restricted route - From the Town of Fermont and from Mont-Wright to the Quebec-Newfoundland border, and return.Additional right: When providing the abovementioned service, the applicant shall have the right to use floats.Modification of permit: The applicant, holder of permit number 21984-V.requests [hat the following clause be added to its permit: Restricted trucking - long distance - territory -special equipment - From any point to any other point in the Province of Québec except in the following Provincial Electoral Counties: L'Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup.Témiscouata, Rimouski, Matane, Matapédia, for the moving of houses with special equipment.This permit shall be valid only for the transport of nouses and buildings which, considering their size, requires the obtainment of a special permit from the Transport Department.Restriction: In virtue of the aforesaid clause, the holder shall not be authorized to effect the transport or haulage of trailers, mobile homes, prefabricated houses, or sectional houses.Application for permit: The applicant requests the following permit: Transportation of household goods and used furniture as defined in the General Order on trucking, in specially-equipped moving vans used exclusively for the transportation of household goods and used furniture.1.From the New Brunswick-Québec border (via all routes and all ports of entry) to all localities situated in the Province of Québec, and return; (Origin or destination: points as authorized in the Maritime Provinces).2.In transit from one border of the Province of Québec to another border of the Province of 1720 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 197Û, Vol.107, Ko.8 Rôle Q-2935 I20-A-D-I-TF CHIBOUGAMAU TRANSPORT LTÉE I, rue Laberge St-Félicien (Lac-Si-Jean) (Oué.) Rôle Q-2936 4545-V-D-3-TF TRANSPORT LAVOŒ LTÉE 659, 118e Rue Ville Monlmorency Québec 5 (Que.) Rôle Q-2937 144-N-D-2-TF COOPÉRATIVE DE TRANSPORT MARITIME ET AÉRIEN C'ap-aux-Meules (lles-de-la-Madeleine) (Oué.) Rôle 0-2938 3281-A-D-3 3281-A AUTOBUS CODÈRE INC.290, Simoncau Thelford Mines (Que.) 2994-A ROBERT GILBERT 643.9e Rue Ouest Thetford Mines (Oué.) Québec (via loulcs les roules el lous les posies douaniers).Provenance ou destinalion: endroits situés dans les provinces du Canada, autres que le Québec, et aux Etats-Unis, suivant autorisation.3.De toute localité située dans la province de Québec à des localités situées dans les autres provinces du Canada et aux Etats-Unis, el retour (via tous les points d'entrée situés sur la frontière Québec-Ontario, sur la frontière Québec-Nouveau-Brunswick et les postes douaniers situés sur la frontière Québec-Etats-Unis.Les actions dc Hendersons's Moving & Storage Ltd.sont réparties comme suit: Actions ordinaires Bruce O.Henderson, président 4998 A.Elaine Henderson, vice-prés.I B.Irene Henderson, secr.-très.1 La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs pour le transport dc personnes entre Chi-bougamau et St-Félicien.Taux actuels / Present rates $ 6.75 Aller / One way 12.40 Aller et retour / La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs pour le transport de marchandises selon son permis No 4545-V.Les intéressés peuvent consulter les taux en s'adressant à la Commission des transports du Québec.La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs de 10% pour le transport de marchandises selon son permis No 144-N.Québec (via ail routes and ail ports of entry).Origin or destination: points as authorized in Provinces of Canada, other than Québec, and the United Stales.3.From all localities situated in the Province of Québec to localities in Provin:es of Canada and United States, and return (via all Pons of entry on the Québec-Ontario borders.Québec-New Brunswick borders and Quebec-United States borders).Shares of Hendersons's Moving & Storage Ltd.are distributed as follows: Common shares Brace O.Henderson, president: 4998 A.Elaine Henderson, vice-pres.: 1 B.Irene Henderson, secr.-treas.: I The applicant requests authorization from the Transport Commission to increase its tariffs for the transport of persons between Chibougamau and Saint-Félicien.Taux proposés / Proposed rates S 8.00 Round trip 16.00 The applicant requests authorization from the Transport Commission to increase its tariffs for the transport of goods according to its permit No.4545-V.Interested parties may consult the rates filed with Québec Transport Commission.The applicant requests authorization from the Transport Commission to increase by 10% its tariffs for the transport of goods according to its permit No.144-N.Cession de la propriété du système de transport: La partie requérante demande l'autorisation de céder à Robert Gildcrt, 643.9e Rue Ouest.Thetford Mines, comté de Mégantic, P.O.quelques-uns dc ses services dûment autorisés en vertu de son permis No 3281-A, comme suit à savoir: Classe de permis: Autobus.Service No 10: Québec-Thetford Mines el points intermédiaires: Sillery et Ste-Foy (via boul.Laurier), Si-Nicolas Station, limites ouest de Sl-Etiennc-dc-Lauzon, St-Gilles, St-Patrice, St-Sylvestre.Leeds Village et Station, St-Pierre-de-Brough-ton, le rang 6 de Robensonville et Robertson-villc.Parcours à suivre: De Québec à St-Nicolas Station en passant par le pont de Québec et la route 20.Dc St-Nicolas Station à St-Gilles en passant dans les limites ouest du village de St-Etienne-de-Lauzon.Transfer of ownership of the transport system: The applicant requests authorization to transfer to Robert Gilbert.643 - 9th Street West.Thetford Mines.County of Mégantic, P.Q.some of ils services duly authorized pursuant to its permit No.3281-A.the foregoing as follows, namely: Class of permit: Bus.Service No.10: Québec-Thetford Mines and intermediate points: Sillery and Sainte;Foy (via Laurier Blvd.), Saint-Nicolas Station, west limits of Saint-Etienne-de-Lauzon, Saint-Gilles.Saint-Patrice.Saint-Sylvesire, Leeds Village and Station, St-Pierre-de-Broughton, Range 6 of Robensonville and Robensonville.Route: From Québec City to Saint-Nicolas Station via the Québec Bridge and Highway 20.From Saint-Nicolas Station to Saint-Gilles via the west limits of the Village of Saini-Eticnne-dc-Lauzon. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, _>.' février 1975, 107' année, n' 8 1721 Rôle Q-2939 760-V-D-4 NIL GIRARD TRANSPORT LTÉE 1777, boul.Talbol Chicoutimi (Oué.) Rôle 0-2940 2I428-V-D-I ROCH ROY LTÉE 41, rue Notre-Dame Cap-Chat (Que.) De St-Gilles à Robertsonville en passant par St-Patrice.St-Sylvestre, Leeds Village el Station, Sl-Pierre-de-Broughlon et le rang 6 dc Robertsonville.De Robertsonville à Thetford Mines.Route No I.Droit additionnel: En donnant le service autorisé.Autobus Co-dère Inc.aura droit à un arrêt à St-Nicolas Station, à un endroit situé à 2.000 pieds au sud des routes No 20 et No 5.pour Québec, et retour.Conditions et restrictions: a) Pas de service local entre Si-Etienne et Québec.b) Pas de service local entre Robertsonville et Thetford Mines.Service No 11 : De Leeds à Thetford Mines, et retour.Parcours à suivre: Rouie régionale reliant Leeds à Thetford Mines, via Kinnear's Mills et Ponlbriand.Conditions et restrictions: Pas de service local sur la roule No 1 à partir de l'intersection de ladite route et du chemin conduisant à Ponlbriand jusqu'à Thetford Mines, ces deux endroits inclus.Service No 12: Transport de colis légers dans les véhicules affectés au transport de voyageurs.Conditions et restrictions: Scion les conditions et restrictions imposées dans l'Ordonnance No 309-A du premier avril 1970.Modification de permis (clause j): La panie requéranie désire que la clause ; de son permis, laquelle se lit comme suit: j) Transport général - longue distance - roule restreinte - service - j) De Bagolville.Pon-Alfred.Grande-Baie.Chicoutimi, Arvida.Jonquière.Kénogami à Québec et Montréal, et retour, pour le transport de marchandises destinées aux sept endroits ci-dessus mentionnés ou en provenant, soit modifiée pour qu'elle se lise comme suit: j) Transport général - longue distance - rouie ;') De Bagotville.Port-Alfred, Grande-Baie.Chicoutimi.Arvida, Jonquière, Kénogami et de tous les endroits silués dans les districts électoraux provinciaux de Dubuc, Chicoutimi.Jonquière, Lac-St-Jean et Roberval à Ouébec el Montréal, el retour.Annulation de permis: La partie requérante demande à la Commission l'annulation de son permis No 21428-V.lequel se lit comme suit: Transport restreint - longue distance - territoire - Entre lous points situés dans les comtés de Gaspé.Matane.Matapédia et Bonavenlure.pour le transport d'explosifs arrivant dans le territoire ci-dessus mentionné par bateaux et chemin de fer.Restriction: Ce permis est subordonné au maintien et au renouvellement du permis du ministère dc l'Energie, des Mines et des Ressources (Divi- From Saint-Gilles lo Robertsonville via Saint-Patrice, Saint-Sylvestre.Leeds Village and Station, Saint-Pierre-de-Broughton and Range 6 of Robertsonville.From Robertsonville to Thetford Mines, via Highway No.I.Additional right: When providing the service authorized.Autobus Codère Inc.shall have the right to stop at Saint-Nicolas Station, at a place located 2.000 feet south of Highways 20 and 5, for Québec City, and relum.Conditions and restrictions: (a) No local service belween Sainl-Etienne and Québec City.(fc) No local service belween Robertsonville and Thetford Mines.Service No.11: From Leeds to Thetford Mines, and relum.Route: Regional highway between Leeds and Thetford Mines, via Kinnear's Mills and Ponlbriand.Conditions and restrictions: No local service on Highway No.1 from the point of intersection of said Highway with the road leading to Pontbriand and lo Thetford Mines, these two points included.Service No.12: Transport of light parcels in vehicles used for the transport of passengers.Conditions and restriclions: Pursuant to the conditions and restrictions laid down in Order No.309-A dated April 1.1970.Modification of permit (clause j): The applicant wishes clause / of its permit, which reads as follows: (j) General trucking - long distance - restricted route - service - (j) From Bagotville, Port-Alfred, Grande-Baie, Chicoutimi, Arvida Jonquière.Kénogami lo Quebec and Montreal, and relum.for the transport of goods destined lo Ihe seven aforementioned points or originating therefrom, to be modified to read as follows in Ihe future: (j) General trucking - long dislance - route -(j) From Bagotville.Port-Alfred.Grande-Baie.Chicouiimi.Arvida.Jonquière.Kénogami and from any point located in the Provincial Elecioral District of Dubuc.Chicoutimi.Jonquière.Lac-St-Jean and Roberval to Québec and Montreal, and return.Cancellation of permit: The applicant requests from the Commission the cancellation of ils permit No.21428-V which reads as follows: Restricted trucking - long distance - territory - Belween any point located in the Counties of Gaspé, Matane, Matapédia and Bonavenlure for Ihe transport of explosives arriving in the afore-mentioned territory by boat or by railway.Restriction: This permit shall be subject to (he maintenance in effect and renewal of Ihe permit issued by Ihe Department of Energy.Mines an Re- 1722 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.February \u201e'_>.197».Vol.107.Xo.8 Rôle 0-2941 3MI-V-D-4 PIUZE TRANSPORT INC.222.Lavoisier Ste-Foy (Que.) Rôle Q-2944 O-502685-D-001 RENÉ MORIN S(c-Edwidge (Roberval) (Oué.) Rôle 0-2945 Q-5O452I-D-O01 ALFRED I M.HI R I McCanney Gaspé (Que.) sion des Explosifs), daté du 13 mars 1969.cou-vrani le transport d'explosifs en quantité de plus de 4.000 Ib par voyage.Modification de permis: La partie requérante demande à la Commission des transports du Québec que le droit additionnel re/clause a No 2 qui se lit comme suit: 2.En donnant son service de Montréal.Trois-Rivières et Québec aux différents points dc la Côte-Nord, et retour, la détentrice est autorisée à utiliser les routes 9.2 et 10.et à titre de Courtier en Transport, le service de traversier Père Nouvel, de Pointe-au-Père à Baie-Comeau.el retour.soit modifié pour se lire à l'avenir comme suit: 2.En donnant son service dc Montréal, Trois-Rivières et Ouébec aux différents points de la Côte-Nord, et retour, la détentrice est autorisée à utiliser les routes 9, 2.20, 132 et 6, et à titre de courtier en transport, le service de traversier ex islant de Matane à Godbout.el retour Le requérant, qui possède l'attestation Q-502685-D-001.demande un permis de camionnage en vrac, de catégorie Entrepreneur, pour la région No 2.Le requérant demande un permis de camionnage en vrac, transport de gravelle.sable, terre, de catégorie Artisan, pour la région No 1.sources (Explosives Division), dated March 13.1969.covering the transport of explosives in quantities weighing more than 4,000 Ib.on any one trip.Modification of permit: The applicant requests from the Quebec Transport Commission that Ihe additional right relating to clause a No 2.which reads as follows: 2.When providing its service from Montreal.Trois-Rivières and Québec City to various points on the North Shore, and return, the holder shall be authorized to follow Highways Nos.9, 2.and 10.and to utilize, as a transport broker, the \"Père Nouvel\" ferry service, from Pointeau-Père lo Baie-Comeau.and return, be modified to read as follows in the future: 2.When providing its service from Montreal.Trois-Rivières and Ouébec City to various points of the North Shore, and return, the holder shall be authorized to take Highways Nos.9.2, 20, 132 and 6, and to utilize, as transport broker, the ferry service operating between Matane and Godbout.and relum.The applicant, who holds certificate No.Q-502685-D-00I, requests a bulk trucking permit.Contractor class, for Region No.2.The applicant requests a bulk trucking permit for the transport of gravel, sand and earth.Artisan class, for Region No.1.Rôle Q-2948 642-A-D-l-TF LA CIE D'AUTOBUS RIMOUSKI LTÉE 270.rue Léonidas Rimouski (Que.) La requérante demande à la Commission des transports l'autorisation d'augmenter ses tarifs pour le transport de voyageurs en voyages spéciaux ou à charte-partie.Tarif 201: 1ère page amendée C-43 cancel le page originale C-43 The applicant requests from the Québec Transport Commission authorization to increase its tariffs for the transport of passengers on special or charter trips.Tariff 201: 1st page C-43.modified cancels original page C-43 Taux actuels I Present rates Page originale C-43 / Original page C-41 Point ou l'équipement est disponible: / Point where the equipment is available: Rimouski Catégorie de véhicules / Class of vehicles I.a) 16 passagers ou moins /16 passengers or less.b) 17 à 25 passagers 117 lo 25 passengers.Mille\tMille utile\tmon Productive\tUnproductive mile\tmile $0.35*\t$0.20 0.40-\t0.30 Taux proposés / Proposed rates Première page amendée C-43 / 1st page C-43.modified Points où l'équipement est disponible: / Points where the equipment is available: Rimouski.St-Anaclet.Luceville, Ste-Luce.St-Charles-Garnier.St-Donat.St-Gabriel.St-François-Xavier-des-Hauteurs.Catégories de véhicules / Class of vehicles I \u2022 a) 38 à 43 passagers «grande route» 138 lo 43 passengers \"Highway\" .Mille\tMille\tTaux à utile\tmort\tl'heure Productive\tUnproductive\tPer hour mile\tmile\trale $0.85\t$0.60\t$15.00 GAZETTE OFFICIELLE DC QUÉBEC.33février 197% 107' mméc, n° 8 1723 \t\tMille\tMille \t\tutile\tmon \t\tProductive\tUnproductive \t\tmile\tmile c)\t26 à 29 passagers / 26 to 29\t\t \t\t0.50'\t0.35 d)\t30 à 36 passagers / 30 to 36\t\t \t\t0.55-\t0.40 e)\t37 à 45 passagers / 37 lo 45\t\t \tpassengers .\t0.60'\t0.40 f)\t46 passagers ou plus/ 46\t\t \t\t0.65*\t0.40 g)\tAutobus de type scolaire\t\t \tSchool-type bus.\t0.50\t0.35 *\tAvec sièges s'inclinant: $0.05 de plus du mille utile / With\t\t \treclining seals: $0.05 more pe\tr live mile.\t 2.Des taux mentionnés à l'item 1, le voilurier utilisera celui qui représente le tarif le plus élevé; minimum dix dollars ($10)./77ie carrier shall utilize either of the rales mentioned in item I.whichever is higher: minimum: ten dollars 1S10).3.Une charge additionnelle de vingt dollars ($20) sera imposée lorsque le véhicule doit séjourner dehors la nuit pour toute période dc vingt-quatre (24) heures où l'autobus n'aura pas parcouru une moyenne de 200 milles ou réalisé un revenu de cent vingt dollars ($120).I An additional charge of twenty dollars ($20) shall be imposed when the vehicle must slay outside overnight for any period of twenty-four (24) hours, or when the bus has not travelled an average of 200 mites or when its operation has not resulted in an income of one hundred twenty ($120) dollars.4.Un avis d'au moins trois (3) heures devra être donné pour l'annulation de tout contrat de location, sans quoi une charge minimum de dix dollars ($10) sera faite pour chaque autobus loué.IA three-hour (3-hr) notice must be given when cancelling a contract.Failing such cancellation notice, a minimum charge of ten dollars ($10) shall be imposed for every bus leased.b) ) From Scott Junction to elsewhere in the Province within a radius of 400 miles, for the transpon of bricks and terra-colta, on behalf of La Brique de Scon Liée.Rôle Q-2978 O-502643-D-004 ROBERT GUAY 504.Ketcheneur La Tuque (Que.) et / and Q-504764-D-001 GILLES BROCHU 664, Real La Tuque (Que.) Rôle Q-2979 Q-500344-D-004 BERTRAND ( 'AM I RAM) CP.272.St-Jean-Pon-Joli (Que.) et /and Q-5O48I9-D-O01 A.B.CAMIRAND LTÉE CP.272 St-Jean-Port-Joli (Que.) Rôle Q-2980 2951-V-D-3 CÔTÉ, JEAN 233, rue Si-Louis Lac-à-la-Croix (Lac-St-Jean) (Oué.) et / and TRANSPORT JEAN CÔTÉ LTÉE 233, rue St-Louis Lac-à-la-Croix (Lac-St-Jean) (Que.) Demande de transfert: Robert Guay demande à la Commission de transférer à: Gilles Brochu 664, Réal La Tuque (Que.) le permis ou l'allestaiion No Q-502643-D-004 qu il détient pour effectuer du transpon de camionnage en vrac, dans la région No 4, pour la catégorie Entrepreneur.Demande de transfen: Bertrand Camirand demande à la Commission de iransférer à: A.B.Camirand Liée CP.272 St-Jean-Port-Joli (Que.) permis ou l'attestation No Q-500344-D-004 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région No 3, pour la catégorie Entrepreneur.Demande de transfert: M.Jean Côté demande que son permis de transport numéro 2951-V soit transféré à: Transport Jean Côté Liée 233.rue St-Louis Lac-à-la-Croix (Lac-St-Jean) (Que.) Le permis No 2951-V se lit présentement comme suit: a) Transport général - service local - a) Ste-Croix el tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite localité.b) Transport général - longue distance -rayon - o) De Ste-Croix à lous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas trente (30) milles des limites de ladite localité, el retour.Application for tiansfer: Robert Guay requests Ihe Commission to transfer to: Gilles Brochu 664 Réal La Tuque (Que.) Krmit or certificate No.Q-502643-D-004 which holds, to effect bulk trucking in Region No.4, Contractor class.Application for transfer: Bertrand Camirand requests the Commission to iransfer to: A.B.Camirand Liée CP.272 St-Jean-Port-Joli (Que.) permil or certificate No.Q-500344-D-004 which he holds, to effect bulk trucking in Region No.3, Contractor class.Application for transfer: Mr.Jean Côté request Ihe Commission to iransfer permil number 2951-V to: Transport Jean Côté Liée 233 St-Louis Lac-à-la-Croix (Lac-Saint-Jean) (Que.Transport permit No.2951-V reads actually as follows: (a) General trucking - local service - (a) Sainte-Croix and all points situated within a distance of five (5) miles from Ihe limits of said locality.(b) General trucking - long distance - radius - (fc) From Sainte-Croix to all points situated within a radius of thirty (30) miles from the limits of Said locality, and return. 1774 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975.Vol.107, No.8 c) Transpon general - longue dislance -rayon \u2022 irrégulier - c) De Ste-Croix à ailleurs dans les comtés de Lac-Sl-Jean, Roberval, Chicoutimi, Dubuc el Lapointe.et retour.(/(Transport général - longue distance -régulier - route restreinte - (au moins une fois par semaine) d) De Ste-Croix à Québec et Montréal, et retour.e) Transpon restreint - longue distance -route restreinte - e) De St-Félicien et de Chambord à Montréal et à tous les points situés dans un rayon de cinquante (50) milles de cette dernière, pour le transpon de bois préparé.f) Transpon restreint - longue dislance -route restreinte - /) Dc Montréal et de Québec à Ste-Croix, pour le transpon de grains, moulées, engrais chimiques, farine et sucre, en sacs et en vrac, par équipement spécialisé.Droit additionnel: En donnant le service autorisé à la clause /.le détenteur est autorisé à faire la cueillette et la livraison dans lous les endroits situés dans un rayon de cinquante (50) milles de Ste-Croix.g) Transpon restreint - longue distance -route restreinte - g) De tous les endroits situés dans les districts électoraux provinciaux de Lac-St-Jean, et Roberval à Québec et Montréal, et à tous les endroits situés dans un rayon de cinquante (50) milles desdites villes, pour le transpon dc bois préparé, pour le public en général.h) Transpon restreint - longue distance -route restreinte - h) De Victoriaville et de St-Hyacinthe à Lac-à-la-Croix, comté du Lac-St-Jean.pour le transpon d'engrais chimique en sacs provenant de Canadian Industries Limited, pour les cultivateurs en général.Droit additionnel: En donnant le service précité, le délenteur est autorisé à effectuer la livraison à tous les endroits situés dans un rayon de cinquante (50) milles de Lac-à-la-Croix.i) Transport restreint - longue distance -route restreinte - contrat - f) De Joliette à Lac-à-la-Croix.Si-Jérôme et Sl-Bruno (Lac-St-Jean).pour le transpon de ciment en sacs, pour le compte de: Syndical Coopératif Agricole de Lac-à-la-Croix.Société Coopérative Agricole de St-Jérôme.Chaine Coopérative du Saguenay, de St-Bruno.j) Transpon restreint - longue distance -route restreinte - I) De St-David-de-Falardeau à Ouébec el Montréal ainsi que lous les endroits situés dans un rayon de cinquante (50) milles desdites villes, pour le transpon de bois préparé pour le public en général.(c) General trucking - long distance - radius -irregular - (c) From Sainte-Croix to points situated within the electoral provincial districts of Lac-Sainl-Jean, Roberval, Chicoutimi, Dubuc and Lapointe.and return.(d) General trucking - long distance - regular - restricted route - (at least once a week) (d) From Sainte-Croix to Ouébec and Montreal, and return.(e) Restricted trucking - long distance - restricted route - (e) From Saint-Félicien and Chambord to Montreal and all points situated within a radius of filly (50) miles from said locality, for the transpon of dress lumber.If) Restricted trucking - long distance - restricted route- (/) From Montreal and Ouébec Cily to Sainte-Croix, for the tfanspon of grains, feed, fertilizer, flour and sugar, in bag and in bulk, with specialized equipment.Additional right: When giving service in virtue of clause /.the holder is authorized to give a pick-up and delivery service lo ail points situated within a radius of fifty (50) miles from Sainte-Croix.(g) Restricted trucking - long distance - restricted route - (g' From all points situated in the electoral provincial districts of Lac-Saint-Jean and Ro-vcrval to Québec and Montreal and lo all points situated within a radius of fifty (50) miles of said cities, for the transpon of dress lumber, for the public.i'm Restricted Irucking - long distance - restricted route - (h) From Victoriaville and Saint-Hyacinthe to Lac-à-la-Croix.County of Lac-St-Jean, for Ihe transpon of fenilizer in bags coming from Canadian Industries Limited, on behalf of fanners.Additional right: When giving above-mentioned service, the holder is authorized to give a delivery service to all points within a radius of fifty (50) miles of Lac-à-la-Croix.(i) Restricted trucking - long distance - restricted route - contract - 'i) From Joliette to Lac-à-la-Croix, Saint-Jérôme and Saint-Bruno (Lac-Sainl-Jean) for transpon of cement in bags, on behalf of: Syndicat Coopératif Agricole de Lac-à-la-Croix.Société Coopérative Agricole de Saint-Jérôme.Chaine Coopérative du Saguenay.Saint-Bruno.(j) Restricted trucking - long distance - re-stncted route - 0) From Saint-David-de-Falardeau to Québec and Montreal and ail points located within a radius of fifty (50) miles of said cities, for Ihe transpon of dress lumber on behalf of public. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1975, 107' année, n° S 1775 Rôle O-3002 Q-500816-D-001 LÉONARD, GOSSELIN 292, St-Augustin Breakeyville (Lévis) (Oué.) et / and Q-S04835-D-001 JULIEN PELCHAT 3, rue Bussières Breakeyville (Lévis) (Oué.) Rôle Q-3003 Q-504791-D-002 GASTON TREMBLAY 10, rue Grenier Beau l'on (Oué.) et / and O-504836-D-001 GUY PARADIS 1094, avenue Royale Villeneuve (Oué.) Rôle Q-3005 6579-V-D-l CLOUTIER, ALBERT 625, avenue Principale St-Marc-des-Carrières (Ponneuf) (Que.) et / and 7737-V BELLECHASSE TRANSPORT INC.3600, boul.Hamel Ouébec 8 (Que.) Rôle Q-3017 3039-A-D-2 3039-A MAURICE BARIBEAU 272, St-Maurice St-Alexis-des-Monts (Maskinongé) (Oué.) et / and AUTOBUS ALLARD INC.152, Notre-Dame St-Alexis-des-Monts (Maskinongé) (Oué.) Les actions de la compagnie Transpon Jean Côté Ltée se répartissent comme suit: Jean Côté: 1.998 actions ordinaires 200 actions privilégiées Marcel Côté: 1 action ordinaire Jules-André Côté: 1 action ordinaire The shares of Transport Jean Côté Ltée are alloted as follows: Jean Côté: 1,998 common shares 200 preferred shares Marcel Côté: 1 common share Jules-André Côté: 1 common share Demande de transfert: Léonard Gosselin demande à la Commission de transférer à: Julien Pelchat 3, rue Bussières Breakeyville (Lévis) (Que.) le permis ou l'attestation Q-500816-D-001 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région No 3, catégorie Artisan.Application for transfer: Léonard Gosselin requests the Commission to transfer to: Julien Pelchat 3 Bussières Street Breakeyville (Levis) (Que.) permit or certificate Q-500816-D-001 which he holds, to effect bulk trucking, in Region No.3, Artisan class.Demande de transfert: Gaston Tremblay demande à la Commission de transférer à: Guy Paradis 1094, avenue Royale Villeneuve (Oué.) le permis ou l'attestalion O-504791-D-002 qu'il détient pour effectuer du transport de camionnage en vrac, dans la région No 3, catégorie Arti-lan.Demande dc transfert partiel: Bellechasse Transpon Inc.demande que lui soit transféré les clauses ft et c du permis No 6579-V d'Albert Cloutier.Les clauses b et c du permis No 6579-V se lisent comme suit: Transport général - b) De St-Marc-des-Carrières, St-Alban, Deschambault, St-Gilbert, St-Casimir et St-Thuribe à Québec, et retour, pour le transport de marchandises destinées aux 6 premiers endroits ou en provenant.c) Des 6 endroits mentionnés ci-dessus à ailleurs dans la province, pour le transpon de pierre et chaux, et retour avec marchandises diverses destinées à ces 6 endroits.Transfert de permis: Aux fins d'obtenir l'autorisation de vendre à Autobus Allard Inc.152, Notre-Dame, St-Alexis-des-Monts, comté de Maskinongé (Que.), les services de transport dûment autorisés en vertu du permis No 3039-A, comme suit à savoir: Classe de permis: Autobus.Service No 1: Occasionnellement, transport de passagers originant de St-Alexis-des-Monts.et se rendant à différents endroits situés sur une distance de cinquante (50) milles dans le bois, et retour.Service No 2.Transport d'écoliers demeurant dans un rayon dc deux (2) milles dans St-Alexis-des-Monts aux Application for transfer: Gaston Tremblay requests the Commission to transfer to: Guy Paradis 1094 Royale Avenue Villeneuve (Que.) permit or certificate Q-504791-D-002 which he holds, to effect bulk trucking, in Region No.3, Anisan class.Partial transfer of permit: Bellechasse Transport Inc.requests lo transfer clauses b and c from permit No.6579-V of Albert Cloutier to ils permit.Clauses b and c of permit No.6579-V read is follows: General trucking - (ft) From Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Alban.Deschambault, Saint-Gilbert, Saint-Casimir, and Saint-Thuribc to Québec, and return, for the transport of merchandise originating from or destined for the six (6) mention.*! points.(c) From the six (6) mentionned points above to any point of the Province for the transport of lime stone, and return with diverse merchandises to the said six (6) points.Transfer of permit: In order to obtain authorization lo sell to Autobus Allard Inc.152 Notre-Dame.Saint -Alexis-des-Monts, County of Maskinongé, P.Q., the transport services duly authorized in virtue of permit No.3039-A, as follows: Class of permit: Bus.Service No.I: Occasionnally.transpon of passengers from Saint-Alexis-des-Monts to different points located within a distance of fifty (5U) miles in the woods, and return.Service No.2: Transpon of students living within a radius of two (2) miles in Saint-Alexis-des-Monts to 1776 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.H différentes écoles de la Commission scolaire de St-Alexis-des-Monts, et retour.Service No 3: Transport d'étudiants les vendredis et dimanches soir, de leur résidence située à St-Alexis-des-Monts à destination des Couvents Carena et Christ-Roi et à la grande Ecole de Trois-Rivières, et retour.Service No 4: Transpon des travailleurs el travailleuses demeurant à St-Alexis-des-Monts et se rendant aux diverses usines situées à St-Paulin et à Ste-Ursule, el retour.different school under the control of School Board of Saint-Alexis-des-Monts, and return.Service No.3: Transport of students on Friday nights and Sunday nights, from their homes located in Saint-Alexis-des-Monts to Carena and Christ-Roi Convents and to Trois-Rivières High School, and return.Service No.4: Transport of workers living in Saint-Alexis-des-Monts and going lo different factories located in Saint-Paulin and Sainte-Ursule, and return.Rôle O-3019 7536-V-D-1 LACHANCE, JACQUES 427, Chabot, app.2.Vanier.Québec 8 (Que.) et / and 24152-V DROUDN, RAYMOND 470.Taschereau Quebec 8 (Que.) Demande de transfen: M.Jacques Lachance demande que son permis de transport No 7536-V soit transféré à: Raymond Drouin (24152-V) 470, Taschereau Québec 8 (Oué.) lequel se lil comme suit: a) Transport général - service local - a) Ouébec el tous les endroits situés sur une distance ne dépassant pas cinq (5) milles des limites de ladite ville.b) Transpon général - longue distance -rayon - b) De Ouébec à tous les endroits situés dans un rayon de trente (30) milles des limites de ladite ville, el retour.Application for transfer: Mr.Jacques Lachance requests that his transport permit No.7536-V be transferred to: Raymond Drouin (24152-V) 470 Taschereau Ouébec 8 (Que.) which reads as follows: (o) General trucking - local service - (a) Québec and ail points located wilhin a distance not exceeding five (5) miles from the limits of said City.(ft) General trucking - long distance -radius - (ft) From Québec to all points located within a radius of thirty (30) miles from the limits of said City, and return.Rôle Q-3020 Q-200113 GRENIER, EDGAR Ste-Louise (L'lslet) (Que.) et /and Q-20I846-D-2 LORD, ROLLAND Ste-Louise (L'lslet) (Que.) Demande de transfert: Grenier, Edgar, demande à la Commission de transférer à: Lord.Rolland Ste-Louise (L'lslet) (Que.) le permis No Q-200113 pour effectuer du transport par véhicule-taxi dans la région suivante: la municipalité de Ste-Louise.Application for transfer: Grenier.Edgar, requests the Commission to iransfer to: Lord.Rolland Sainte-Louise (L'lslet) (Que.) permit No.Q-200113 to effect transport by taxicab in the following Region: the Municipality of Sainte-Louise.Rôle Q-3024 1131-DYV-D-3 JEAN-JACQUES GAUVIN 143, rue Châteaudun Cap-de-la-Madeleine (Que.) Transfen de permis: La partie requérante (Jean-Jacques Gauvin) s'adresse à la Commission des transports du Québec pour changer la raison sociale pour Jean-Jacques Gauvin Incorporée, 143, rue Châteaudun, Cap-de-la-Madeleinc, P.Q.Transfer of permit: The applicant (Jean-Jacques Gauvin) requests from the Québec Transport Commission to change his firm name for Jean-Jacques Gauvin Incorporée, 143, rue Châleaudun, Cap-de-la-Madelcine.P.Q.Rôle Q-3025 245-N-D-6-TF AGENCE MARITIME INC.CP.156, Station «B» Ouébec 2 (Que.) La requérante demande à la Commission des transports la fixation du tarif No FM-1 pour le service de passagers entre les ports de Rimouski, Sept-llcs jusqu'à Blanc-Sablon, et retour.Les intéressés peuvent consulter les taux à la Commission des transports du Québec.The applicant requests from the Transport Commission the fixation of tariff No.FM-I applicable to Ihe passengers' service between the pons of Rimouski.Sept-lles and Blanc-Sablon, and return.The interested parties may consult the rates filed with the Québec Transport Commission.60018-o GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.«V Jevrier W7Ô.107' aimée.«° 8 V \u2014 Avis de décisions rendues: La Commission donne avis de la nature des décisions suivantes, prises par elle, conformément aux dispositions de l'article 2.58 du Règlement No 2.Dans le cas d'une décision rendue par un membre siégeant seul conformément à l'article 14 de la Loi des transports, la révision peut en être demandée dans les 15 jours francs de la présente publication.V \u2014 Notice of decisions rendered: The Commission gives notice of the nature of the following decisions reached by it, in conformity with the provisions of section 2.58 of Regulation No.2.In the case of a decision rendered by a member sitting alone, in conformity with section 14 of the Transport Act, the revision may be requested within a period of 15 clear days following this publication.AUDIENCES PUBLIQUES / PUBLIC HEARINGS \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\tA pplicants\tpage\tdate\tCase\tDécisions MCR-1583\t10-01-75\t1842-V\t920\t26-02-74\tM-947\tAccordée / Granted \t\tDENIS 4 ROBERT TRANSPORT INC.Droit additionnel / Additional right\t\t\t\t MCS-1020\t11-02-75\t22406-V-D-l\t4992\t13-07-74\tM-2388\tAccordée / Granted \t\tJ.& B.CARTAGE COMPANY LTD.Requérante-venderesse\t\t\t\t \t\tA pplicant-vendor NESEL FAST FREIGHT\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\tINCORPORATED\t\t\t\t \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t \t\tApplicant-purchaser\t\t\t\t \t\tTransfert de permis / Transfer of permit\t\t\t\t ML-543\t11-02-75\t785-DYV-D-l\t6976\t24-11-73\tM-663\tRejetée / Rejected \t\tMARLEASE INC.\t\t\t\t \t\tDroit additionnel / Additional right\t\t\t\t SÉANCES EN CHAMBRE / SITTINGS IN CHAMBERS 10-02-75 11-02-75 11-02-75 11-02-75 11-02-75 12-02-75 13-02-75 13-02-75 05-02-75 3607-A-D-l JEANNE DAOUST Nouvelle demande / New application 629-A-D-2-TF PONTIAC BUS LINE LTEE Modification de tarif Tariff modification 3595-A-D-l SABINI LUIGI ET DANTE Nouvelle demande / New application 2871-A-D-3 ALLEN, EDOUARD Nouvelle demande / New application 2594-A-D-3 METROPOLITAIN SUD (1967) INC.Annulation de permis Cancellation of permit 2096-A-D-l-TF METROPOLITAIN PROVINCIAL (1967) INC.Modification de tarif Tariff modification 2957-A-D-3 RIVERAINS TRANSPORT INC.Droit additionnel / Additional right 3609-A-D-l MATTE SERVICE AUTOBUS LIMITED .Nouvelle demande / New application M-206082 M-202184-D-2 GEORGE COLTLLARD Requérant-cédant A pplicant-transfcrror 8999 8244 8457 8458 8996 8454 9158 9159 9632 30-11-74 02-11-74 09-11-74 09-11-74 30-11-74 09-11-75 07-12-74 07-12-74 28-12-74 M-3892 M-3234 M-3616 M-3617 M-3835 M-3595 M-4107 M-4108 M-4392 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Rejetée / Rejected Accordée / Granted 1778 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 33, 1976, Vol.107, No.8 No Date Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Case Décisions MPT-8209 06-02-75 MPT-8210 06-02-75 MPT-8211 06-02-75 MPT-8212 06-02-75 MPT-8213 07-02-75 MPT-8214 05-02-75 MPT-8215 06-02-75 M-202184-D-2 EMMANUEL FREUNDLICH Requérant-cessionnaire A pplicant-transf eree Transfert de permis / Transfer of permit M-203873 MARCEL PELLERIN Requérant-cédant A pplicant-transf'error M-206125 RAYMOND BROUILLARD Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis / Transfer of permit M-206058-D-2 ELPHEGE BELANGER PAULE BELANGER (Légataire universelle / Sole legatee) Requérant-cédant Applicant-transferror M-206834-D-3 MARIO VENAFRO Requérant-cessionnaire A pplicant-transferee Transfert de permis / Transfer of permil M-206068-D-3 ELPHEGE BELANGER PAULE BELANGER (Légataire-universelle / Sole legatee) Requérant-cédant Applicant-transferror M-203835-D-2 RAOUL BELANGER Requérant-cessionnaire A pplicant-transf eree Transfert de permis / Transfer of permit M-206058-D-4 ELPHEGE BELANGER PAULE BELANGER (Légataire universelle / Sole legatee) Requérant-cédant Applicant-transferror M-205834-D-4 MARIO VENAFRO Requérant-cessionnaire A pplicant-transferee Transfert de permis / Transfer of permit M-203617-D-1 SAMUEL ORNSTEIN Requérant-cédant Applicant-transferror M-206134 PAUL VOLGYESI Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis / Transfer of permit M-203830-D-8 CECILIA MOSNER Requérant-cédant Applicant-transferror M-203773-D-6 BENONY WECHSLER Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis / Transfer of permil M-203830-D-4 CECILIA MOSNER Requérante-cédante Applicant-transferror 9632 28-12-74 M-4393 Accordée / Granted 9G32 28-12-74 M-4396 Accordée / Granted 9632 28-12-74 M-4397 Accordée / Granted 9632 28-12-74 M-4398 Accordée / Granted 20 11-01-74 M-4515 Accordée / Granted 9326 14-12-74 M-4280 Accordée / Granted 9320 14-12-74 M-4281 Accordée / Granted GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, «\u2022 8 1779 No MPT-8210 MPT-8217 MPT-8218 MPT-8219 MPT-8220 MPT-8221-TF MCR-1673-TF MCR-1674 Date 05-02-75 06-02-75 06-02-75 06-02-75 06-02-75 13-02-75 06-02-75 06-02-75 Requérants Applicants M-203773-D-5 BENONY WECHSLER Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis / Transfer of permit M-200399 HENRI CODERRE Requéranl-cédant Applicant-transferror M-206116 NAPOLEON LATRAVERSE Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis / Transfer of permil M-201448 OVILA GADBOIS Requérant-cédant A pplicant-transf error M-203227-D-2 JACQUES ALLARD Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert d'attestation Transfer of certificate M-204811-D-1 JULIAN FURMAN Requérant-cédant Applicant-transferror M-202886-D-6 LAZAR SAFERMAN Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-204811-D-3 JULIAN FURMAN Requérant-cédant Applicant-transferror M-202886-D-7 LAZAR SAFERMAN Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-201161 EDGAR MICHELSON Requérant-cédant Applicant-transferror M-201302-D-3 ALVES FLORENTINO Requérant-cessionnaire Applicant-transferee Transfert de permis Transfer of permit M-20043-D-1-TF SHERBROOKE RADIO TAXI INC.Modification de tarif Tariff modification 12979-V-D-2-TF BELLEMARE EXPRESS INC.Modification de tarif Tariff modification 22031-V-D-l RICHELIEU COLIS & DISPATCH SERVICE CO.Requérante-venderesse Applicant-vendor RICHELIEU COL1S SERVICE CO.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permit G.O.Q.page date 9326 9629 9630 9630 \u2022-\u2022\u2022an 9003 9321 8681 14-12-74 23-03-74 28-12-74 28-12-74 28-12-74 30-11-74 14-12-74 16-11-74 Cause Case M-4282 M-1380 M-4381 M-4382 M-4383 M-3937 M-4253 M-3720 Décisions Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Désistement Withdrawal Accordée / Granted Accordée / Granted 1780 QUÉBEC OFF ICI At.GAZETTE, February 2:2.1975.Vol.107, No.S No Date Requérants Applicants G.O.Q.page date Cause Case Décisions MCR-1575 06-02-75 MCR-1576 06-02-75 MCR-1577 MCS-1009 MCR-J578 06-02-75 07-02-75 MCR-1579-TF MCR-1580- TF MCS-1010- TF MCR-1582 MCR-1584 MCR-1586 MCR-1686 MCR-1587 07-02-75 07-02-75 07-02-75 07-02-75 07-02-76 10-02-75 10-02-75 17816-V-D-l JEROME BESSIERES Requérant-vendeur .4 p plica nt-ve ndor J.B.TRANSPORT INC.Requérante-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permil 1039-V-D-l MONTREAL COURIER SERVICE INC.Mise en cause EDOUARD C.LEROUX GEORGES C.LEROUX GERALD L.DEMERS NATIONAL SALES & DISTRIBUTION CO.LTD.Requérants-vendeurs A pplica nt-vendors GASTON GOYETTE ALAIN LEBLANC GILLES GOYETTE Requérants-acquéreurs Applicant-purchasers Transfert d'actions Transfer of shares 675-V-D-3 ROGERS TRANSPORT INC.Modification de clause Clause modification 18603-V-D-l LUCIEN ST-LAURENT Requérant-vendeur / Applicant-vendor LES ENTREPRISES ANDRE LAMBERT INC.Requérant-acquéreur Applicant-purchaser Transfert de permis Transfer of permit 3291-V-D-l-TF J.A.DORE TRANSPORT INC.Modification de tarif Tariff modification 4552-V-D-l-TF CHOUINASD & FRERES LTEE Modification de tarif Tariff modification M-23577-V-D-1 OMER MORIN Requérant-vendeur / Applicant-vendor JAMES TANNER Requérant-acquéreur A ppl icon t-p ureh ase r Transfert de permis Transfer of permil 24036-V-D-l WON SEVIGNY Nouvelle demande / New application 13963-V-D-12 SPEEDWAY EXPRESS LIMITED Modification de permis Modification of permit 24037-V-D-l LES MESSAGERIES LORIBEC ENR.Nouvelle demande / New application 22543-V-D-l-TF JEAN-CLAUDE BUJOLD Modification de tarif Tariff modification 3346 04-05-74 M-1739 Accordée / Granted 5298 5547 27-07-74 03-08-74 M-2619 Accordée / Granted 9157 9141 07-12-74 07-02-75 M-4102 M-4135 Accordée / Granted Accordée / Granted 8685 8454 8049 8685 8682 8997 9313 16-11-74 09-11-74 26-10-74 16-11-74 16-11-74 30-11-74 14-12-76 M-3734 M-3596 M-3494 M-3771 M-3727 M-3876 M-4179 Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted C.AZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.SS février 1975.107' année.n° 8 1781 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\tA pplicanls\tpage\tdate\tCase\tDécisions MCR-1588\t10-02-75\t2901-V-D-l\t8053\t26-10-74\tM-3507\tAccordée / Granted \t\tGERARD CLOUTIER\t\t\t\t \t\tRequérant-vendeur / Applicant-vendor\t\t\t\t \t\tGILLES ROBERT INC.\t\t\t\t \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t \t\tApplicant-purchaser\t\t\t\t \t\tTransfert de permis\t\t\t\t \t\tTransfer of permit\t\t\t\t MCR-1689\t10-02-75\t22500-V-D-l\t6152\t31-08-74\tM-2912\tDésistement \t\tRAYMOND VAILLANT\t\t\t\tWithdrawal \t\tRequérant-vendeur / Applicant-vendor\t\t\t\t \t\tTRANSPORT VAILLANT LIMITEE\t\t\t\t \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t \t\tApplicant-purchaser\t\t\t\t \t\tTransfert de permis\t\t\t\t \t\tTransfer of permit\t\t\t\t MCR-1590\t11-02-75\t22500-V-D-l TRANSPORT VAILLANT LTEE Droit additionnel / Additional right\t8271\t02-11-74\tM-3603\tDésistement Withdrawal MCR-1592\t11-02-75\t24040-V-D-l LIBERO CUSANO Nouvelle demande / New application\t8995\t30-11-74\tM-3832\tAccordée / Granted MCR-1594-\t13-02-75\t11717-V-D-2-TF\t9002\t30-11-74\tM-3935\tAccordée / Granted TF\t\tYVON LAROCQUE TRANSPORT\t\t\t\t MCS-1026-\t\tLIMITEE\t\t\t\t TF\t\tModification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1595-\t13-02-75\t250-V-D-2-TF\t8454\t09-11-74\tM-3594\tAccordée / Granted TF\t\tJOS TONDREAU & FILS INC.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCR-1596\t13-02-75\t14440-V-D-2\t9004\t30-11-74\tM-3940\tAccordée / Granted \t\tTHEODORE MORIN TRANSPORT\t\t\t\t \t\tENRG.\t\t\t\t \t\tRequérante-venderesse\t\t\t\t \t\tApplicant-vendor\t\t\t\t \t\tLES TRANSPORTS T.MORIN INC.\t\t\t\t \t\tRequérante-acquéreur\t\t\t\t \t\tApplicant-purchaser Transfert de permis\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\tTransfer of permit\t\t\t\t \t\tModification à la clause\t\t\t\t \t\tClause modification\t\t\t\t MCS-1002-\t06-02-76\t15578-V-D-7-TF\t8455\t09-11-74\tM-3600\tAccordée / Granted TF\t\tCLARKE TRANSPORTATION CANADA LIMITED Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCS-1003-\t06-02-75\t40003-D-68-TF\t8050\t26-10-74\tM-3498\tAccordée / Granted TF\t\tCANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS TARIFF BUREAU ASSOCIATION Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCS-1004-\t06-02-75\t4003-D-70-TF\t8050\t26-10-74\tM-3499\tAccordée / Granted TF\t\tCANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS TARIFF BUREAU ASS'N.Modification de tarif\t\t\t\t \t\tTariff modification\t\t\t\tAccordée / Granted MCS-1005-\t06-02-75\t40003-D-71-TF\t8050\t26-10-74\tM-3500\t TF\t\tCANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS TARIFF BUREAU ASS'N.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCS-1006\t06-02-75\t24005-V-D-l REJEAN MARTEL Vo itur ier-remorqueu r Haulaway operator\t8046\t26-10-74\tM-3484\tAccordée / Granted 1782 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 No \t\tG.O.O.\t\t \tRequérants\t\t\tCause Date\tA pplicanls\tpage\tdate\tCase \t18510-V\t\t\t \tNORMAND CLOUTIER TRANS-\t\t\t \tPORT INC.\t\t\t \tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t \tDroit additionnel / Additional right\t\t\t 06-02-75\t18660-V-D-l-TF G.M.SMITH LIMITED Modification de tarif Tariff modification\t9312\t14-12-74\tM-4176 06-02-75\t19614-V-D-4-TF FLORIDA REFRIGERATED SERVICE INC.Modification de tarif Tariff modification\t9312\t14-12-74\tM-4177 07-02-75\t40003-D-83-TF CANADIAN HOUSEHOLD GOODS CARRIERS' TARIFF BUREAU ASSOCIATION Modification de tarif Tariff modification\t\t\tM-5010 07-02-75\t24076-V-D-l LES ENTREPRISES SANITAIRES R.M.INC.Nouvelle demande / New application\t\t\tM-5096 10-02-75\t23985-VM-D-l BURGE BROS.TRANSFER & STORAGE LIMITED Nouvelle demande / New application\t7333\t05-10-74\tM-3217 10-02-75\t169-V-D-l BIRD'S TRANSFER LIMITED Mise en cause P.J.INDUSTRIES LIMITED FREDERICK DAVIES ALLAN SEW ELL DAVID J.MACLEAN\t8046\t26-10-74\tM-3487 \tRequéra nts-vendeurs A pplicant-rendors\t\t\t \t\t\t\t \tDOUGLAS ALLAN ARMSTRONG\t\t\t \tPAULINE DUPLESSIS-ARMSTRONG\t\t\t \tLOUISE BAILLARGEON\t\t\t \tRequérants- .cquéreurs\t\t\t \tA j.plicanl-pu rchasers\t\t\t 10-02-75\t23990-V-D-i\t7637\t12-10-74\tM-3288 \tRENE BOUCHER\t\t\t \tVoi .ui i;r-remorqueur\t\t\t \tHaulaway operator\t\t\t \tNouvelle demande / New application\t\t\t \tH,G.SNYDER TRUCKING INC.\t\t\t \tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t \tDroit additionnel / Additional right\t\t\t 11-02-75\t4120-V-D-2-TF\t9164\t07-12-74\tM-4155 \tDIXON VAN LINES (MONTREAL)\t\t\t \tLIMITED\t\t\t \tModification de tarif\t\t\t \tTariff modification\t\t\t 11-02-75\t24049-V-D-l\t9152\t07-12-74\tM-4075 \tJAMES VAL DEMAINE\t\t\t \tVoiturier-remorqueur\t\t\t \tHaulaway operator\t\t\t \tKINGSWAY FREIGHT LINES LTD.\t\t\t \tVoiturier-roulier / Carrier\t\t\t \tNouvelle demande / New application\t\t\t 11-02-75\t12972-V-D-l-TF\t8454\t09-11-74\tM-3597 \tA & F BAILLARGEON EXPRESS\t\t\t \tOTTAWA LTD.\t\t\t \tModification de tarif\t\t\t 11-02-75\tTariff modification\t\t\t \t14176-V-D-2-TF\t8455\t09-11-74\tM-3599 \tALLIED CARTAGE & WARE-\t\t\t \tHOUSES INC.\t\t\t \tModification de tarif\t\t\t \tTariff modification\t\t\t Décisions MCS-1007-TF MCS-100S-TF MCS-1011-TF MCS-1012 MCS-1013 MCS-1014 MCS-1015 MCS-1019 MCR-1593 MCS-1021 MCS-1022 MCS- 1023-TF Accordée / Granted Accordée / Granted Désistement Withdrawal Désistement H'tindrauiai Accordée/ Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granted Accordée / Granled GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1075.10T année.n° S 1783 \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants\t\t\tCause\t No\tDate\tApplicants\tpage\tdate\tCase\tDécisions MCS-1024-\t11-02-75\t1256-V-D-2-TF\t8685\t16-11-74\tM-3733\tAccordée / Granted TF\t\tA & F BAILLARGEON EXPRESS\t\t\t\t \t\tINC.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t MCS-1025\t11-02-75\t19614-V-D-3\t9158\t30-12-74\tM-4103\tAccordée / Granted \t\tREFRIGERATED TRANSPORT CO.\t\t\t\t \t\tINC.\t\t\t\t \t\tRequérant / Applicant\t\t\t\t \t\tFLORIDA REFRIGERATED\t\t\t\t \t\tSERVICE INC.\t\t\t\t \t\tRequérant-conjoint / Joint applicant\t\t\t\t \t\tTransfert et fusion de permis\t\t\t\t \t\tTransfer and amalgamation of transport\t\t\t\t \t\tpermit\t\t\t\t MCS-1016\t11-02-75\t23602-V-D-2\t8994\t30-11-74\tM-3826\tAccordée / Granted \t\tTHOMAS SCOTT & SONS\t\t\t\t \t\tLIMITED\t\t\t\t \t\tModification de clause\t\t\t\t \t\tClatise modification\t\t\t\t MCS-1018\t11-02-75\t20266-V-D-2\t8459\t09-11-74\tM-3621\tAccordée/ Granted \t\tCANADIAN MACHINERY MOVERS\t\t\t\t \t\tLTD.\t\t\t\t \t\tDroit additionnel / Additional right\t\t\t\t MCV-4174\t07-02-75\tM-500768-D-2\t4976\t05-08-74\tM-2360\tAccordée / Granted \t\tJOSEPH DUBEAU\t\t\t\t \t\tRequérant-vendeur / Applicant-vendor\t\t\t\t \t\tM-504490-D-3\t\t\t\t \t\tERNEST TOUPIN\t\t\t\t \t\tRequérant-acquéreur\t\t\t\t \t\tApplicant-purchaser\t\t\t\t \t\tTransfert d'attestation\t\t\t\t \t\tTransfer of certificate\t\t\t\t MCV-4202\t10-02-75\tM-501993-D-1 PIERRE GOHIER Transfert d'attestation Transfer of certificate\t4122\t14-06-74\tM-2016\tAccordée f Granted MCV-4203\t10-02-76\t505163-D-3 J.A.VERRET Demande de permis Application for permit\t\t\tM-5535\tDésistement Withdrawal MCV-4204\t10-02-75\tM-505163-D-2 J.A.VERRET Demande de permis Application for permit\t\t\tM-5534\tDésistement Withdrawal MCV-4206\t10-02-76\tM-504374-D-001 ANDRE VATJDRY Demande de permis application for permit\t\t\tM-6532\tDésistement Withdrawal MCV-4207\t11-02-75\tM-504824-D-1 VALBER TRANSPORT ENRG.Demande de permis Application for permit\t\t\tM-5531\tDésistement Ifilndrau-af MCV-4209\t12-02-75\tM-505654-D-001 ARMAND VIGNEAULT Demande de permis Application for permit\t\t\tM-5530\tDésistement Withdrawal MCV-4208\tU-02-75\tM-504824-D-1\t\t\tM-5531\tDésistement \t\tVALBER TRANSPORT ENRG.Demande de permis Application for permit\t\t\t\tWttndraieai ML-630\t06-02-75\t1027-DYV-D-l\t8051\t26-10-74\tM-3502\tAccordée / Granted \t\tPANORAMA LEASING INC.Mise en cause ALAIN TREMBLAY DONALD TREMBLAY ADRIEN R.PAQUETTE Requérants-vendeurs Applicant-vendors\t\t\t\t 1784 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE.February 22.1975.Vol.107, No./I \t\t\tG.O.Q.\t\t\t \t\tRequérants Applicants\t\t\tCause\t No\tDate\t\tpage\tdate\tCase\tDécisions \t\tPAUL GAGNON\t\t\t\t \t\tFERNANDE GAGNON\t\t\t\t \t\tJACQUES BOLDUC\t\t\t\t \t\tRequérants-acquéreurs\t\t\t\t \t\tApplicant-purçhasera Transfert d'actions / Transfer of shares\t\t\t\t \t\t\t\t\t\tAccordée 1 Granted ML-53S\t11-02-76\t592-DYV-D-l\t8680\t16-11-74\tM-3702\t \t\tMcQUILLEN LEASING REG'D.Mise en cause GORDON MATHIEW McQUILLEN Requérant-vendeur / Applicant-vendor RONALD A.SCOBIE Requérant-acquéreur Applicant-purchaser\t\t\t\t \t\tTransfert de permis / Transfer of permit\t\t\t\tAccordée / Granted ML-539\t11-02-75\t1068-DYV-D-l LOCATION FRONTENAC INC.Changement d'adresse\t8994\t30-11-74\tM-3830\t \t\tChange of business place\t\t\t\tAccordée / Granted ML-541\t11-02-75\t1930-V-D-9 PROVOST CARTAGE INC.Modification de permis\t8458\t09-11-74\tM-3618\t \t\tModification of permit 546-DYV-D-l\t\t\t\t ML-542\t11-02-75\t\t8457\t09-11-74\tM-3613\tAccordée / Granted \t\tGELCO CORPORATION OF\t\t\t\t \t\tCANADA LTD.\t\t\t\t \t\tChangement d'adresse\t\t\t\t \t\tChange of business place\t\t\t\t ML-544-\t13-02-75\t838-DY-D-2-TF\t9313\t14-12-74\tM-4182\tAccordée / Granted TF\t\tAUTO HIRE (CANADA) LTD.Modification de tarif Tariff modification\t\t\t\t PERMIS SPÉCIAUX / SPECIAL PERMITS No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.Nom du requérant Name of Applicanl Période de validité Period of validity MS-1272 24126-V-S-l MRS-0861 LES INDUSTRIES AVICOLES DE BEDFORD LTEE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal n Le Jour », les 21, 22, 23 novembre 1974.Accordée.MS-1273 24139-V-S-l MRS-0867 REAL MILLETTE Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Jour » les 21, 22, 23 novembre 1974.Accordée.MS-1274 24123-V-S-l MRS-0864 MIRAGE ST-HYACINTHE INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Jour ».les 21, 22, 23 novembre 1974.Accordée.Du 3 février 1975 au 2 février 1976 ou décision finale./ From February S, 1975 to February 2, 1976 or final decision.Particulars of application and derision : Application published in the \"Le Jour\" newspaper on November 21, 22, 23, 1974.Granted.Du 3 février 1975 au 2 février 1976 ou décision finale./ From February S, 1976 to February S.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on November 21, 22, 23, 1974.Granted.Du 3 février 1975 au 2 février 1976 ou décision finale./ From February S, 1975 to February 2, 1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on November 21, 22, 23, 1974.Granted. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 17S5 No du répertoire chronologique Chronological Repertory No.MS-1275 Nom du requérant Name of Applicant 24141-V-S-l MRS-0869 MIRAGE DRUMMOND INC.Période de validité Period of validity Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal ¦ Le Jour » les 21, 22, 23 novembre 1974.Accordée.Du 3 février 1975 au 2 février 1976 ou décision finale./ From February S, 1976 to February 2.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on November 21, 22, 23, 1974.Granted.MS-1276 24142-V-S-l LE MAGASIN DES AVICULTEURS INC.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Jour » les 21, 22, 23 novembre 1974.Accordée.Du 3 février 1975 au 2 février 1976 ou décision finale./ From February S.1976 to February 2.1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on November 21, 22.23.1974.Granted.MS-1277 24140-V-S-l LA CHAINE COOPERATIVE DU SAGUENAY Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Jour » les 21, 22, 23 novembre 1974.Accordée.MS-1278 24138-V-S-l LES POUSSINS HONFLEUR ENRG.Détails de la demande et de la décision: Demande parue dans le journal « Le Jour » les 21, 22, 23 novembre 1974.Accordée.MS-1279-TF 2594-A-S-l-TF METROPOLITAIN SUD (1967) INC.Détails de la demande et de la décision: Demande de modification de tarifs en vertu de l'article 2.71 du règlement No 2 qui a parue dans » Le Devoir n les 13, 14, 15 janvier 1975.Accordée.Du 3 février 1975 au 2 février 1976 ou décision finale.I From February S.1976 to February 2, 1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on November 21, 22, 23, 1974.Granted.Du 3 février 1975 au 2 février 1976 ou décision finale./ From February 3, 1976 to February 2, 1976 or final decision.Particulars of application and decision: Application published in the \"Le Jour\" newspaper on November 21.22, 23, 1974.Granted.A partir du fi février 1975./ From February 6.1976.Particulars of application and decision: Application for modification of tariff in virtue of section 2.71 of regulation No.2, that was published in \"Le Devoir\" January 13, 14, 15, 1975.Granted.MS-1280-TF 16023-V-S-l-TF HOWELL FORWARDING QUEBEC LIMITED Détails de la demande et de la décision: Modification de tarif en vertu de l'article 2.64 du règlement No 2.Déclare qu'elle ne peut statuer sur la présente requête en vertu de l'article 2.64 du règlement No 2.Réfère le dossier à l'administrateur pour que la requête suive la procédure régulière.MS-1281 14416-V-S-7 MRS-0727 PIETTE TRANSPORT INC.Détails de la demande et de la décision : Demande parue dans le journal « Montréal-Matin » les 26, 27, 28 décembre 1974.Rejetée.MS-1282 M-502304-A-1 MRS-0836 ANDRE LAFLAMME Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1283 M-502412 MRS-0837 ROLLAND MARTEL Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.Particulars of application and decision : Tariff modification in virtue of section 2.64 of regulation No.2.Declares that it cannot rule on the present application in virtue of section 2.64 of regulation No.2.Refers the file to the administrator so that the application may follow the regular procedure.Particulars of application and decision: Application published in the \"Montréal-Matin\" newspaper on December 26, 27, 28, 1974.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected. 1786 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.February 7.975, Vol.707, No.S No du répertoire\t\t chronologique\tNom du requérant\tPériode de validité Chronological\tName of Applicant\tPeriod of validity Repertory No.\t\t MS-1284\tM-5U2467 MRS-0838\t \tLAURENT LEVESQUE\t Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1285 M-504050-A-1 MRS-1285 I ROBERT MILLER Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1286 M-503976 MRS-0840 AIME POISSANT Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1287 M-505447-A-1 MRS-0841 KANIEL LE HESRAN Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1288 M-500807-A-2 MRS-0842 JEAN-MARIE ROY Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1289 M-500807-A-1 MRS-0843 JEAN-MARIE ROY Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1290 M-500990-A-1 MRS-0844 ROCK HEBERT Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1291 M-500975-A-1 MPS-0845 WALTER KEMP Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrae.Rejetée.MS-1292 M-503685-A-1 MRS-0846 JEAN-JACQUES BOISVERT Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1293 M-503685-A-2 MRS-0847 JEAN-JACQUES BOISVERT Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1294 M-501317-A-2 MRS-0848 BLAIS & LANGLOIS INC.Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision : Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking Rejected. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.>> février 1975, 107' année, n\" 8 1787 No du répertoire\t\t chronologique\tNom du requérant\tPériode de validité Chronological\tName of Applicant\tPeriod of validity Repertory No.\t\t MS-1295\tM-501317-A-1 MRS-0849\t \tBLAIS & LANGLOIS INC.\t Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage eu vrac.Rejetée.MS-1290 M-502931-A-1 MRS-0850 ROLLAND VILLEMAIRE Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1297 M-502703-A-1 MRS-0851 BERNARD MESSIER Détails de La demande et de la décision : Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1298 M-502702-A-1 MRS-0852 GAETAN BENOIT Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1299 M-502487-A-] MRS-0853 JEAN-MARC MILLETTE Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1300 M-502487-A-2 MRS-0854 JEAN-MARC MILLETTE Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1301 M-502449-A-1 MRS-0855 JEAN-LOUIS MICHON Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1302 M-503669-A-1 MRS-0857 ANDRE DUSSAULT Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1303 M-501769-A-1 MRS-0858 SERGE THIBERT Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1304 M-501788-A-1 MRS-0859 GEORGES MAILLOUX Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1305 M-500599-A-1 MRS-0835 JEAN GUIMOND Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.Particulars of application and decision: Applicaticn for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision : Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision : Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision : Application for additional permit for bulk trucking.Rejected. 17Î QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE, February 22.1975, Vol.107, No.8 No du répertoire\t\t chronologique\tNom du requérant\tPériode de validité Chronological\tName of Applicant\tPeriod of validity Repertory No.\t\t MS-1306\tM-503408-A-1 MRS-0834\t \tLUCIEN PRIM EAU\t Details de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1307 M-503122-A-1 MRS-0833 JACQUES TARTE Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1308 M-503108-A-1 MRS-0832 FRANÇOIS OSTIGUY Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1309 M-5031I7-A-1 MRS-0831 BERNARD TARTE Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1310 M -500598-A-1 M RS-0830 JEAN-LOUIS RIENDEAl' Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1311 M-501330-A-1 MRS-0829 ALAIN MICHON Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1312 M-503058-A-1 MRS-0828 ISRAEL LEGAIT.T Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1313 M-503094-A-I MRS-0827 MICHEL TARTE Détails de la demande et de la décision : Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.MS-1314 M-502773-A-1 MRS-0828 JEAN-GUY ALARIE Détails de la demande et de la décision: Demande de permis additif pour le camionnage en vrac.Rejetée.Particulars of application and decision: Application for additional permit for hulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for hulk trucking.Rejected.Particulars of application and decision: Application for additional permit for bulk trucking.Rejected.60018-0 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.février 1975.107' année, n° 8 1789 Régie de l'électricité et du gaz Electricity and Gas Board GAZ METROPOLITAIN INC.Avis public est donné par les présentes que « GAZ METROPOLITAIN.INC.» a demandé à la Régie de l'électricité et du gaz d'autoriser l'émission, la mise en circulation et la vente à Northern and Central Gas Corporation Limited de SI 2.000.000 d'obligations première hypothèque portant intérêt de 11-J4% par année, échéant le 1er mars 1995 et payables en devises canadiennes.Le produit net de l'émission doit servir au remboursement d'emprunts dus à Northern and Central Gas Corporation Limited et pour les dépenses futures en immobilisations.Toute personne désirant obtenir copie de la demande ou ayant des représentations à faire au sujet de ladite demande, devra s'adresser à la Régie de l'électricité et du gaz, 2100.rue Drummond, Montréal 107.dans les quinze (15) jours de la date de publication des présentes.Montréal, ce 19e jour de février 1975.Gaz métropolitain, inc., Le secrétaire, C.Antaki.60101-o 2632-75 Office des professions du Québec Avis de radiation permanente L'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 176 du Code des professions, (L.Q., 1973, ch.43), que M.Réal Caron, ayant exercé sa profession à Senneterre, Abitibi, a été radié d'une façon permanente du tableau de la Chambre des notaires du Québec en vertu d'une décision définitive du comité de discipline de cette corporation rendue le 11 novembre 1974.Le secrétaire de l'Office des professions du Québec, 60092-o Edouard Champoux.Avis de radiation permanente et de révocation de permis L'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 176 du Code des professions, (L.Q., 1973, ch.43), que M.Gabriel Coallier, résidant au 6367, boulevard Pie IX, Montréal, a été radié d'une façon permanente du tableau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et a vu son permis révoqué en vertu d'une décision définitive du comité dc discipline de cette corporation rendue le 1er octobre 1974.Le secrétaire de l'Office des professions du Québec.60092-o Edouard Champoux.GAZ METROPOLITAIN INC.Public notice is hereby given that application has been made to the Electricity and Gas Board by \"GAZ METROPOLITAIN.INC.\" for authorization to issue, put into circulation and sell to Northern and Central Gas Corporation Limited $12.000.000 First Mortgage Bonds bearing interest, at the rate of \\\\-x/\\% per annum payable in Canadian funds maturing on March 1, 1995.The net proceeds of the issue will be used to repay loans due to Northern and Central Gas Corporation Limited and to finance capital expenditures.Any person desiring to obtain a copy of the application or desiring to make representations in respect thereof should communicate with the Electricity and Gas Board.2100 Drummond Street, Montreal 107.Québec, within fifteen (15) days of the publication of this notice.Montreal, this 19th day of February.1975.Gaz Métropolitain, inc., C.Antaki, Secretary.60101-o 2632-75 Québec Professions Board Notice of permanent striking off The Québec Professions Board hereby gives notice, in conformity with section 176 of the Professional Code (S.Q., 1973.Chapter 43), that Mr.Real Caron, who has practised his profession in Senneterre, Abitibi, has been permanently struck off the roll of the Board of Notaries of Québec, pursuant to a final decision of the Committee on Discipline of said Corporation rendered on November 11,1974.Edouard Champoux, Secretary of the 60092 Québec Professions Board.Notice of permanent striking off and of revocation of permit The Québec Professions Board hereby gives notice, in conformity with section 176 of the Professional Code (S.Q, 1973, Chapter 43), that Mr.Gabriel Coallier, residing at 6367 Pie IX Boulevard, Montreal, has been permanently struck off the roll of the Professional Corporation of Physicians of Québec and that his permit has been revoked pursuant to a final decision of the Committee on Discipline of said Corporation rendered on October 1, 1974.Edouard Champoux, Secretary of the 60092 Québec Professions Board. 1700 QUÉBEC OFFICIAI.GAZETTE.February 197$.Vol.107.Xo.8 Avis de radiation permanente L'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 176 du Code des professions.(L.Q., 1973.eh.43), que Patrick Vallée, ayant exercé sa profession à ville des Laurentides, a été radié d'une façon permanente du tableau du Barreau du Québec en vertu d'une décision définitive du comité île discipline dc cette corporation rendue le 27 novembre 1974.Le secrétaire île l'Office tien professions ilu Québec.60092-o Rdocard Champovx.Notice of permanent striking off The Québec Professions Hoard hereby fives notice, in conformitv with section 176 of the Professional Code (S.Q.1973.Chapter 43).that Patrick Vallée, who has practised his profession in Ville des Lauren-tides, has been permanently struck off the roll of the Bar of the Province of Québec, pursuant to a final decision of the Committee on Discipline of said Corporation, rendeiedon November 27.1974.Edouard Chamfoi'x, Secretary of Ihe 60092 Québec Professions Hoard.Compagnies étrangères Permis Extra-Provincial Companies License BOW VALLEY INDUSTRY SUPPLIES LTD.Avis est donné qu'en vertu de la Loi îles compagnies étrangères, la compagnie « BOW VALLEY' INDUSTRY SUPPLIES LTD.a été autorisée :i faire affaires dans la province.L'agent principal, aux fins de recevoir les assignations dans les procédures contre ladite compagnie, est M.P.André (iervais, a/s MM.Doheny, Mackenzie, (irivakes.(iervais & Lemoyne.1203, Édifice IBM, ,\">.Place Ville-Marie, Montréal.Le bureau principal tie la compagnie dans la province est établi à 1203.Edifice IBM, 5.Place Ville-Marie.Montréal, district judiciaire de Montréal.Le sous-niinislrc des institutions financières.compagnies et coopérai ires.Ai.nF.ttT Jessop.60016-e.1360-0663 BOW VALLEY INDUSTRY SUPPLIES LTD.Notice is given that pursuant to the Extra-Provincial Companies Act.\"BOW VALLEY INDUSTRY SUPPLIES LTD.\" has been authorized to carry on business ill the Province.The chief agent for the purpose of receiving service in proceedings against the said Company is Mr.P.André (Iervais, c/o Messrs.Doheny, Mackenzie, (irivakes.(iervais & Lemoyne, 1203 IBM Building, 5 Place Ville-Marie, Montreal.The principal office of the Company in the Province is located at 1203 IBM Building, 5 Place Ville-Marie, Montreal, Judicial District of Montreal.Albert Jessop, Deputy Minister of Financial Institutions, Companies and Cooperatives.60016 1360-0663 Ventes par Shérifs Sheriff's Sales AVIS PUBLIC, est par la présente donné que les TERRES et HERITAGES sous-mentionnés ont été saisis et seront vendus aux temps et lieux respectifs mentionnés plus bas.PUBLIC NOTICE, is hereby given that the undermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places mentioned below.MONTREAL MONTREAL Fieri Facias de Terris Canada\u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal LES FIDUCIAIRES DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL LIMITEE, corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 1253.McGill College, suite 600, à Montréal, district judiciaire de Montréal, demanderesse, vs FRANÇOIS CONSTRUCTION LIMITEE.cor- No 05-013 127-74 { Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( \\/fDNTREAL CITY AND 27-74.< J-Vl DISTRICT TRUSTEES ' LIMITED, a corporation legally incorporated, having its principal place of business at 1253 McGill College.Suite 600.in Montreal.Judicial District of Montreal, plaintiff.M FRANÇOIS CONSTRUCTION LIMITEE, a corporation legallv incor- No.05-013 127-7 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 février 1975.107' année, n° 8 1791 poration légalement constituée ayant sa place d'affaires au 38, Desmarchais app.S, à Longueuil, district judiciaire de Montréal, défenderesse, Dame RÉJEANNE TREMBLAY, résidante et domiciliée au 2830.Bel-court, Longueuil, district judiciaire de Montréal.JACQUES COOKE, résidant et domicilié au 150.boulevard des Ormeaux.Longueuil, district judiciaire de Montréal.ANDRÉ STE-MARIE.résidant et domicilié à St-Léonard, district judiciaire de Montréal, co-défendeurs.LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Cliamhly.de la cité de Longueuil.district judiciaire de Montréal, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur la rue Desmarchais, dans la ville de Longueuil connu et désigné sous le lot numéro trois cent quarante-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre-vingt-treize (93-348) aux plan et livre de renvoi officiels dc la paroisse de St-Antoine-de-Longneuil, mesurant cent vingt-neuf (129') pieds dans sa ligne nord-est, deux cent huit pieds et huit dixièmes de pied (208.8') dans sa ligne sud-est, cinq pieds (5') dans une ligne sud-ouest, cent vingt-quatre pieds et vingt-huit centièmes de pied (124.28\") dans une autre ligne sud-ouest, soixante et un pieds et soixante-quatorze centièmes de pied (61.74') dans une ligne nord-ouest, cent cinq pieds et quarante-huit centièmes de pied (105.48') le long d'une courbe de cinquante et un pieds (51') de rayon dans une autre ligne nord-ouest, cinquante pieds et vingt et un centièmes de pied (50.21') dans une autre ligne nord-ouest, contenant en superficie vingt-quatre mille sept cent soixante-cinq pieds carrés (24.765 pi.ca.) borné comme suit: au nord-est par le lot numéro 93-349.au sud-est par les lots 93-84, 93-85, et 93-86, au sud-ouest, par les lots 93-87 et 93-347 et au nord-ouest, par les lots 93-347, 93-296 et 93-349.Avec une maison dessus érigée et portant le numéro civique 38, rue Desmarchais.à Longueuil.Ainsi que le tout se trouve présentement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et plus spécialement une servitude pour fins de non exploitation de super-marchés, d'épicerie, etc.créée en faveur de Steinberg's Limited, aux termes d'une acte de vente reçu devant le notaire soussigné en date de ce jour, dont copie sera enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Chambly et au bureau d'enregistrement de la division de Montréal, en même temps que les présentes, et également une servitude de droit de passage (fonds dominant) sur le lot 93 partie 349 dudit cadastre, créée aux termes d'un acte de servitude reçu devant le notaire soussigné le 29 novembre 1973, sous le numéro 501 de ses minutes, dont copie sera enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Chambly, en même temps que les présentes.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Chamblv, 201, Place Charles-Lemoyne.Édifice Montval.à Longueuil.P.Q., le VINGT-CINQUIEME jour dc MARS 1975, à DIX heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure.Paul St-Martix.Montreal, le 12 février 1975.60085-o porated, having its place of business at 38 Desmarchais, Apt.8.in Longueuil.Judicial District of Montreal, defendant, Mrs.RÉJEANNE TREMBLAY, residing and domiciled at 2830 Belcourt.Longueuil, Judicial District of Montreal, JACQUES COOKE, residing and domiciled at 150 Des Ormeaux Boulevard.Longueuil, Judicial District of Montreal, ANDRÉ STE-MARLE, residing and domiciled in Saint-Léonard, Judicial District of Montreal, joint defendants, THE REGISTRAR for the Chambly Registration Division, of the City of Longueuil, Judicial District of Montreal, mis en cause.\"An emplacement fronting on Desmarchais Street, in the City of Longueuil.known and described as lot number three hundred forty-eight of the official subdivision of original lot number ninety-three (93-348) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Saint-Antoine-de-Longueuil.measuring one hundred twenty-nine (129') feet on its northeast line, two hundred eight and eight tenths feet (208.8') on its southeast line, five feet (5') on its southwest line, one hundred twenty-four and twenty-eight hundredths feet (124.28') on another southwest line, sixty-one and seventy-four hundredths feet (61.74') on its northwest line, one hundred five and forty-eight hundredths feet (105.48') along a curve having a fifty-one-foot (51') radius on another northwest line, fifty and twenty-one hundredths feet (50.21') on another northwest line, covering an area of twenty-four thousand seven hundred sixty-five square feet (24,765 sq.ft) bounded as follows: on the northeast by lot number 93-349, on the southeast by lots 93-84, 93-85 and 93-86, on the southwest by lots 93-87 and 93-347 and on the northwest by lots 93-347, 93-296 and 93.349.With a house erected thereon bearing civic number 38 on Desmarchais Street, in Longueuil.As the whole presently subsists with all active and passive, apparent or non-apparent servitudes attaching to said immoveable, and more particularly a servitude of non-operation of super-markets, groceries, etc., created for the benefit of Steinberg's Limited, under the terms of a deed of sale executed before the Undersigned notary, dated this day, a copy of which deed will be registered with these presents at the Chambly Registration Division Office and in the Montreal Registration Division, and subject also to a servitude of right-of-way (dominant tenement) on lot 93 part 349 of said cadastre, created under the terms of a deed of servitude executed hefore the undersigned notary, on November 29.1973, under number 501 of his minutes, a copy of which deed will be registered with these presents at the Chambly Registration Division Office.\" To be sold at the County of Chambly Registry Office, 201 Place Charles-Lemovne, Montval Building, in Longueuil.P.Q., on the TWENTY-FIFTH day of MARCH 1975, at TEN o'clock in the forenoon.Sheriff's Office.Paul St-Martin, Superior Court, Assistant Sheriff.Montreal.February 12, 1975.60085 1792 QUÉBEC OFFICIAL GAZETTE, February 22, 1975, Vol.107, No.8 Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal l FIDUCIAIRES DE LA CITÉ No 05-013128-74.< J- ET DU DISTRICT DE v MONTRÉAL LIMITEE, corporation légalement constituée ayant sa principale place d'affaires au 1253, McGill College, suite 600, à Montréal, district judiciaire dc Montréal, demanderesse; M FRANÇOIS CONSTRUCTION LIMITÉE, corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 150, boulevard des Ormeaux, à Longueuil, district judiciaire de Montréal, défendeur, JACQUES COOKE, résidant et domicilié au 150, boulevard Des Ormeaux, à Longueuil, district judiciaire de Montréal, DAME REJEANNE TREMBLAY, résidante et domiciliée au 2830, Belcourt, à Longueuil, district judiciaire de Montréal, ANDRÉ STE-MARIE, résidant et domicilié à St-Léonard, district judiciaire de Montréal, co-défen-deurs, LE REGISTRATEUR de la division d'enregistrement de Chambly, de la cité de Longueuil, district judiciaire de Montréal, mis en cause.« Un emplacement ayant front sur la rue Desmarchais, dans la ville de Longueuil, connu et désigné sous le lot numéro trois cent quarante-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro quatre-vingt-treize (93-349) aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de St-Antoine-de-Longueuil, mesurant deux cent soixante-quinze pieds (275') dans la ligne nord-est, 60 pieds dans une ligne sud-est, cent vingt-neuf pieds (129') dans une ligne sud-ouest, cinquante pieds et vingt et un centièmes de pied (50.21') dans une autre ligne sud-est, vingt-sept pieds et trente-six centièmes de pied (27.36') le long d'une courbe de cinquante et un pied (51') de rayon dans une autre ligne sud-ouest, cent vingt pieds (120') dans une autre ligne sud-ouest cent trois pieds (103') dans sa ligne nord-ouest, contenant en superficie vingt-deux mille huit cent trente-huit pieds carrés (22,838 pi.ca.) borné comme suit: au nord-est par les lots 93-297, 93-298, 93-299, au sud-est par les lots 93-84 et 93-248, au sud-ouest, par les lots 93-348 et 93-296 et au nord-ouest par le lot 93-91A.Avec une maison ci-dessus y érigée et portant le numéro cinvique 62, rue Desmarchais, en la ville de Longueuil.Ainsi que le tout se trouve présentement avec les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et plus spécialement une servitude pour fins de non exploitation de supermarchés, d'épicerie, etc., créée en faveur de Steinberg's Limited, aux termes d'un acte de vente reçu devant le notaire soussigné, en date de ce jour, dont copie sera enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Chambly, et au bureau d'enregistrement de la division de Montréal, en même temps que les présentes, et également sujet à une servitude dc droit de passage en faveur du lot numéro 93-348 du susdit cadastre, créée aux termes d'un acte dc servitude reçu devant le notaire soussigné, le 29 novembre 1973, sous le numéro 501 de ses minutes et dont copie sera enregistrée au Fieri Fadas de Terris Canada \u2014 Province of Québec Superior Court \u2014 District of Montreal ( -V/fONTREAL CITY AND No.05-013128-74X J-vl DISTRICT TRUSTEES v LIMITED, a corporation legally incorporated having its principal place of business at 1253 McGill College, Suite 600, in Montreal, Judicial District of Montreal, plaintiff; vs FRANÇOIS CONSTRUCTION LIMITEE, a corporation legally incorporated having its place of business at 150 Des Ormeaux Boulevard, in Longueuil, Judicial District of Montreal, defendant, JACQUES COOKE, residing and domiciled at 150 Des Ormeaux Boulevard, in Longueuil, Judicial District of Montreal.MRS.RÉJEANNE TREMBLAY, residing and domiciled at 2830 Belcourt, in Longueuil.Judicial District of Montreal.ANDRÉ STE-MARIE, residing and domiciled in Saint-Léonard, Judicial District of Montreal, joint defendants.THE REGISTRAR for the Chambly Registration Division, of the City of Longueuil, Judicial District of Montreal, mis en cause.\"An emplacement fronting on Desmarchais Street, in the City of Longueuil, known and described as number three hundred forty-nine of the official subdivision of original lot number ninety-three (93-349) on the official plan and in the book of reference for the Parish of Saint-Antoine-de-Longueuil, measuring two hundred seventy-five feet (275') on its northeast line, 60 feet on a southeast line, one hundred twenty-nine feet (129') on a southwest line, fifty and twenty-one hundredths feet (50.21') on another southeast line, twenty-seven and thirty-six hundredths feet (27.36') along a curve having a radius of fifty-one feet (51') on another southwest line, one hundred twenty feet on another southwest line (120'), one hundred and three feet (103') on its northwest line, covering an area of twenty-two thousand eight hundred thirty-eight square feet (22,838 sq.ft.), bounded as follows: on the northeast by lots 93-297, 93-298, 93-299, on the southeast bv lots 93-84 and 93-248, on the southwest by lots 93-348 and 93-296 and on the northwest by lot 93-91 A.With a house erected thereon and bearing civic number 62 Desmarchais Street, in the City of Longueuil.As the whole presently subsists with the active and passive, apparent and non-apparent servitudes attaching to said immoveable, particularly a servitude of non-operation of supermarkets, grocery business, etc., established for the benefit of Steinberg's Limited, under the terms of a deed of sale executed before the undersigned notary, dated this day, a copy of which deed will be registered with these presents in the Chambly Division Registry Office and in the Montreal Division Registry Office, and subject also to a servitude of right-of-way for the benefit of lot number 93-348 on the aforesaid cadastre, established under the terms of a deed of servitude executed before the undersigned notary on November 29, 1973, under number 501 of his minutes, a copy of which deed will be registered with GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 février 1975, 107' année, n° 8 1793 bureau d'enregistrement de la Division de Chambly, en même temps que les présentes.» Pour être vendu au bureau d'enregistrement du comté de Chambly, 201, Place Charles-Lemoyne, Édifice Montval, à Longueuil, P.Q., le VINGT-CINQUIÈME jour de MARS 1975, à ONZE heures de l'avant-midi.Bureau du shérif.Le shérif adjoint.Cour Supérieure, Paul St-Martin.Montréal, le 12 février 1975.60084-o Fieri Facias de Terris Canada \u2014 Province de Québec Cour Supérieure \u2014 District de Montréal I CUN LIFE ASSURANCE COMPA-No 796 388.< es 1790 clhatei.i.k pi bi.ique.1680 Demandes à i.a Legislature 1677 i.kji i dation.Loi de la 1679 Ministère .1667 Office des professions m Québec 1789 Régie de i.'êi.ecthicitê et du gaz.1789 Renseignements sur les compagnies.1691 Services de santé et services sociaux 1684 Soumissions.1692 Ventes: Applications to Legislature.1677 Change ok Name Act.1672 Companies Act.Notices concerning the.1637-1683-1685-1796 Companies Information Act.1691 Cooperative Associations.1715 Department .1667 Electricity and Cas Hoakd.1789 Extra-Provincial Companies Act 1790 Health Services and Social Services 1684 Miscellaneous Notices .16X5 Public Curatohship, 16X0 Quep.ec Professions Hoard .1789 Quebec Transport Commission.1716 Sali - By Sheriffs 1790 For taxes.1710 Tenders.1692 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec Cité parlementaire, Québec G1R 4Y7 1*\tCanada Postes Post Canada J Poil*^riu.J Peu pa,* \tThird Troisième \tclass classe \tPermis No.107 \tQuébec Montréal 129, Que.Bibliothèque nationale Dépôt Légal 1700, St-Denia H2X 3K6 Dernier avis Réabonnement à la Gazette officielle du Québec Partie 1 (Avis juridiques) Janvier à décembre Partie 2 (Lois & Règlements) $20 $30.OFFICIELLE reçu le: Toiji%lâa;sb^g]gemen s actuellement en cours et non payés aj 28 février 1975 Bi»^Rt(^OTO8*M|ii»6enent annulés DU QUÉBEC JL Éditeur officiel du Québec 675 est, boul.Saint-Cyrille, Québec G1R 4Y7 "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.